Buscador CIF Logo

Actos BORME Aspro Ocio Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Aspro Ocio Sa

Actos BORME Aspro Ocio Sa - A79256871

Tenemos registrados 62 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Aspro Ocio Sa con CIF A79256871

馃敊 Perfil de Aspro Ocio Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Aspro Ocio Sa

18 de Diciembre de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 42689 , F 198, S 8, H M 12392, I/A 145 (11.12.23).

30 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: MARCOS ANDRES JESUS. Nombramientos. Apo.Sol.: SOTO MORENO-SANTAMARIA RICARDO.Apo.Manc.: EZQUERRA RUIZ MIGUEL;SOTO MORENO-SANTAMARIA RICARDO;ABRAHAM ALEMANY RAFAEL. Apo.Sol.: SOTOMORENO-SANTAMARIA RICARDO;ABRAHAM ALEMANY RAFAEL;HERRERA TORRALBO EMILIO. Datos registrales. T 42689 , F197, S 8, H M 12392, I/A 144 (23.03.23).

03 de Enero de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 42689 , F 196, S 8, H M 12392, I/A 143 (27.12.22).

29 de Agosto de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PERETO GARCIA MARIA-JOSE. Apo.Manc.: CANALS PASTOR BARTOLOME. Nombramientos.Apoderado: PERETO GARCIA MARIA-JOSE. Apo.Manc.: PERETO GARCIA MARIA-JOSE;CENI SERRAT IBAN;LOPEZ GUI脩ONALFONSO. Datos registrales. T 42689 , F 195, S 8, H M 12392, I/A 142 (22.08.22).

04 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: LARIOS BRUNA JORGE;VILLAESCUSA GARCIA-QUIJADA MARIA DE LOS ANGELES;GARDEGARCIA JAVIER;SORIANO LOPEZ DAVID. Datos registrales. T 33701 , F 199, S 8, H M 12392, I/A 141 (27.06.22).

16 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 33701 , F 199, S 8, H M 12392, I/A 140 ( 8.11.21).

22 de Marzo de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 33701 , F 199, S 8, H M 12392, I/A 139 (12.03.21).

24 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 33701 , F 199, S 8, H M 12392, I/A 138 (17.12.19).

28 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN. Apo.Manc.: GONZALEZ FERNANDEZ PINEDOJULIAN;RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS;GARCIA OVIEDO MARIA ANTONIA. Apoderado: GONZALEZ FERNANDEZ PINEDOJULIAN;LOBEJON GONZALEZ ADOLFO;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN;VILLAESCUSA GARCIA-QUIJADA MARIA DELOS ANGELES;RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN;ABRAHAM ALEMANYRAFAEL;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN;EZQUERRA RUIZ MIGUEL;LOPEZ GUI脩ON ALFONSO;LOPEZ GUI脩ONALFONSO;MONTIEL AMAYA ARACELI;AYGUAVIVA MATEO MARTA;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN. Apo.Manc.:GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN;INGLES PERNIA JORDI;MONTIEL AMAYA ARACELI;AYGUAVIVA MATEO MARTA.Datos registrales. T 33701 , F 198, S 8, H M 12392, I/A 137 (21.11.19).

23 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS;GONZALEZ FERNANDEZ-PINEDO JULIAN;LOPEZ SORIANODAVID.Presidente: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Secretario: GONZALEZ FERNANDEZ-PINEDO JULIAN. Cons.Del.Sol:SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Cons.Del.Man: GONZALEZ FERNANDEZ-PINEDO JULIAN;LOPEZ SORIANO DAVID.Vicepresid.: SORIANO LOPEZ DAVID. Nombramientos. Consejero: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS;SORIANO LOPEZDAVID;GARDE GARCIA JAVIER. Presidente: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Vicepresid.: SORIANO LOPEZ DAVID.Secretario: GARDE GARCIA JAVIER. Cons.Del.Sol: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Cons.Del.Man: SORIANO LOPEZDAVID;GARDE GARCIA JAVIER. Datos registrales. T 33701 , F 198, S 8, H M 12392, I/A 136 (16.10.19).

11 de Junio de 2019
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ SORIANO DAVID;LOPEZ SORIANO DAVID;CARRERA CORDOBA TERESA. Nombramientos.Apoderado: SORIANO LOPEZ DAVID;SORIANO LOPEZ DAVID;LARIOS BRUNA JORGE;VILLAESCUSA GARCIA-QUIJADA MARIADE LOS ANGELES. Datos registrales. T 33701 , F 197, S 8, H M 12392, I/A 135 ( 4.06.19).

01 de Abril de 2019
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS. Apo.Manc.: RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS;GARCIAOVIEDO MARIA ANTONIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA AZCARRAGA IZASKUN;GOMEZ SANCHEZ DAVID.Apo.Manc.: GARCIA OVIEDO MARIA ANTONIA. Datos registrales. T 33701 , F 196, S 8, H M 12392, I/A 134 (25.03.19).

05 de Marzo de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 33701 , F 196, S 8, H M 12392, I/A 133 (26.02.19).

04 de Septiembre de 2018
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 33701 , F 195, S 8, H M 12392, I/A 132 (28.08.18).

22 de Junio de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARCOS ANDRES JESUS. Nombramientos. Apoderado: MARCOS ANDRES JESUS;EZQUERRARUIZ MIGUEL;LARIOS BRUNA JORGE;ABRAHAM ALEMANY RAFAEL;VILLAESCUSA GARCIA-QUIJADA MARIA DE LOSANGELES. Datos registrales. T 33701 , F 194, S 8, H M 12392, I/A 131 (14.06.18).

25 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apoderado: AYGUAVIVA MATEO MARTA. Nombramientos. Apoderado: AYGUAVIVA MATEOMARTA;AYGUAVIVA MATEO MARTA;VILLAESCUSA GARCIA-QUIJADA MARIA DE LOS ANGELES;LARIOS BRUNA JORGE;VILAREDUARD CAROL. Datos registrales. T 33701 , F 193, S 8, H M 12392, I/A 130 (17.05.18).

27 de Marzo de 2018
Revocaciones. Apoderado: HERRERA TORRALBO EMILIO;HERRERA TORRALBO EMILIO. Apo.Sol.: FERNANDEZ IGLESIASGONZALO. Apo.Manc.: FERNANDEZ IGLESIAS GONZALO. Nombramientos. Vicepresid.: SORIANO LOPEZ DAVID. Apoderado:HERRERA TORRALBO EMILIO. Apo.Manc.: HERRERA TORRALBO EMILIO;ABRAHAM ALEMANY RAFAEL;EZQUERRA RUIZMIGUEL;LARIOS BRUNA JORGE;VILLAESCUSA GARCIA-QUIJADA MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 33701 , F192, S 8, H M 12392, I/A 129 (19.03.18).

20 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE RAMON-LACA COTORRUELO JESUS. Secretario: DE RAMON LACA COTORRUELO JESUS.Con.Delegado: DE RAMON LACA COTORRUELO JESUS. Consejero: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS;GONZALEZFERNANDEZ PINEDO JULIAN;SORIANO LOPEZ DAVID.Presidente: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Vicepresid.: SORIANOLOPEZ DAVID. Vicesecret.: GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN. Con.Delegado: SMITH MORRONDO JUANCARLOS;SORIANO LOPEZ DAVID. Nombramientos. Consejero: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS;GONZALEZ FERNANDEZ-PINEDO JULIAN;LOPEZ SORIANO DAVID.Presidente: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Secretario: GONZALEZ FERNANDEZ-PINEDO JULIAN. Cons.Del.Sol: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Cons.Del.Man: GONZALEZ FERNANDEZ-PINEDOJULIAN;LOPEZ SORIANO DAVID. Datos registrales. T 33701 , F 192, S 8, H M 12392, I/A 128 (12.02.18).

17 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apoderado: LOBEJON GONZALEZ ADOLFO;LOBEJON GONZALEZ ADOLFO. Nombramientos. Apo.Sol.: LARIOSBRUNA JORGE. Apo.Manc.: LARIOS BRUNA JORGE;LOPEZ SORIANO DAVID;VILLAESCUSA GARCIA-QUIJADA MARIA DE LOSANGELES. Datos registrales. T 33701 , F 190, S 8, H M 12392, I/A 127 ( 6.10.17).

29 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: AYGUAVIVA MATEO MARTA;ADKAROVITS JANOS ODIN BUGS;LOBEJON GONZALEZADOLFO;SORIANO LOPEZ DAVID. Datos registrales. T 33701 , F 190, S 8, H M 12392, I/A 126 (21.03.17).

24 de Marzo de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: CODINA ZUGASTI PEDRO. Apo.Manc.: CODINA ZUGASTI PEDRO. Apoderado: SANTIN GALLARDOJOSEP;FERRES TORRES ESTEBAN;FERRES TORRES ESTEBAN;INGLES PERNIA JORDI. Apo.Man.Soli: SOLER HERRANZARTURO. Apo.Manc.: INGLES PERNIA JORDI. Apoderado: TOMAS PEREZGIL AITANA-NATALIA;TOMAS PEREZGIL AITANA-NATALIA;INGLES PERNIA JORDI.Apo.Sol.: GARCIA AZCARRAGA IZASKUN. Apo.Manc.: GARCIA AZCARRAGA IZASKUN.Nombramientos. Apoderado: AYGUAVIVA MATEO MARTA. Datos registrales. T 33701 , F 189, S 8, H M 12392, I/A 125(15.03.17).

03 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apoderado: BALLESTER SAAVEDRA FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: GARDE GARCIA JAVIER.Datos registrales. T 33701 , F 189, S 8, H M 12392, I/A 124 (26.01.17).

10 de Noviembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: ERKOREKA ENDEMA脩O ERNESTO. Apo.Manc.: ERKOREKA ENDEMA脩O ERNESTO. Apoderado:GOMEZ DELGADO NURIA;DEL VALS CASILLAS FATIMA. Apo.Manc.: DEL VALS CASILLAS FATIMA;MARTIN PEREZ AVELINA.Apoderado: LARA ORIA RAMON. Datos registrales. T 33701 , F 188, S 8, H M 12392, I/A 123 (27.10.16).

24 de Octubre de 2016
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 33701 , F 188, S 8, H M 12392, I/A 122 (14.10.16).

06 de Mayo de 2016
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 121& EL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO,VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE LOPEZ SORIANO DAVID, SIENDO LO CORRECTO SORIANO LOPEZ DAVID.Datos registrales. T 33701 , F 187, S 8, H M 12392, I/A 121 (13.01.16).

21 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS;DE RAMON LACA COTORRUELO JESUS;BARRACHINAMORENO ANGEL. Presidente: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Vicepresid.: DE RAMON LACA COTORRUELO JESUS.Secretario: BARRACHINA MORENO ANGEL. Con.Delegado: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Nombramientos. Consejero:SMITH MORRONDO JUAN CARLOS;DE RAMON-LACA COTORRUELO JESUS;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN;LOPEZSORIANO DAVID. Presidente: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Vicepresid.: LOPEZ SORIANO DAVID. Secretario: DE RAMONLACA COTORRUELO JESUS. Vicesecret.: GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN. Con.Delegado: SMITH MORRONDO JUANCARLOS;DE RAMON LACA COTORRUELO JESUS;LOPEZ SORIANO DAVID. Datos registrales. T 33701 , F 187, S 8, H M 12392,I/A 121 (13.01.16).

19 de Octubre de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: INGLES PERNIA JORDI. Apo.Manc.: BANCELLS BOSCH JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli:PERETO GARCIA MARIA-JOSE. Apo.Manc.: MARCOS ANDRES JESUS;LOPEZ GUI脩ON ALFONSO;CANALS PASTORBARTOLOME. Datos registrales. T 30043 , F 123, S 8, H M 12392, I/A 120 ( 9.10.15).

24 de Septiembre de 2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30043 , F 123, S 8, H M 12392, I/A 119 (16.09.15).

24 de Junio de 2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30043 , F 123, S 8, H M 12392, I/A 118 (16.06.15).

18 de Marzo de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCOS ANDRES JESUS. Apo.Manc.: AYGUAVIVA MATEO MARTA;INGLES PERNIA JORDI.Datos registrales. T 30043 , F 122, S 8, H M 12392, I/A 117 ( 9.03.15).

12 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apoderado: MARCOS ANDRES JESUS. Datos registrales. T 30043 , F 121, S 8, H M 12392, I/A 116 ( 5.02.15).

27 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA AZCARRAGA IZASKUN. Apo.Manc.: GARCIA AZCARRAGA IZASKUN. Nombramientos.Apo.Sol.: GARCIA AZCARRAGA IZASKUN. Apo.Manc.: GARCIA AZCARRAGA IZASKUN;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDOJULIAN;INGLES PERNIA JORDI;MONTIEL AMAYA ARACELI;AYGUAVIVA MATEO MARTA. Datos registrales. T 30043 , F 121, S8, H M 12392, I/A 115 (20.03.14).

20 de Febrero de 2014
Revocaciones. Apoderado: MARCOS ANDRES JESUS. Nombramientos. Apoderado: TOMAS PEREZGIL AITANA-NATALIA;TOMAS PEREZGIL AITANA-NATALIA;ABRAHAM ALEMANY RAFAEL;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDOJULIAN;EZQUERRA RUIZ MIGUEL. Datos registrales. T 30043 , F 119, S 8, H M 12392, I/A 113 (12.02.14).

Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ GUI脩ON ALFONSO. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ GUI脩ON ALFONSO;LOPEZGUI脩ON ALFONSO;MONTIEL AMAYA ARACELI;AYGUAVIVA MATEO MARTA;INGLES PERNIA JORDI;GONZALEZ FERNANDEZPINEDO JULIAN. Datos registrales. T 30043 , F 120, S 8, H M 12392, I/A 114 (12.02.14).

24 de Diciembre de 2013
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30043 , F 119, S 8, H M 12392, I/A 112 (17.12.13).

04 de Julio de 2013
Segregaci贸n. Beneficiarios de la segregaci贸n: ASPRO PARKS SL. Datos registrales. T 30043 , F 117, S 8, H M 12392, I/A 111(26.06.13).

25 de Junio de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ IGLESIAS GONZALO. Apo.Manc.: FERNANDEZ IGLESIAS GONZALO;ABRAHAMALEMANY RAFAEL;CANALS PASTOR BARTOLOME. Datos registrales. T 30043 , F 116, S 8, H M 12392, I/A 110 (13.06.13).

14 de Junio de 2013
Revocaciones. Apoderado: ABRAHAM ALEMANY RAFAEL. Nombramientos. Apo.Sol.: ABRAHAM ALEMANY RAFAEL.Apo.Manc.: ABRAHAM ALEMANY RAFAEL;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN;EZQUERRA RUIZ MIGUEL;CANALSPASTOR BARTOLOME. Datos registrales. T 30043 , F 114, S 8, H M 12392, I/A 108 ( 6.06.13).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA AZCARRAGA IZASKUN. Apo.Manc.: GARCIA AZCARRAGA IZASKUN;GONZALEZFERNANDEZ PINEDO JULIAN;INGLES PERNIA JORDI;MONTIEL AMAYA ARACELI. Datos registrales. T 30043 , F 115, S 8, H M12392, I/A 109 ( 6.06.13).

02 de Abril de 2013
Nombramientos. Apoderado: HERRERA TORRALBO EMILIO;HERRERA TORRALBO EMILIO;RODRIGUEZ FERNANDEZCARLOS;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN. Datos registrales. T 30043 , F 113, S 8, H M 12392, I/A 107 (21.03.13).

19 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: INGLES PERNIA JORDI. Apo.Manc.: BANCELLS BOSCH JOSE. Datos registrales. T 30043 , F113, S 8, H M 12392, I/A 106 (12.12.12).

18 de Diciembre de 2012
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ACUARIOS OCEANWORLD SL. Datos registrales. T 30043 , F 110, S 8, H M12392, I/A 105 (11.12.12).

30 de Octubre de 2012
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 6.499.500,00 Euros. Desembolsado: 6.499.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.500.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 7.500.000,00 Euros. Ampliacion del objeto social. LA GESTION DE CONCESIONES OTORGADASPARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE ACUARIOS.- Datos registrales. T 30043 , F 110, S 8, H M 12392, I/A 104(18.10.12).

21 de Agosto de 2012
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30043 , F 109, S 8, H M 12392, I/A 103 ( 8.08.12).

01 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: COTONER Y MARTOS NICOLAS. Nombramientos. Apoderado: BALLESTER SAAVEDRAFRANCISCO. Reelecciones. Consejero: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS;DE RAMON LACA COTORRUELOJESUS;BARRACHINA MORENO ANGEL. Presidente: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Vicepresid.: DE RAMON LACACOTORRUELO JESUS. Secretario: BARRACHINA MORENO ANGEL. Con.Delegado: SMITH MORRONDO JUAN CARLOS. Datosregistrales. T 24444 , F 112, S 8, H M 12392, I/A 101 (20.07.12).

Revocaciones. Apoderado: BARRACHINA MORENO ANGEL;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN. Nombramientos.Apoderado: GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN;LOBEJON GONZALEZ ADOLFO;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDOJULIAN;VILLAESCUSA GARCIA QUIJADA MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 30043 , F 109, S 8, H M 12392, I/A 102(20.07.12).

10 de Abril de 2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CODINA ZUGASTI PEDRO. Apo.Manc.: EZQUERRA RUIZ MIGUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli:GONZALEZ SERRA FERRAN. Apo.Manc.: EZQUERRA RUIZ MIGUEL. Datos registrales. T 24444 , F 111, S 8, H M 12392, I/A 99(27.03.12).

Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ SERRA FERNANDO;MONTIEL AMAYA ARACELI. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SOLERHERRANZ ARTURO. Apo.Manc.: MONTIEL AMAYA ARACELI. Datos registrales. T 24444 , F 111, S 8, H M 12392, I/A 100(27.03.12).

16 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CODINA ZUGASTI PEDRO. Apo.Manc.: EZQUERRA RUIZ MIGUEL. Datos registrales. T 24444 , F110, S 8, H M 12392, I/A 98 ( 3.11.11).

22 de Septiembre de 2011
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MARINELAND SA. Datos registrales. T 24444 , F 109, S 8, H M 12392, I/A 97 (6.09.11).

17 de Junio de 2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 24444 , F 109, S 8, H M 12392, I/A 96 ( 7.06.11).

13 de Abril de 2011
Otros conceptos: Datos identificativos: Sociedad absorbente "ASPRO OCIO SA",NIFA-07025703,Madrid, calle Oquendo numero 23,inscrita en el RM al tomo 564, folio 14 Hoja M-12.392. Sociedad absorbida "MARINELAND SA2 NIF A07025703Madrid, calle Oquendonumero 23, inscrita en el RM, tomo 9561,folio 162 hoja M153724. Datos registrales. T 564 , F 20, S 8, H M 12392, I/A 6M (31.03.11).

22 de Marzo de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: INGLES PERNIA JORDI. Apo.Manc.: INGLES PERNIA JORDI;SANTIN GALLARDO JOSEP.Nombramientos. Apoderado: FERRES TORRES ESTEBAN;FERRES TORRES ESTEBAN;INGLES PERNIA JORDI. Datosregistrales. T 24444 , F 108, S 8, H M 12392, I/A 95 (10.03.11).

07 de Diciembre de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 24444 , F 108, S 8, H M 12392, I/A 94 (24.11.10).

07 de Julio de 2010
Revocaciones. Apoderado: MASEGOSA SANCHEZ RICARDO;MASEGOSA SANCHEZ RICARDO;AYGUAVIVA MATEOMARTA;INGLES PERNIA JORDI. Nombramientos. Apo.Manc.: LOPEZ GUI脩ON ALFONSO;AYGUAVIVA MATEO MARTA;INGLESPERNIA JORDI. Apoderado: LOPEZ GUI脩ON ALFONSO. Datos registrales. T 24444 , F 107, S 8, H M 12392, I/A 93 (25.06.10).

24 de Diciembre de 2009
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 24444 , F 107, S 8, H M 12392, I/A 92 (15.12.09).

10 de Junio de 2009
Nombramientos. Apoderado: ABRAHAM ALEMANY RAFAEL;MARCOS ANDRES JESUS;CANALS PASTOR BARTOLOME. Datosregistrales. T 24444 , F 105, S 8, H M 12392, I/A 90 (29.05.09).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN. Datos registrales. T 24444 , F 106, S 8, H M 12392, I/A91 (29.05.09).

20 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: PEDREGAL PARDO MIGUEL. Apo.Manc.: PEDREGAL PARDO MIGUEL;MARCOS ANDRESJESUS;GONZALEZ FERNANDEZ PINEDO JULIAN;CANALS PASTOR BARTOLOME. Datos registrales. T 24444 , F 104, S 8, H M12392, I/A 89 ( 6.05.09).

23 de Abril de 2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEDREGAL PARDO MIGUEL. Datos registrales. T 24444 , F 104, S 8, H M 12392, I/A 88(13.04.09).

30 de Enero de 2009
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 24444 , F 104, S 8, H M 12392, I/A 87 (21.01.09).

13 de Enero de 2009
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARINA BARRIO CARLOS. Datos registrales. T 24444 , F 104, S 8, H M 12392, I/A 86 (23.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n