Actos BORME de Asturiana De Perfumeria Sl
22 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Presidente: MU脩IZ FERNANDEZ ANDRES. Cons.Del.Sol: MU脩IZ FERNANDEZ ANDRES. Secretario: EZAMAALVAREZ PABLO. Nombramientos. Presidente: EZAMA ALVAREZ PABLO. Secretario: MU脩IZ GARCIA ENRIQUE ANGEL. Datosregistrales. T 1961 , F 89, S 8, H AS 6539, I/A 26 (14.06.21).
26 de Abril de 2021Nombramientos. Consejero: SUAREZ MARTINEZ ADELA CONSUELO. Datos registrales. T 1961 , F 89, S 8, H AS 6539, I/A 25(19.04.21).
21 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: ATRIUM AUDITORES SA. Datos registrales. T 1961 , F 89, S 8, H AS 6539, I/A 24 (11.01.19).
20 de Abril de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 63.285,30 Euros. Resultante Suscrito: 919.283,59 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 3. Capital social.-. Datos registrales. T 1961 , F 88, S 8, H AS 6539, I/A 23 (12.04.18).
20 de Noviembre de 2015Nombramientos. Auditor: ATRIUM AUDITORES SA. Datos registrales. T 1961 , F 88, S 8, H AS 6539, I/A 22 (12.11.15).
11 de Febrero de 2015Reelecciones. Auditor: ARGUELLO VAZQUEZ JUAN. Aud.Supl.: ALONSO MARTINEZ ELOY ANTONIO. Datos registrales. T 1961, F 88, S 8, H AS 6539, I/A 21 ( 3.02.15).
03 de Abril de 2014Reelecciones. Auditor: ARGUELLO VAZQUEZ JUAN. Aud.Supl.: ALONSO MARTINEZ ELOY ANTONIO. Datos registrales. T 1961, F 88, S 8, H AS 6539, I/A 20 (26.03.14).
11 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: DIAZ SUAREZ JAVIER. Datos registrales. T 1961 , F 88, S 8, H AS 6539, I/A 19 ( 2.10.13).
11 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA UZ UZ ALEJANDRO;EZAMA ALVAREZ PABLO;ROBES FERNANDEZ EVA;GONZALEZMIGUEL ALEJANDRO DESIDERIO;MU脩IZ GARCIA ENRIQUE ANGEL;MU脩IZ FERNANDEZ ANDRES;DIAZ SUAREZ JAVIER.
18 de Mayo de 2011Reelecciones. Auditor: ARGUELLO VAZQUEZ JUAN. Aud.Supl.: ALONSO MARTINEZ ELOY ANTONIO. Datos registrales. T 1961, F 80, S 8, H AS 6539, I/A 17 ( 6.05.11).
15 de Abril de 2010Reelecciones. Auditor: ARGUELLO VAZQUEZ JUAN. Datos registrales. T 1961 , F 80, S 8, H AS 6539, I/A 16 (31.03.10).
11 de Febrero de 2010Nombramientos. Auditor: ALONSO MARTINEZ ELOY ANTONIO. Reelecciones. Auditor: ARGUELLO VAZQUEZ JUAN. Datosregistrales. T 1961 , F 80, S 8, H AS 6539, I/A 14 ( 1.02.10).
Reelecciones. Auditor: ARGUELLO VAZQUEZ JUAN. Datos registrales. T 1961 , F 80, S 8, H AS 6539, I/A 15 ( 1.02.10).
26 de Mayo de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 334.901,24 Euros. Resultante Suscrito: 982.568,89 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culode los estatutos: 3. Capital.-. 8. Transmisi贸n de Acciones/Participaciones.-. Otros conceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 4潞DE LOS ESTATUTOS SOCIALES REFERENTE AL AUMENTO DE CAPITAL. Datos registrales. T 1961 , F 79, S 8, H AS 6539, I/A13 (13.05.09).
05 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA UZ UZ ALEJANDRO;CORDON PIEDRA JOSE;DE LA UZ DE LA LLANA NURIA;IGLESIASSIMON RAQUEL;RUA FERNANDEZ MANUEL;EZAMA ALVAREZ PABLO;MU脩IZ GARCIA JOSE MANUEL;BUENO RICO GIL.Presidente: DE LA UZ DE LA LLANA NURIA. Secretario: IGLESIAS SIMON RAQUEL. Cons.Del.Sol: DE LA UZ UZALEJANDRO;CORDON PIEDRA JOSE. Nombramientos. Consejero: DE LA UZ UZ ALEJANDRO;EZAMA ALVAREZPABLO;ROBES FERNANDEZ EVA;GONZALEZ MIGUEL ALEJANDRO DESIDERIO;MU脩IZ GARCIA ENRIQUE ANGEL;MU脩IZFERNANDEZ ANDRES;DIAZ SUAREZ JAVIER. Presidente: MU脩IZ FERNANDEZ ANDRES. Vicepresid.: MU脩IZ GARCIA ENRIQUEANGEL. Secretario: DIAZ SUAREZ JAVIER. Cons.Del.Sol: EZAMA ALVAREZ PABLO;DE LA UZ UZ ALEJANDRO. Modificacionesestatutarias. 22. Funcionamiento Junta Gral.-. Datos registrales. T 1961 , F 79, S 8, H AS 6539, I/A 12 (23.04.09).