Buscador CIF Logo

Actos BORME Asturiana De Zinc Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Asturiana De Zinc Sa

Actos BORME Asturiana De Zinc Sa - A82689753

Tenemos registrados 67 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Asturiana De Zinc Sa con CIF A82689753

馃敊 Perfil de Asturiana De Zinc Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Asturiana De Zinc Sa

10 de Noviembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: BURTON JOHN WILLIAM. Datos registrales. T 4043 , F 35, S 8, H AS 25924, I/A 115 ( 3.11.23).

29 de Agosto de 2023
Reelecciones. Consejero: ROMERO FERNANDEZ MANUEL;ARIAS ZAPICO JAIME LUIS. Datos registrales. T 4043 , F 34, S 8, HAS 25924, I/A 114 (21.08.23).

10 de Octubre de 2022
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: GLENCORE METALES ESPA脩A SL. Datos registrales. T 4043 , F 34, S 8, H AS25924, I/A 111 (30.09.22).

24 de Marzo de 2022
Otros conceptos: Cambio de denominaci贸n del accionista 煤nico XSTRATA (NEDERLAND) BV, ACTUALMENTE GLENCORE(NEDERLAND) BV. Datos registrales. T 4043 , F 33, S 8, H AS 25924, I/A 110 (16.03.22).

16 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: SANCHEZ TORRES LUIS MIGUEL. Apo.Sol.: SANCHEZ TORRES LUIS MIGUEL;SANCHEZ TORRESLUIS MIGUEL;SANCHEZ TORRES LUIS MIGUELApo.Manc.: SANCHEZ TORRES LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 4043 , F 33,S 8, H AS 25924, I/A 109 ( 5.11.21).

10 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ GARCIA MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 4043 , F 32, S 8, H AS 25924, I/A 108(30.04.21).

10 de Febrero de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: DIEZ BAQUERO JESUS. Datos registrales. T 4043 , F 32, S 8, H AS 25924, I/A 105 ( 1.02.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ABARCA JUNCO I脩IGO. Presidente: ABARCA JUNCO I脩IGO. Nombramientos. Consejero:NAVALPOTRO FUSTER CARLOS ANTONIO. Presidente: NAVALPOTRO FUSTER CARLOS ANTONIO. Datos registrales. T 4043 ,F 32, S 8, H AS 25924, I/A 106 ( 1.02.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: ABARCA JUNCO I脩IGO;ABARCA JUNCO I脩IGO. Datos registrales. T 4043 , F 32, S 8, H AS 25924, I/A107 ( 1.02.21).

27 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4043 , F 32, S 8, H AS 25924, I/A 104 (19.09.19).

29 de Julio de 2019
Revocaciones. Consejero: NAVALPOTRO FUSTER CARLOS ANTONIO. Nombramientos. Consejero: MARAIS WILLEMHENDRIK. Datos registrales. T 4043 , F 32, S 8, H AS 25924, I/A 103 (22.07.19).

27 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO ALVAREZ VICTOR MANUEL;RIOS IGLESIAS MARIA CRUZ;MACIA NU脩EZ JUAN CARLOS.Datos registrales. T 4043 , F 31, S 8, H AS 25924, I/A 102 (19.03.19).

07 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL;SANCHEZ TORRES LUIS MIGUEL;HEVIA AZA SUAREZ JOSEMANUEL;ARTIMEZ HUERTA JUAN JOSE. Datos registrales. T 4043 , F 27, S 8, H AS 25924, I/A 96 (30.01.18).

Nombramientos. Apo.Manc.: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Apo.Sol.: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 4043 , F 28, S 8, H AS 25924, I/A 97 (30.01.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ LORENZO RICARDO. Datos registrales. T 4043 , F 28, S 8, H AS 25924, I/A 98 (30.01.18).

Nombramientos. Apo.Manc.: ARTIMEZ HUERTA JUAN JOSE. Datos registrales. T 4043 , F 28, S 8, H AS 25924, I/A 99 (30.01.18).

Revocaciones. Apo.Manc.: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL;HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Apo.Sol.: HEVIA AZASUAREZ JOSE MANUEL;HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Apo.Manc.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL;SANCHEZ TORRESLUIS MIGUEL. Datos registrales. T 4043 , F 29, S 8, H AS 25924, I/A 100 (30.01.18).

Nombramientos. Apoderado: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4043 , F 29, S 8, H AS 25924, I/A 101(30.01.18).

16 de Octubre de 2017
Revocaciones. Adm. Unico: MECANIZACIONES Y FABRICACIONES SA. Nombramientos. Consejero: ABARCA JUNCOI脩IGO;NAVALPOTRO FUSTER CARLOS ANTONIO;ROMERO FERNANDEZ MANUEL;ARIAS ZAPICO JAIME LUIS. Presidente:ABARCA JUNCO I脩IGO. SecreNoConsj: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Otros conceptos: Modificaci贸n de estatutos porcambio del organo de administraci贸n y la adaptacion a la legislaci贸n vigente. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 4043 , F 17, S 8, H AS 25924, I/A 95 ( 4.10.17).

07 de Julio de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: SANTOS GARCIA ANA MARIA;BASTARDO MANEIRO CAROLINA;DE GREGORIO IGLESIASELIAS;LAVIN MARTIN JUDIT. Datos registrales. T 4043 , F 17, S 8, H AS 25924, I/A 94 (29.06.17).

18 de Octubre de 2016
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4043 , F 17, S 8, H AS 25924, I/A 93 ( 7.10.16).

31 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL;SANCHEZ TORRES LUIS MIGUEL;BOTAS LEAL MARCOS;LOZANADUARTE EMILIO;PALACIO ZAPICO NOEMI. Datos registrales. T 4043 , F 16, S 8, H AS 25924, I/A 92 (22.08.16).

26 de Octubre de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: TAMARGO BENAVIDES EMILIO. Apo.Sol.: TAMARGO BENAVIDES EMILIO;TAMARGO BENAVIDESEMILIO. Apo.Manc.: TAMARGO BENAVIDES EMILIO. Datos registrales. T 4043 , F 16, S 8, H AS 25924, I/A 91 (16.10.15).

07 de Mayo de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: ALVAREZ DAVILA MANUEL;SAN MARTIN GONZALEZ FAUSTINO. Apo.Sol.: SAN MARTIN GONZALEZFAUSTINO;SAN MARTIN GONZALEZ FAUSTINO. Datos registrales. T 4043 , F 16, S 8, H AS 25924, I/A 90 (28.04.15).

21 de Abril de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: LEON SUAREZ IGNACIO. Apo.Sol.: LEON SUAREZ IGNACIO;TEMBOURY MOLINA JAVIER.Apoderado: TEMBOURY MOLINA JAVIER. Datos registrales. T 4043 , F 16, S 8, H AS 25924, I/A 89 (13.04.15).

12 de Enero de 2015
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4043 , F 14, S 8, H AS 25924, I/A85 ( 2.01.15).

Revocaciones. Apo.Manc.: FIGAREDO DE LA MORA CESAR. Apo.Sol.: FIGAREDO DE LA MORA CESAR;FIGAREDO DE LAMORA CESAR. Datos registrales. T 4043 , F 15, S 8, H AS 25924, I/A 86 ( 2.01.15).

Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL. Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL.Datos registrales. T 4043 , F 15, S 8, H AS 25924, I/A 87 ( 2.01.15).

Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Objeto.-. Cambio de objeto social. CNAE 2443 A-La exploracion,investigacion y aprovechamiento de yacimientos minerales y demas recursos del subsuelo,geologicos, minerales, hidrogeologicos,geot茅cnicos y geotermicos), cualesquiera que sean su origen y estado fisico, asi como su denuncia, adquisicion, (por concesion directao deriva. Datos registrales. T 4043 , F 15, S 8, H AS 25924, I/A 88 ( 2.01.15).

25 de Agosto de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: CEREZO HURTADO RAFAEL. Apo.Manc.: CEREZO HURTADO RAFAEL. Apo.Sol.: CEREZO HURTADORAFAEL;PINTADO MARTINEZ JUAN MANUEL. Apo.Manc.: PINTADO MARTINEZ JUAN MANUEL. Apo.Sol.: PINTADO MARTINEZJUAN MANUEL. Datos registrales. T 4043 , F 13, S 8, H AS 25924, I/A 84 (13.08.14).

12 de Junio de 2014
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: XSTRATA (NEDERLAND) BV. Datos registrales. T 4043 , F 12, S 8, H AS 25924,I/A 80 ( 4.06.14).

Nombramientos. Apoderado: PALACIO ZAPICO NOEMI. Datos registrales. T 4043 , F 12, S 8, H AS 25924, I/A 81 ( 4.06.14).

Nombramientos. Apo.Manc.: LOZANA DUARTE EMILIO. Apo.Sol.: LOZANA DUARTE EMILIO. Apo.Manc.: RODRIGUEZPARRONDO MARIA JESUS. Apo.Sol.: RODRIGUEZ PARRONDO MARIA JESUS. Datos registrales. T 4043 , F 12, S 8, H AS25924, I/A 82 ( 4.06.14).

Nombramientos. Apo.Sol.: BOTAS LEAL MARCOS;LOZANA DUARTE EMILIO. Datos registrales. T 4043 , F 13, S 8, H AS 25924,I/A 83 ( 4.06.14).

19 de Mayo de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: AZZOPARDI BRIAN KEITH. Datos registrales. T 4043 , F 4, S 8, H AS 25924, I/A 78 ( 8.05.14).

Nombramientos. Apoderado: BURTON JOHN WILLIAM. Datos registrales. T 4043 , F 4, S 8, H AS 25924, I/A 79 ( 8.05.14).

09 de Mayo de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 31.823,70 Euros. Resultante Suscrito: 406.885.586,60 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6. Capital.-. Art铆culo de los estatutos: 7. Capital.-. Datos registrales. T 4043 , F 3, S 8, H AS25924, I/A 77 (28.04.14).

21 de Enero de 2014
Nombramientos. Apo.Manc.: ALVAREZ GONZALEZ EDUARDO. Apo.Sol.: ALVAREZ GONZALEZ EDUARDO. Datos registrales. T4043 , F 3, S 8, H AS 25924, I/A 75 (13.01.14).

Revocaciones. Apo.Manc.: CARNEADO VALDES AVELINO. Apo.Sol.: CARNEADO VALDES AVELINO. Datos registrales. T 4043 ,F 3, S 8, H AS 25924, I/A 76 (13.01.14).

13 de Agosto de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: QUIROGA ALVAREZ JOSE MARIA. Apoderado: ALVAREZ DAVILA MANUEL. Apo.Manc.: LEON JARIEGOJUAN. Apoderado: LEON JARIEGO JUAN. Apo.Manc.: LEON JARIEGO JUAN. Apo.Sol.: LEON JARIEGO JUAN. Apo.Manc.:SUAREZ LLANA FRANCISCO JAVIER. Apoderado: SUAREZ LLANA FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: SUAREZ LLANA FRANCISCOJAVIER;GONZALEZ CUEVA JOSE LUIS. Apo.Manc.: TAMARGO BENAVIDES EMILIO;LEON JARIEGO JUAN;ROMEROFERNANDEZ MANUEL. Apo.Sol.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T 2952 , F 225, S 8, H AS 25924, I/A 69 (1.08.13).

Nombramientos. Apoderado: TEMBOURY MOLINA JAVIER. Datos registrales. T 2952 , F 225, S 8, H AS 25924, I/A 70 ( 1.08.13).

Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T 2952 , F 225, S 8, H AS 25924, I/A 71 ( 1.08.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL. Apo.Sol.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T4043 , F 2, S 8, H AS 25924, I/A 72 ( 1.08.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: TAMARGO BENAVIDES EMILIO;ROMERO FERNANDEZ MANUEL;SANCHEZ TORRES LUISMIGUEL;HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4043 , F 2, S 8, H AS 25924, I/A 73 ( 1.08.13).

Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ TORRES LUIS MIGUEL;ARTIMEZ HUERTA JUAN JOSE;HEVIA AZA SUAREZ JOSEMANUEL Datos registrales. T 4043 , F 2, S 8, H AS 25924, I/A 74 ( 1.08.13).

02 de Agosto de 2013
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2952 , F 224, S 8, H AS 25924, I/A 68(17.07.13).

11 de Julio de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: AZZOPARDI BRIAN KEITH;ALVAREZ RENDUELES JOSE RAMON;RAMIREZ LARRAURISANTIAGO;ABARCA JUNCO I脩IGO. Presidente: AZZOPARDI BRIAN KEITH. Secretario: ABARCA JUNCO I脩IGO. Nombramientos.Adm. Unico: MECANIZACIONES Y FABRICACIONES SA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 3, 8, 10, 16, 18, 19, 20,23, 25, 27, 28 A 37, 39 Y 42 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 2952 , F 220, S 8, H AS 25924, I/A 67 ( 3.07.13).

04 de Junio de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: ZALDUMBIDE VIADAS SANTIAGO;LEVENE BENNY STEVEN. Datos registrales. T 2952 , F 220, S 8, HAS 25924, I/A 66 (27.05.13).

24 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: ZALDUMBIDE VIADAS SANTIAGO. Presidente: ZALDUMBIDE VIADAS SANTIAGO. Consejero:LAWRENCE DAVIS MICHAEL;LEVENE BENNY STEVEN. Nombramientos. Presidente: AZZOPARDI BRIAN KEITH. Datosregistrales. T 2952 , F 220, S 8, H AS 25924, I/A 65 (16.05.13).

30 de Noviembre de 2012
Reelecciones. Consejero: LEVENE BENNY STEVEN. Datos registrales. T 2952 , F 220, S 8, H AS 25924, I/A 64 (20.11.12).

14 de Septiembre de 2012
Reelecciones. Consejero: AZZOPARDI BRIAN KEITH;LAWRENCE DAVIS MICHAEL. Datos registrales. T 2952 , F 219, S 8, H AS25924, I/A 63 ( 4.09.12).

24 de Agosto de 2012
Revocaciones. Apo.Manc.: DIEZ ARAGON JESUS. Apo.Sol.: DIEZ ARAGON JESUS. Apo.Manc.: HEVIA AZA SUAREZ JOSEMANUEL. Apo.Sol.: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2952 , F 219, S 8, H AS 25924, I/A 62 (13.08.12).

23 de Agosto de 2012
Nombramientos. Apo.Manc.: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Apo.Sol.: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 2952 , F 219, S 8, H AS 25924, I/A 60 (10.08.12).

Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA MOLERA MARTA. Apo.Sol.: GARCIA MOLERA MARTA. Datos registrales. T 2952 , F 219, S8, H AS 25924, I/A 61 (10.08.12).

30 de Julio de 2012
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2952 , F 218, S 8, H AS 25924, I/A 59 (18.07.12).

27 de Julio de 2012
Reelecciones. Consejero: ZALDUMBIDE VIADAS SANTIAGO;ALVAREZ RENDUELES JOSE RAMON;RAMIREZ LARRAURISANTIAGO;ABARCA JUNCO I脩IGO. Datos registrales. T 2952 , F 218, S 8, H AS 25924, I/A 58 (17.07.12).

14 de Diciembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: REINHARD STROTHOTTE WILLY. Vicepresid.: REINHARD STROTHOTTE WILLY. Datosregistrales. T 2952 , F 218, S 8, H AS 25924, I/A 57 (30.11.11).

31 de Octubre de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: ABARCA JUNCO I脩IGO;ARIAS ZAPICO JAIME LUIS;FERNANDEZ GONZALEZ JOSE RAMON. Datosregistrales. T 2952 , F 218, S 8, H AS 25924, I/A 56 (19.10.11).

11 de Agosto de 2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2952 , F 218, S 8, H AS 25924, I/A 55 ( 1.08.11).

19 de Abril de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: ABARCA JUNCO I脩IGO;TEMBOURY MOLINA JAVIER;HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 2952 , F 218, S 8, H AS 25924, I/A 54 ( 7.04.11).

26 de Agosto de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2952 , F 217, S 8, H AS 25924, I/A 52 (11.08.10).

Modificaciones estatutarias. 20. Funcionamiento Junta Gral.-. 30. Administraci贸n y Representacion.-. 34. Administraci贸n yRepresentacion.-. Datos registrales. T 2952 , F 217, S 8, H AS 25924, I/A 53 (11.08.10).

08 de Abril de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ MARGARIDE JOSE LUIS. Datos registrales. T 2952 , F 217, S 8, H AS 25924, I/A 51(25.03.10).

04 de Enero de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: ROBLES ALVAREZ OSCAR. Apo.Sol.: ROBLES ALVAREZ OSCAR. Datos registrales. T 2952 , F 216,S 8, H AS 25924, I/A 49 (18.12.09).

Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL. Apo.Sol.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T2952 , F 216, S 8, H AS 25924, I/A 50 (18.12.09).

29 de Septiembre de 2009
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2952 , F 216, S 8, H AS 25924, I/A 48 (17.09.09).

04 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apo.Manc.: TAMARGO BENAVIDES EMILIO;LEON JARIEGO JUAN. Datos registrales. T 2952 , F 216, S 8, H AS25924, I/A 47 (21.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n