Actos BORME de Asturiana De Zinc Sa
10 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apoderado: BURTON JOHN WILLIAM. Datos registrales. T 4043 , F 35, S 8, H AS 25924, I/A 115 ( 3.11.23).
29 de Agosto de 2023Reelecciones. Consejero: ROMERO FERNANDEZ MANUEL;ARIAS ZAPICO JAIME LUIS. Datos registrales. T 4043 , F 34, S 8, HAS 25924, I/A 114 (21.08.23).
10 de Octubre de 2022Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: GLENCORE METALES ESPA脩A SL. Datos registrales. T 4043 , F 34, S 8, H AS25924, I/A 111 (30.09.22).
24 de Marzo de 2022Otros conceptos: Cambio de denominaci贸n del accionista 煤nico XSTRATA (NEDERLAND) BV, ACTUALMENTE GLENCORE(NEDERLAND) BV. Datos registrales. T 4043 , F 33, S 8, H AS 25924, I/A 110 (16.03.22).
16 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: SANCHEZ TORRES LUIS MIGUEL. Apo.Sol.: SANCHEZ TORRES LUIS MIGUEL;SANCHEZ TORRESLUIS MIGUEL;SANCHEZ TORRES LUIS MIGUELApo.Manc.: SANCHEZ TORRES LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 4043 , F 33,S 8, H AS 25924, I/A 109 ( 5.11.21).
10 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ GARCIA MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 4043 , F 32, S 8, H AS 25924, I/A 108(30.04.21).
10 de Febrero de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: DIEZ BAQUERO JESUS. Datos registrales. T 4043 , F 32, S 8, H AS 25924, I/A 105 ( 1.02.21).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ABARCA JUNCO I脩IGO. Presidente: ABARCA JUNCO I脩IGO. Nombramientos. Consejero:NAVALPOTRO FUSTER CARLOS ANTONIO. Presidente: NAVALPOTRO FUSTER CARLOS ANTONIO. Datos registrales. T 4043 ,F 32, S 8, H AS 25924, I/A 106 ( 1.02.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: ABARCA JUNCO I脩IGO;ABARCA JUNCO I脩IGO. Datos registrales. T 4043 , F 32, S 8, H AS 25924, I/A107 ( 1.02.21).
27 de Septiembre de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4043 , F 32, S 8, H AS 25924, I/A 104 (19.09.19).
29 de Julio de 2019Revocaciones. Consejero: NAVALPOTRO FUSTER CARLOS ANTONIO. Nombramientos. Consejero: MARAIS WILLEMHENDRIK. Datos registrales. T 4043 , F 32, S 8, H AS 25924, I/A 103 (22.07.19).
27 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO ALVAREZ VICTOR MANUEL;RIOS IGLESIAS MARIA CRUZ;MACIA NU脩EZ JUAN CARLOS.Datos registrales. T 4043 , F 31, S 8, H AS 25924, I/A 102 (19.03.19).
07 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL;SANCHEZ TORRES LUIS MIGUEL;HEVIA AZA SUAREZ JOSEMANUEL;ARTIMEZ HUERTA JUAN JOSE. Datos registrales. T 4043 , F 27, S 8, H AS 25924, I/A 96 (30.01.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Apo.Sol.: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 4043 , F 28, S 8, H AS 25924, I/A 97 (30.01.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ LORENZO RICARDO. Datos registrales. T 4043 , F 28, S 8, H AS 25924, I/A 98 (30.01.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: ARTIMEZ HUERTA JUAN JOSE. Datos registrales. T 4043 , F 28, S 8, H AS 25924, I/A 99 (30.01.18).
Revocaciones. Apo.Manc.: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL;HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Apo.Sol.: HEVIA AZASUAREZ JOSE MANUEL;HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Apo.Manc.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL;SANCHEZ TORRESLUIS MIGUEL. Datos registrales. T 4043 , F 29, S 8, H AS 25924, I/A 100 (30.01.18).
Nombramientos. Apoderado: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4043 , F 29, S 8, H AS 25924, I/A 101(30.01.18).
16 de Octubre de 2017Revocaciones. Adm. Unico: MECANIZACIONES Y FABRICACIONES SA. Nombramientos. Consejero: ABARCA JUNCOI脩IGO;NAVALPOTRO FUSTER CARLOS ANTONIO;ROMERO FERNANDEZ MANUEL;ARIAS ZAPICO JAIME LUIS. Presidente:ABARCA JUNCO I脩IGO. SecreNoConsj: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Otros conceptos: Modificaci贸n de estatutos porcambio del organo de administraci贸n y la adaptacion a la legislaci贸n vigente. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 4043 , F 17, S 8, H AS 25924, I/A 95 ( 4.10.17).
07 de Julio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: SANTOS GARCIA ANA MARIA;BASTARDO MANEIRO CAROLINA;DE GREGORIO IGLESIASELIAS;LAVIN MARTIN JUDIT. Datos registrales. T 4043 , F 17, S 8, H AS 25924, I/A 94 (29.06.17).
18 de Octubre de 2016Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4043 , F 17, S 8, H AS 25924, I/A 93 ( 7.10.16).
31 de Agosto de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL;SANCHEZ TORRES LUIS MIGUEL;BOTAS LEAL MARCOS;LOZANADUARTE EMILIO;PALACIO ZAPICO NOEMI. Datos registrales. T 4043 , F 16, S 8, H AS 25924, I/A 92 (22.08.16).
26 de Octubre de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: TAMARGO BENAVIDES EMILIO. Apo.Sol.: TAMARGO BENAVIDES EMILIO;TAMARGO BENAVIDESEMILIO. Apo.Manc.: TAMARGO BENAVIDES EMILIO. Datos registrales. T 4043 , F 16, S 8, H AS 25924, I/A 91 (16.10.15).
07 de Mayo de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: ALVAREZ DAVILA MANUEL;SAN MARTIN GONZALEZ FAUSTINO. Apo.Sol.: SAN MARTIN GONZALEZFAUSTINO;SAN MARTIN GONZALEZ FAUSTINO. Datos registrales. T 4043 , F 16, S 8, H AS 25924, I/A 90 (28.04.15).
21 de Abril de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: LEON SUAREZ IGNACIO. Apo.Sol.: LEON SUAREZ IGNACIO;TEMBOURY MOLINA JAVIER.Apoderado: TEMBOURY MOLINA JAVIER. Datos registrales. T 4043 , F 16, S 8, H AS 25924, I/A 89 (13.04.15).
12 de Enero de 2015Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4043 , F 14, S 8, H AS 25924, I/A85 ( 2.01.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: FIGAREDO DE LA MORA CESAR. Apo.Sol.: FIGAREDO DE LA MORA CESAR;FIGAREDO DE LAMORA CESAR. Datos registrales. T 4043 , F 15, S 8, H AS 25924, I/A 86 ( 2.01.15).
Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL. Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL.Datos registrales. T 4043 , F 15, S 8, H AS 25924, I/A 87 ( 2.01.15).
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Objeto.-. Cambio de objeto social. CNAE 2443 A-La exploracion,investigacion y aprovechamiento de yacimientos minerales y demas recursos del subsuelo,geologicos, minerales, hidrogeologicos,geot茅cnicos y geotermicos), cualesquiera que sean su origen y estado fisico, asi como su denuncia, adquisicion, (por concesion directao deriva. Datos registrales. T 4043 , F 15, S 8, H AS 25924, I/A 88 ( 2.01.15).
25 de Agosto de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: CEREZO HURTADO RAFAEL. Apo.Manc.: CEREZO HURTADO RAFAEL. Apo.Sol.: CEREZO HURTADORAFAEL;PINTADO MARTINEZ JUAN MANUEL. Apo.Manc.: PINTADO MARTINEZ JUAN MANUEL. Apo.Sol.: PINTADO MARTINEZJUAN MANUEL. Datos registrales. T 4043 , F 13, S 8, H AS 25924, I/A 84 (13.08.14).
12 de Junio de 2014Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: XSTRATA (NEDERLAND) BV. Datos registrales. T 4043 , F 12, S 8, H AS 25924,I/A 80 ( 4.06.14).
Nombramientos. Apoderado: PALACIO ZAPICO NOEMI. Datos registrales. T 4043 , F 12, S 8, H AS 25924, I/A 81 ( 4.06.14).
Nombramientos. Apo.Manc.: LOZANA DUARTE EMILIO. Apo.Sol.: LOZANA DUARTE EMILIO. Apo.Manc.: RODRIGUEZPARRONDO MARIA JESUS. Apo.Sol.: RODRIGUEZ PARRONDO MARIA JESUS. Datos registrales. T 4043 , F 12, S 8, H AS25924, I/A 82 ( 4.06.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: BOTAS LEAL MARCOS;LOZANA DUARTE EMILIO. Datos registrales. T 4043 , F 13, S 8, H AS 25924,I/A 83 ( 4.06.14).
19 de Mayo de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: AZZOPARDI BRIAN KEITH. Datos registrales. T 4043 , F 4, S 8, H AS 25924, I/A 78 ( 8.05.14).
Nombramientos. Apoderado: BURTON JOHN WILLIAM. Datos registrales. T 4043 , F 4, S 8, H AS 25924, I/A 79 ( 8.05.14).
09 de Mayo de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 31.823,70 Euros. Resultante Suscrito: 406.885.586,60 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6. Capital.-. Art铆culo de los estatutos: 7. Capital.-. Datos registrales. T 4043 , F 3, S 8, H AS25924, I/A 77 (28.04.14).
21 de Enero de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: ALVAREZ GONZALEZ EDUARDO. Apo.Sol.: ALVAREZ GONZALEZ EDUARDO. Datos registrales. T4043 , F 3, S 8, H AS 25924, I/A 75 (13.01.14).
Revocaciones. Apo.Manc.: CARNEADO VALDES AVELINO. Apo.Sol.: CARNEADO VALDES AVELINO. Datos registrales. T 4043 ,F 3, S 8, H AS 25924, I/A 76 (13.01.14).
13 de Agosto de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: QUIROGA ALVAREZ JOSE MARIA. Apoderado: ALVAREZ DAVILA MANUEL. Apo.Manc.: LEON JARIEGOJUAN. Apoderado: LEON JARIEGO JUAN. Apo.Manc.: LEON JARIEGO JUAN. Apo.Sol.: LEON JARIEGO JUAN. Apo.Manc.:SUAREZ LLANA FRANCISCO JAVIER. Apoderado: SUAREZ LLANA FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: SUAREZ LLANA FRANCISCOJAVIER;GONZALEZ CUEVA JOSE LUIS. Apo.Manc.: TAMARGO BENAVIDES EMILIO;LEON JARIEGO JUAN;ROMEROFERNANDEZ MANUEL. Apo.Sol.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T 2952 , F 225, S 8, H AS 25924, I/A 69 (1.08.13).
Nombramientos. Apoderado: TEMBOURY MOLINA JAVIER. Datos registrales. T 2952 , F 225, S 8, H AS 25924, I/A 70 ( 1.08.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T 2952 , F 225, S 8, H AS 25924, I/A 71 ( 1.08.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL. Apo.Sol.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T4043 , F 2, S 8, H AS 25924, I/A 72 ( 1.08.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: TAMARGO BENAVIDES EMILIO;ROMERO FERNANDEZ MANUEL;SANCHEZ TORRES LUISMIGUEL;HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4043 , F 2, S 8, H AS 25924, I/A 73 ( 1.08.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ TORRES LUIS MIGUEL;ARTIMEZ HUERTA JUAN JOSE;HEVIA AZA SUAREZ JOSEMANUEL Datos registrales. T 4043 , F 2, S 8, H AS 25924, I/A 74 ( 1.08.13).
02 de Agosto de 2013Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2952 , F 224, S 8, H AS 25924, I/A 68(17.07.13).
11 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: AZZOPARDI BRIAN KEITH;ALVAREZ RENDUELES JOSE RAMON;RAMIREZ LARRAURISANTIAGO;ABARCA JUNCO I脩IGO. Presidente: AZZOPARDI BRIAN KEITH. Secretario: ABARCA JUNCO I脩IGO. Nombramientos.Adm. Unico: MECANIZACIONES Y FABRICACIONES SA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 3, 8, 10, 16, 18, 19, 20,23, 25, 27, 28 A 37, 39 Y 42 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 2952 , F 220, S 8, H AS 25924, I/A 67 ( 3.07.13).
04 de Junio de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: ZALDUMBIDE VIADAS SANTIAGO;LEVENE BENNY STEVEN. Datos registrales. T 2952 , F 220, S 8, HAS 25924, I/A 66 (27.05.13).
24 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ZALDUMBIDE VIADAS SANTIAGO. Presidente: ZALDUMBIDE VIADAS SANTIAGO. Consejero:LAWRENCE DAVIS MICHAEL;LEVENE BENNY STEVEN. Nombramientos. Presidente: AZZOPARDI BRIAN KEITH. Datosregistrales. T 2952 , F 220, S 8, H AS 25924, I/A 65 (16.05.13).
30 de Noviembre de 2012Reelecciones. Consejero: LEVENE BENNY STEVEN. Datos registrales. T 2952 , F 220, S 8, H AS 25924, I/A 64 (20.11.12).
14 de Septiembre de 2012Reelecciones. Consejero: AZZOPARDI BRIAN KEITH;LAWRENCE DAVIS MICHAEL. Datos registrales. T 2952 , F 219, S 8, H AS25924, I/A 63 ( 4.09.12).
24 de Agosto de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: DIEZ ARAGON JESUS. Apo.Sol.: DIEZ ARAGON JESUS. Apo.Manc.: HEVIA AZA SUAREZ JOSEMANUEL. Apo.Sol.: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2952 , F 219, S 8, H AS 25924, I/A 62 (13.08.12).
23 de Agosto de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Apo.Sol.: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 2952 , F 219, S 8, H AS 25924, I/A 60 (10.08.12).
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA MOLERA MARTA. Apo.Sol.: GARCIA MOLERA MARTA. Datos registrales. T 2952 , F 219, S8, H AS 25924, I/A 61 (10.08.12).
30 de Julio de 2012Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2952 , F 218, S 8, H AS 25924, I/A 59 (18.07.12).
27 de Julio de 2012Reelecciones. Consejero: ZALDUMBIDE VIADAS SANTIAGO;ALVAREZ RENDUELES JOSE RAMON;RAMIREZ LARRAURISANTIAGO;ABARCA JUNCO I脩IGO. Datos registrales. T 2952 , F 218, S 8, H AS 25924, I/A 58 (17.07.12).
14 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: REINHARD STROTHOTTE WILLY. Vicepresid.: REINHARD STROTHOTTE WILLY. Datosregistrales. T 2952 , F 218, S 8, H AS 25924, I/A 57 (30.11.11).
31 de Octubre de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: ABARCA JUNCO I脩IGO;ARIAS ZAPICO JAIME LUIS;FERNANDEZ GONZALEZ JOSE RAMON. Datosregistrales. T 2952 , F 218, S 8, H AS 25924, I/A 56 (19.10.11).
11 de Agosto de 2011Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2952 , F 218, S 8, H AS 25924, I/A 55 ( 1.08.11).
19 de Abril de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: ABARCA JUNCO I脩IGO;TEMBOURY MOLINA JAVIER;HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 2952 , F 218, S 8, H AS 25924, I/A 54 ( 7.04.11).
26 de Agosto de 2010Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2952 , F 217, S 8, H AS 25924, I/A 52 (11.08.10).
Modificaciones estatutarias. 20. Funcionamiento Junta Gral.-. 30. Administraci贸n y Representacion.-. 34. Administraci贸n yRepresentacion.-. Datos registrales. T 2952 , F 217, S 8, H AS 25924, I/A 53 (11.08.10).
08 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ MARGARIDE JOSE LUIS. Datos registrales. T 2952 , F 217, S 8, H AS 25924, I/A 51(25.03.10).
04 de Enero de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: ROBLES ALVAREZ OSCAR. Apo.Sol.: ROBLES ALVAREZ OSCAR. Datos registrales. T 2952 , F 216,S 8, H AS 25924, I/A 49 (18.12.09).
Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL. Apo.Sol.: ROMERO FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T2952 , F 216, S 8, H AS 25924, I/A 50 (18.12.09).
29 de Septiembre de 2009Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2952 , F 216, S 8, H AS 25924, I/A 48 (17.09.09).
04 de Mayo de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: TAMARGO BENAVIDES EMILIO;LEON JARIEGO JUAN. Datos registrales. T 2952 , F 216, S 8, H AS25924, I/A 47 (21.04.09).