Buscador CIF Logo

Actos BORME Atencion Social En Emergencias Grupo 5 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Atencion Social En Emergencias Grupo 5 Sl

Actos BORME Atencion Social En Emergencias Grupo 5 Sl - B85595239

Tenemos registrados 32 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Atencion Social En Emergencias Grupo 5 Sl con CIF B85595239

馃敊 Perfil de Atencion Social En Emergencias Grupo 5 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Atencion Social En Emergencias Grupo 5 Sl

30 de Octubre de 2018
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 34846 , F 41, S 8, H M 476090, I/A 32 (23.10.18).

01 de Junio de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO. Apo.Sol.: SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO.Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 34846 , F 37, S 8, H M 476090, I/A 29(25.05.18).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ ORDOVAS JAVIER. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ORDOVAS JAVIER. Datosregistrales. T 34846 , F 39, S 8, H M 476090, I/A 30 (25.05.18).

Revocaciones. Apoderado: CALVARRO ORDAS SILVIA. Nombramientos. Apoderado: CALVARRO ORDAS SILVIA. Datosregistrales. T 34846 , F 40, S 8, H M 476090, I/A 31 (25.05.18).

23 de Enero de 2018
Nombramientos. Apoderado: CALVARRO ORDAS SILVIA. Datos registrales. T 34846 , F 36, S 8, H M 476090, I/A 28 (15.01.18).

27 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 34846 , F 36, S 8, H M 476090, I/A 27 (18.12.17).

30 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: MARTIN PEREIRA BEATRIZ. Nombramientos. Apo.Manc.: SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO.Apo.Sol.: SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 34846 , F 34, S 8, H M 476090, I/A 26 (23.11.17).

06 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ ORDOVAS JAVIER. Datos registrales. T 34846 , F 33, S 8, H M 476090, I/A 25(26.10.17).

29 de Septiembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: MUSTIELES MU脩OZ DAVID;GOMEZ PASTOR ANA MARIA;BENNASSAR ORDINASJULIA;SANTALICES LOPEZ RAUL;ARIAS FERNANDEZ JULIO;MARTIN PEREIRA BEATRIZ;MARTINEZ PERAL CARMEN.Nombramientos. Apoderado: MARTIN PEREIRA BEATRIZ;OLIVARES YNZENGA ALVARO;SANTA-EULALIA YARTEGABRIEL;LAVILLA RUBIRA CARLOS;ARIAS FERNANDEZ JULIO;SANTALICES LOPEZ RAUL. Datos registrales. T 34846 , F 31, S8, H M 476090, I/A 24 (20.09.17).

18 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: MERIN CA脩ADA TOMAS. Nombramientos. Representan: BELL CIBILS GUILLERMO. Datosregistrales. T 34846 , F 30, S 8, H M 476090, I/A 23 (11.09.17).

02 de Junio de 2017
Modificaciones estatutarias. Se elimina el art铆culo 12.BIS que queda sin contenido.. Datos registrales. T 34846 , F 30, S 8, H M476090, I/A 22 (25.05.17).

24 de Marzo de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: TEJERO ORDO脩EZ JAVIER;MARTIN PEREIRA BEATRIZ. Datos registrales. T 34846 , F 29, S 8, HM 476090, I/A 20 (14.03.17).

Nombramientos. Apoderado: MARTIN PEREIRA BEATRIZ;MARTINEZ PERAL CARMEN. Datos registrales. T 34846 , F 29, S 8, HM 476090, I/A 21 (14.03.17).

03 de Febrero de 2017
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 34846 , F 28, S 8, H M 476090, I/A 19 (26.01.17).

24 de Noviembre de 2016
Modificaciones estatutarias. Se modifica el art铆culo 12 bis de los estatutos.. Datos registrales. T 34846 , F 28, S 8, H M 476090, I/A18 (17.11.16).

21 de Noviembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: PRECIOSO HORCAJO MARIA ELENA. Nombramientos. Apoderado: ARIAS FERNANDEZ JULIO.Datos registrales. T 34846 , F 27, S 8, H M 476090, I/A 17 (11.11.16).

16 de Junio de 2016
Revocaciones. Apoderado: GARCIA RUIZ FERNANDO RAMON;MARTIN PEREIRA BEATRIZ. Nombramientos. Apo.Man.Soli:TEJERO ORDO脩EZ JAVIER;MARTIN PEREIRA BEATRIZ. Datos registrales. T 26420 , F 78, S 8, H M 476090, I/A 16 ( 8.06.16).

31 de Diciembre de 2015
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 26420 , F 78, S 8, H M 476090, I/A 15 (22.12.15).

26 de Noviembre de 2015
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 26420 , F 78, S 8, H M 476090, I/A 14 (18.11.15).

27 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apoderado: BAEZA RUIZ ROSARIO FATIMA. Datos registrales. T 26420 , F 77, S 8, H M 476090, I/A 12 (20.03.14).

Nombramientos. Apoderado: PRECIOSO HORCAJO MARIA ELENA. Datos registrales. T 26420 , F 77, S 8, H M 476090, I/A 13(20.03.14).

11 de Febrero de 2013
Revocaciones. Apoderado: MARTIN PEREIRA BEATRIZ;GARCIA RUIZ FERNANDO. Datos registrales. T 26420 , F 77, S 8, H M476090, I/A 11 ( 1.02.13).

06 de Febrero de 2013
Nombramientos. Apoderado: BAEZA RUIZ ROSARIO FATIMA;GARCIA RUIZ FERNANDO RAMON;MARTIN PEREIRABEATRIZ;BENNASSAR ORDINAS JULIA;SANTALICES LOPEZ RAUL. Datos registrales. T 26420 , F 70, S 8, H M 476090, I/A 10(29.01.13).

13 de Julio de 2012
Revocaciones. Apoderado: CORTES LEON CARLOS. Datos registrales. T 26420 , F 70, S 8, H M 476090, I/A 9 ( 3.07.12).

21 de Febrero de 2012
Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26420 , F 70, S 8, H M 476090, I/A 8 ( 8.02.12).

12 de Abril de 2010
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ PASTOR ANA MARIA. Datos registrales. T 26420 , F 69, S 8, H M 476090, I/A 7 (29.03.10).

09 de Febrero de 2010
Otros conceptos: SE ACUERDA LA DONACION A LA FUNDACION ALDABA DE UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL MENOS AL5% DE LOS BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS Y SE INTRODUCE UN NUEVO ARTICULO EL NUMERO 12 BIS DE LOSESTATUTOS SOCIALES. Cambio de domicilio social. C/ DE LA OLIMPIADA 2 (MADRID). Datos registrales. T 26420 , F 69, S 8,H M 476090, I/A 6 (28.01.10).

14 de Septiembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: MARTIN PEREIRA BEATRIZ. Datos registrales. T 26420 , F 66, S 8, H M 476090, I/A 3 (28.08.09).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA RUIZ FERNANDO. Datos registrales. T 26420 , F 66, S 8, H M 476090, I/A 4 (28.08.09).

Nombramientos. Apoderado: CORTES LEON CARLOS. Datos registrales. T 26420 , F 68, S 8, H M 476090, I/A 5 (28.08.09).

01 de Julio de 2009
Nombramientos. Apoderado: MUSTIELES MU脩OZ DAVID. Datos registrales. T 26420 , F 65, S 8, H M 476090, I/A 2 (22.06.09).

05 de Marzo de 2009
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 27.01.09. Objeto social: EL ESTUDIO, LA PREVENCION E INTERVENCION EN TODOTIPO DE EMERGENCIAS SOCIALES, PARA PALIAR EN LO POSIBLE SUS CONSECUENCIAS EN LAS PERSONAS AFECTADASDIRECTA E INDIRECTAMENTE Y SATISFACER LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LAS MISMA EN LOS ASPECTOSPSICOSOCIALES. Domicilio: AVDA DEL MEDITERRANEO 44 (MADRID). Capital: 3.100,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad.Socio 煤nico: GRUPO 5 ACCION Y GESTION SOCIAL SL. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO 5 ACCION Y GESTION SOCIALSL. Representan: MERIN CA脩ADA TOMAS. Datos registrales. T 26420 , F 64, S 8, H M 476090, I/A 1 (23.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n