Actos BORME de Atencion Social Y Residencial Valdemoro Sl
22 de Noviembre de 2023Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4466, L 4466, F 75, S 8, H PO 64872, I/A 52 (13.11.23).
10 de Octubre de 2023Modificación de poderes. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 50, S 8, H PO64872, I/A 51 ( 2.10.23).
29 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 49, S 8, H PO 64872, I/A50 (21.09.23).
04 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO;ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA;SARMINI SAINZALBERTO;FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO;VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL;VICENTE ARCOS MARIA CARMEN;SOLLATORRES JOSE MANUEL;BRAVO ARAGON PEDRO;RECUENCO COTILLAS PILAR;ALZAMORA CAÑERO ELENA;SARRATOMARTINEZ FRANCISCO JAVIER;REYES PONCE MONICA;RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276,F 49, S 8, H PO 64872, I/A 49 (26.07.23).
28 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN GARCIA ELENA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 49, S 8, H PO 64872, I/A 48 (20.07.23).
27 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 48, S 8, H PO 64872,I/A 47 (18.07.23).
24 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO QUINTELA SANDRA;TAUSTE BAUTISTA HUGO;LAGUNA VALENZUELA MARIA CRISTINA.Datos registrales. T 4276, L 4276, F 47, S 8, H PO 64872, I/A 46 (13.07.23).
20 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: ALZAMORA CAÑERO ELENA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 45, S 8, H PO 64872, I/A 41(12.06.23).
16 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO PERIAÑEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 44, S 8, H PO 64872, I/A 39 (8.06.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 44, S 8, H PO 64872, I/A 40 (8.06.23).
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 44, S 8, H PO 64872, I/A 38(14.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 44, S 8, H PO64872, I/A 37 (27.10.22).
03 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 44, S 8, H PO64872, I/A 36 (26.07.22).
18 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: INSTITUTO SOCIOSANITARIO SL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 43, S 8, H PO 64872, I/A 35 ( 7.01.22).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 43, S 8, H PO 64872, I/A 34(26.10.21).
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 41, S 8, H PO 64872, I/A 33(22.10.21).
26 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 40, S 8, H PO 64872, I/A 32(15.10.21).
21 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 40, S 8, H PO 64872, I/A 31 (13.10.21).
19 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 40, S 8, H PO 64872, I/A 30 ( 7.10.21).
01 de Septiembre de 2021Otros conceptos: El socio único decida añadir el artículo 9º bis a los estatutos sociales, y la modificación del artículo 10.2 de losmismos. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 40, S 8, H PO 64872, I/A 29 (24.08.21).
20 de Julio de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: INSTITUTO SOCIO SANITARIO SL. Datos registrales. T 4276, L4276, F 39, S 8, H PO 64872, I/A 28 (12.07.21).
17 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 39, S 8, H PO 64872, I/A 27 ( 8.06.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 39, S 8, H PO 64872, I/A 26(27.05.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 39, S 8, H PO64872, I/A 25 (26.04.21).
07 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 39, S 8, H PO 64872, I/A 24(31.07.20).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 38, S 8, H PO64872, I/A 23 (22.06.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 38, S 8, H PO 64872, I/A 22 (18.06.20).
13 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 38, S 8, H PO 64872, I/A 21 ( 3.04.20).
23 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PRIETO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 38, S 8, H PO 64872, I/A 20 (15.10.19).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 38, S 8, H PO 64872, I/A 19(16.05.19).
13 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 37, S 8, H PO 64872, I/A 18 ( 7.05.19).
09 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 37, S 8, H PO 64872, I/A 17 ( 2.05.19).
07 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA BUSTAMANTE FRAILE MARIA ANGELES. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 37, S 8, H PO64872, I/A 16 (29.04.19).
04 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MELON CASTRO MARIA JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 35, S 8, H PO 64872, I/A 14(28.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 37, S 8, H PO 64872, I/A 15 (28.03.19).
03 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 36, S 8, H PO 64872, I/A13 (28.03.19).
01 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 35, S 8, H PO 64872,I/A 12 (22.03.19).
28 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4272, L 4272, F 199, S 8, H PO 64872, I/A 10(18.03.19).
Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4272, L 4272, F 202, S 8, H PO 64872, I/A 11(20.03.19).
26 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4272, L 4272, F 198, S 8, H PO 64872, I/A 7(15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4272, L 4272, F 199, S 8, H PO 64872,I/A 8 (15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;ORTS SAN JOSEALFREDO;GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU;PRIETO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4272, L 4272, F 199, S 8, H PO64872, I/A 9 (18.03.19).
22 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4272, L 4272, F 194, S 8, H PO 64872, I/A 4(13.03.19).
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4272, L 4272, F 197, S 8, H PO 64872, I/A 5(14.03.19).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4272, L 4272, F 198, S 8, H PO 64872, I/A 6(14.03.19).
20 de Marzo de 2019Revocaciones. Apoderado: HERNAIZ DEL CAMPO FELIX. Datos registrales. T 4272, L 4272, F 194, S 8, H PO 64872, I/A 3(12.03.19).
05 de Marzo de 2019Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 BAJOS (VIGO). Datos registrales. T 4272, L 4272, F 185, S 8, H PO64872, I/A 1 (26.02.19).
Otros conceptos: MODIFICADO el artículo 6 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales. T4272, L 4272, F 194, S 8, H PO 64872, I/A 2 (26.02.19).
18 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTEGA MESA DIEGO. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFAISABEL. Datos registrales. T 25392 , F 10, S 8, H M 457340, I/A 13 (11.02.19).
19 de Octubre de 2018Declaración de unipersonalidad. Socio único: SERVIGER XXI VALDEMORO SL. Datos registrales. T 25392 , F 10, S 8, H M457340, I/A 12 (11.10.18).
14 de Enero de 2016Otros conceptos: Revocado el nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembrede 2015 a la sociedad " Astureco Auditores SL". Datos registrales. T 25392 , F 9, S 8, H M 457340, I/A 11 ( 4.01.16).
20 de Julio de 2015Cambio de domicilio social. C/ LILI ALVAREZ 3 - ESQUINA CALLE AGATHA CHRISTIE (VALDEMORO). Datos registrales. T25392 , F 9, S 8, H M 457340, I/A 10 (10.07.15).
09 de Abril de 2014Nombramientos. Auditor: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1456 , F 192, S 8, H VA 26378, I/A 5 ( 2.04.14).
01 de Abril de 2014Revocaciones. Apoderado: MORENO PASCUAL ELENA. Datos registrales. T 1456 , F 191, S 8, H VA 26378, I/A 3 (25.03.14).
Nombramientos. Apoderado: HERNAIZ DEL CAMPO FELIX. Datos registrales. T 1456 , F 191, S 8, H VA 26378, I/A 4 (25.03.14).
28 de Febrero de 2014Cambio de domicilio social. C/ MONATERIO SAN PEDRO DE ALCANTARA 117 (VALLADOLID). Datos registrales. T 1456 , F190, S 8, H VA 26378, I/A 2 (21.02.14).
15 de Enero de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANCHEZ HERNANDEZ MARIA CARLA. Nombramientos. Adm. Unico: ORTEGA MESA DIEGO.Datos registrales. T 25392 , F 7, S 8, H M 457340, I/A 8 ( 3.01.14).
15 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: RAMIREZ FERNANDEZ ANA MARIA PILAR;SANCHEZ HERNANDEZ MARIA CARLA.Nombramientos. Adm. Unico: SANCHEZ HERNANDEZ MARIA CARLA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de
14 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MORENO PASCUAL ELENA. Nombramientos. Adm. Mancom.: SANCHEZ HERNANDEZMARIA CARLA. Datos registrales. T 25392 , F 7, S 8, H M 457340, I/A 6 ( 1.02.12).
27 de Marzo de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: AMOR MORENO CARLOTA;MORENO PASCUAL ELENA;RAMIREZ FERNANDEZ ANA MARIAPILAR. Nombramientos. Apoderado: MORENO PASCUAL ELENA. Datos registrales. T 25392 , F 5, S 8, H M 457340, I/A 5(13.03.09).