Actos BORME de Atox Sistemas De Almacenaje Sociedad Anonima
30 de Noviembre de 2023Otros conceptos: Se modifica el proyecto de fusion de la sociedad de esta hoja como sociedad Absorbente y NEVAL TECHNICALINVESTMENTS SOCIEDAD LIMITADA como sociedad Absorbida, depositado bajo el expediente numero 601. Datos registrales. T1084 , F 225, S 8, H AS 1550, I/A 33 N (27.11.23).
07 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: BLASQUIZ MORENO JOSE. Datos registrales. T 1084 , F 225, S 8, H AS 1550, I/A 33 (30.06.22).
29 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: GRANJO MEANA MARIA PAULA. Nombramientos. Consejero: SUAREZ SIERRA JOSE LUIS. Datosregistrales. T 1084 , F 225, S 8, H AS 1550, I/A 32 (22.03.22).
26 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: GRANJO MEANA PAULA;LEBORDAIS SERGE. Presidente: BLASQUIZ MORENO JOSE. Secretario:GRANJO MEANA PAULA. Cons.Del.Sol: BLASQUIZ MORENO JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: ALVARGONZALEZTREMOLS ALEJANDRO. Consejero: SAEZ NEGRILLO FERNANDO. Presidente: SAEZ NEGRILLO FERNANDO. Consejero:VALDERRAMA SANCHEZ RODRIGO ANTONIO. Datos registrales. T 1084 , F 224, S 8, H AS 1550, I/A 31 (18.01.22).
08 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Auditor: VACIERO AUDITORES SL.Datos registrales. T 1084 , F 224, S 8, H AS 1550, I/A 30 (29.12.20).
31 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: BLASQUIZ MORENO JOSE;GRANJO MEANA PAULA;LEBORDAIS SERGE. Presidente: BLASQUIZMORENO JOSE. Secretario: GRANJO MEANA PAULA. Con.Delegado: BLASQUIZ MORENO JOSE. Nombramientos. Consejero:GRANJO MEANA PAULA;LEBORDAIS SERGE;BLASQUIZ MORENO JOSE. Presidente: BLASQUIZ MORENO JOSE. Secretario:GRANJO MEANA PAULA. Cons.Del.Sol: BLASQUIZ MORENO JOSE. Datos registrales. T 1084 , F 224, S 8, H AS 1550, I/A 29(24.07.20).
21 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1084 , F 224, S 8, H AS 1550, I/A 28(14.01.20).
18 de Noviembre de 2019Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ATOX INDUSTRIAL SL. Datos registrales. T 1084 , F 223, S 8, H AS 1550, I/A 27 (7.11.19).
31 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: PORRAS ALONSO ANTONIO. Datos registrales. T 1084 , F 223, S 8, H AS 1550, I/A 26 (23.01.19).
11 de Julio de 2017Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1084 , F 223, S 8, H AS 1550, I/A 25 (3.07.17).
14 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: BLASQUIZ MORENO JOSE;GRANJO MEANA PAULA;PORRAS ALONSO ANTONIO;LEBORDAISSERGE. Presidente: BLASQUIZ MORENO JOSE. Secretario: GRANJO MEANA PAULA. Cons.Del.Sol: BLASQUIZ MORENO JOSE.Nombramientos. Consejero: BLASQUIZ MORENO JOSE;GRANJO MEANA PAULA;PORRAS ALONSO ANTONIO;LEBORDAISSERGE. Presidente: BLASQUIZ MORENO JOSE. Secretario: GRANJO MEANA PAULA. Con.Delegado: BLASQUIZ MORENO JOSE.Datos registrales. T 1084 , F 222, S 8, H AS 1550, I/A 24 ( 6.05.15).
29 de Enero de 2015Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio.-. 29. Administraci贸n y Representacion.-. Cambio de domicilio
29 de Agosto de 2013Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1084 , F 222, S 8, H AS 1550, I/A 22(21.08.13).