Actos BORME de Auditores Administradores Concursales Y Peritos Slp
19 de Enero de 2021Cierre provisional hoja registral por baja en el 铆ndice de Entidades Jur铆dicas. Datos registrales. T 3454, L 2366, F 45, S 8, H MA67479, I/A 1 A ( 2.12.20).
28 de Diciembre de 2011Modificaciones estatutarias. Aumentos de capital y ejercicio del derecho de suscripci贸n preferente. Datos registrales. T 4519, L3428, F 69, S 8, H MA 67479, I/A 11 (14.12.11).
Nombramientos. Soc.Prof.: VILLALBA GARCIA PEDRO ANGEL;ROBLES DIAZ MARIA DEL CARMEN;MARIN LOPEZ JUANLUIS;GONZALEZ MARTIN SALVADOR;GARCIA NUEZ ELENA MARIA;GABRIELLI GONZALEZ MIGUEL AGUSTIN;SAN CRISTOBALROVERE HECTOR RUBEN;ROBLES DIAZ JUAN CARLOS;GABRIELLI GONZALEZ ADOLFO;MOLINA RODRIGUEZ EDUARDOMIGUEL. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.300,00 Euros. Ampliacion del objeto social.Todas las actuaciones como auditores de cuentas, expertos independientes encomendados por todos los Juzgados y Jurisdicciones,Registro Mercantil,organismos p煤blicos y privados, incluidas la Entidades Locales, Organismosaut贸nomos, sociedades y entidadesdependientes de las enti. Datos registrales. T 4519, L 3428, F 69, S 8, H MA 67479, I/A 12 (14.12.11).
08 de Noviembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.630,00 Euros. Datos registrales. T 4519, L 3428, F 68, S 8,H MA 67479, I/A 9 (21.10.11).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CANDELA RAMOS RUBEN. Vicepresid.: CANDELA RAMOS RUBEN. Cons.Del.Man: CANDELARAMOS RUBEN. Consejero: FERRERA CORDERO ROBERTO. Cons.Del.Man: FERRERA CORDERO ROBERTO. Consejero:MENDEZ DE CASTRO MANUEL JUAN. Vicesecret.: MENDEZ DE CASTRO MANUEL JUAN. Cons.Del.Man: MENDEZ DE CASTROMANUEL JUAN. Secretario: GONZALEZ SANTOS MANUEL. Cons.Del.Man: GONZALEZ SANTOS MANUEL. Consejero: ROBLESGOMEZ FRANCISCO. Presidente: ROBLES GOMEZ FRANCISCO. Consejero: GONZALEZ SANTOS MANUEL. Nombramientos.Consejero: ROBLES GOMEZ FRANCISCO;CANDELA RAMOS RUBEN;GONZALEZ SANTOS MANUEL;FERRERA CORDEROROBERTO;MENDEZ DE CASTRO MANUEL JUAN. Presidente: ROBLES GOMEZ FRANCISCO. Vicepresid.: CANDELA RAMOSRUBEN. Secretario: GONZALEZ SANTOS MANUEL. Cons.Del.Man: CANDELA RAMOS RUBEN;GONZALEZ SANTOSMANUEL;FERRERA CORDERO ROBERTO;MENDEZ DE CASTRO MANUEL JUAN. Ampliaci贸n de capital. Capital: 19.330,00Euros. Resultante Suscrito: 10.300,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 10.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00Euros. Cambio de objeto social. Todas las actuaciones como auditores de cuentas, expertos independientesencomendados portodos los Juzgados y Jurisdicciones, Registro Mercantil, organismos p煤blicos y privados, incluidas las Entidades Locales,OrganismosAut贸nomos, sociedades y entidades dependientes de ent. Datos registrales. T 4519, L 3428, F 68, S 8, H MA 67479, I/A10 (24.10.11).
25 de Agosto de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.630,00 Euros. Datos registrales. T 4519, L 3428, F 67, S 8,H MA 67479, I/A 9 (16.08.11).