Actos BORME de Auditores De Energia Y Medio Ambiente Sa
08 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 20828 , F 48, S 8, H M 96312, I/A 49(31.10.22).
14 de Septiembre de 2020Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.audema.com. Datos registrales. T 20828 , F 48, S 8, H M96312, I/A 48 ( 7.09.20).
11 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: REGIDOR IPIÑA DANIEL. Secretario: REGIDOR IPIÑA DANIEL. Consejero: GALATAS MARTINEZPABLO. Cons.Del.Sol: REGIDOR IPIÑA DANIEL;GALATAS MARTINEZ PABLO. Consejero: GALATAS MARTINEZ PEDRO.Cons.Del.Sol: GALATAS MARTINEZ PEDRO. Presidente: GALATAS MARTINEZ PEDRO. Nombramientos. Consejero: GALATASMARTINEZ PABLO. Cons.Del.Sol: GALATAS MARTINEZ PABLO;GALATAS MARTINEZ PEDRO. Consejero: GALATAS MARTINEZPEDRO. Presidente: GALATAS MARTINEZ PEDRO. Consejero: REGIDOR IPIÑA DANIEL. Secretario: REGIDOR IPIÑA DANIEL.Cons.Del.Sol: REGIDOR IPIÑA DANIEL. Datos registrales. T 20828 , F 48, S 8, H M 96312, I/A 47 ( 3.08.20).
19 de Marzo de 2020Revocaciones. Apoderado: GOMEZ OLEA PEÑA RAMON;GALATAS ROVIRA FERNANDO;REGIDOR ARRIBAS JUANJOSE;GONZALEZ MOLINUEVO JESUS ENRIQUE. Datos registrales. T 20828 , F 48, S 8, H M 96312, I/A 46 (12.03.20).
03 de Diciembre de 2019Nombramientos. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 20828 , F 48, S 8, H M 96312, I/A 45(26.11.19).
04 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: JANER OTERO AGUSTIN. Presidente: JANER OTERO AGUSTIN. Cons.Del.Sol: JANER OTEROAGUSTIN. Nombramientos. Consejero: GALATAS MARTINEZ PEDRO. Cons.Del.Sol: GALATAS MARTINEZ PEDRO. Presidente:GALATAS MARTINEZ PEDRO. Datos registrales. T 20828 , F 47, S 8, H M 96312, I/A 44 (28.01.19).
23 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 20828 , F 47, S 8, H M 96312, I/A 43(15.01.19).
12 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 20828 , F 47, S 8, H M 96312, I/A 42(30.11.17).
01 de Marzo de 2017Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ampliación de capital. Suscrito: 70.455,23 Euros. Desembolsado: 70.455,23 Euros.Resultante Suscrito: 479.736,23 Euros. Resultante Desembolsado: 479.736,23 Euros. Datos registrales. T 20828 , F 46, S 8, H M96312, I/A 41 (20.02.17).
10 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 20828 , F 45, S 8, H M 96312, I/A 40(30.12.16).
18 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 20828 , F 45, S 8, H M 96312, I/A 39 (8.01.16).
05 de Mayo de 2015Declaración de unipersonalidad. Socio único: ACTIVIDADES SUBACUATICAS DEL NORTE SL. Datos registrales. T 20828 , F45, S 8, H M 96312, I/A 38 (24.04.15).
18 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 20828 , F 45, S 8, H M 96312, I/A 37(10.12.14).
08 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GALATAS ROVIRA FERNANDO. Nombramientos. Consejero: JANER OTERO AGUSTIN.Presidente: JANER OTERO AGUSTIN. Consejero: REGIDOR IPIÑA DANIEL. Secretario: REGIDOR IPIÑA DANIEL. Consejero:GALATAS MARTINEZ PABLO. Cons.Del.Sol: JANER OTERO AGUSTIN;REGIDOR IPIÑA DANIEL;GALATAS MARTINEZ PABLO.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Otrosconceptos: COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION, SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 16º,17º Y 19º DE LOS ESTATUTOS.- Cambio de domicilio social. C/ SANTORCAZ 4 (MADRID). Datos registrales. T 20828 , F 44, S8, H M 96312, I/A 36 ( 1.07.14).
03 de Febrero de 2014Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 20828 , F 44, S 8, H M 96312, I/A 35(22.01.14).
27 de Febrero de 2013Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 20828 , F 44, S 8, H M 96312, I/A 34(19.02.13).
24 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 20828 , F 43, S 8, H M 96312, I/A 33(13.01.12).
16 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MOLINUEVO JESUS ENRIQUE. Datos registrales. T 20828 , F 43, S 8, H M 96312, I/A32 ( 2.09.11).
20 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: LOMBANA LARREA LUIS;GALATAS MARTINEZ PABLO;GALATAS MARTINEZ PEDRO. Presidente:LOMBANA LARREA LUIS. Secretario: GALATAS MARTINEZ PEDRO. Cons.Del.Sol: LOMBANA LARREA LUIS;GALATAS MARTINEZPABLO;GALATAS MARTINEZ PEDRO. Nombramientos. Adm. Unico: GALATAS ROVIRA FERNANDO. Modificacionesestatutarias. Artículo de los estatutos: 16. Administración y Representacion.-. Datos registrales. T 20828 , F 42, S 8, H M 96312, I/A31 ( 6.05.09).
16 de Marzo de 2009Nombramientos. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 20828 , F 42, S 8, H M 96312, I/A 30 (4.03.09).