Actos BORME de Auren Abogados Y Asesores Fiscales Sp Slp
21 de Septiembre de 2023Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.490,00 Euros. Resultante Suscrito: 727.520,00 Euros. Cambio de denominaci贸n social. AURENLEGAL SP SLP. Datos registrales. T 40161 , F 187, S 8, H M 610939, I/A 36 (14.09.23).
24 de Abril de 2023Nombramientos. Soc.Prof.: LLUNA ROMERO RAFAEL;GARCIA GARCIA MARIA SUSANA. Otros conceptos: El socio "AurenHolding SP SLP", vende la participaci贸n n煤mero 68023 a Do帽a Mar铆a Susana Garc铆a Garc铆a. El socio profesional "Auren Holding SPSLP" vende la participaci贸n n煤mero 68.024 a D. Rafael Lluna Romero. Datos registrales. T 40161 , F 186, S 8, H M 610939, I/A 34(17.04.23).
09 de Febrero de 2023Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA MARIA SUSANA;LLUNA ROMERO RAFAEL. Datos registrales. T 40161 , F 184, S8, H M 610939, I/A 33 ( 2.02.23).
27 de Diciembre de 2022Ampliaci贸n de capital. Capital: 39.150,00 Euros. Resultante Suscrito: 719.370,00 Euros. Datos registrales. T 40161 , F 182, S 8, HM 610939, I/A 32 (19.12.22).
28 de Octubre de 2022Revocaciones. Soc.Prof.: DEL VALLE SCHAAN MARIA CELINA. Datos registrales. T 40161 , F 182, S 8, H M 610939, I/A 31(21.10.22).
28 de Junio de 2022Otros conceptos: Comunicaci贸n proyecto de segregaci贸n. Datos registrales. T 33949 , F 34, S 8, H M 610939, I/A 4 M (21.06.22).
26 de Mayo de 2022Revocaciones. Soc.Prof.: GOMEZ VALVERDE ANTONIO. Otros conceptos: Don Antonio Gomez Valverde vende la participacionnumero 29 a la sociedad " AUREN HOLDING SP SLP". Datos registrales. T 40161 , F 181, S 8, H M 610939, I/A 30 (19.05.22).
03 de Mayo de 2022Nombramientos. Soc.Prof.: GILARRANZ GILARANZ ALBERTO. Ampliaci贸n de capital. Capital: 10,00 Euros. Resultante Suscrito:680.220,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5潞.-. Capital social.-. Datos registrales. T 40161 , F 181,S 8, H M 610939, I/A 29 (25.04.22).
27 de Abril de 2022Reelecciones. Auditor: BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 40161 , F 180, S 8, H M 610939, I/A 28(20.04.22).
11 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ENCISO MONICA;GRACIA ESTEVEZ ROBERTO. Datos registrales. T 40161 , F 179,S 8, H M 610939, I/A 27 ( 4.02.22).
27 de Enero de 2022Revocaciones. Soc.Prof.: CORTES RUBIRA MANUEL;CORTES ROYO JUAN-JOSE. Otros conceptos: El socio Don Juan Jos茅Cort茅s Royo transmite 1 participaci贸n, la n煤mero 19, al socio profesional "AUREN HOLDING SP, S.L.P.". Datos registrales. T 40161 ,F 178, S 8, H M 610939, I/A 26 (20.01.22).
01 de Octubre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: CORTES RUBIRA MANUEL;CORTES RUBIRA MANUEL;BARCOS BARCOS SILVIA. Datosregistrales. T 40161 , F 178, S 8, H M 610939, I/A 25 (24.09.21).
21 de Abril de 2021Nombramientos. Soc.Prof.: JIMENEZ GONZALEZ FERNANDO. Otros conceptos: Transmisi贸n de 1 participaci贸n del Socio "AurenHolding SP, SLP" al socio Fernando Jimenez Gonz谩lez. Datos registrales. T 40161 , F 177, S 8, H M 610939, I/A 24 (14.04.21).
19 de Abril de 2021Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 10, 11, 15 y 17 de los Estatutos sociales. . Datos registrales. T 40161 , F176, S 8, H M 610939, I/A 23 (12.04.21).
13 de Noviembre de 2020Revocaciones. Soc.Prof.: PARRA GOMEZ RAMON. Nombramientos. Soc.Prof.: BERNABE BARQUIN JESUS;BLANCOFERNANDEZ MARIO;RUIZ-RICO VERA MERCEDES. Otros conceptos: El socio PARRA GOMEZ RAMON transmite un n煤mero de1 participaci贸n al socio RUIZ-RICO VERA MERCEDES. El socio AUREN HOLDING SP SLP transmite un n煤mero de 1 participaci贸n alsocio BERNABE BARQUIN, JESUS. El socio AUREN HOLDING SP SLP transmite un n煤mero de 1 participaci贸n al socio BLANCOFERNANDEZ MARIO. Datos registrales. T 40161 , F 175, S 8, H M 610939, I/A 22 ( 5.11.20).
15 de Septiembre de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 13.970,00 Euros. Resultante Suscrito: 680.210,00 Euros. Datos registrales. T 38488 , F 209, S 8, HM 610939, I/A 21 ( 8.09.20).
28 de Julio de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERRANDEZ MARTINEZ LUISA MARIA. Datos registrales. T 38488 , F 207, S 8, H M 610939, I/A 19(21.07.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARCOS BARCOS SILVIA. Datos registrales. T 38488 , F 207, S 8, H M 610939, I/A 20 (21.07.20).
08 de Mayo de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: CANTERA HERRERO FRANCISCO JAVIER;SAEZ CASTRO DANIEL;BARGALLO FERRER JOSEMARIA. Datos registrales. T 38488 , F 205, S 8, H M 610939, I/A 18 (30.04.20).
25 de Febrero de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: PARRA GOMEZ RAMON. Datos registrales. T 38488 , F 205, S 8, H M 610939, I/A 17 (18.02.20).
12 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: SAEZ CASTRO DANIEL;BARGALLO FERRER JOSE MARIA;MONTALBAN MASEDAFERNANDO;GALIPIENSO ANGLES JOSE LUIS;PICAZO GONZALEZ JULIO. Datos registrales. T 38488 , F 201, S 8, H M 610939,I/A 16 ( 5.11.19).
29 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BARGALLO FERRER JOSE MARIA;PICAZO GONZALEZ JULIO. Nombramientos. Consejero:BARGALLO FERRER JOSE MARIA. Presidente: BARGALLO FERRER JOSE MARIA. Consejero: SAEZ CASTRO DANIEL. Secretario:SAEZ CASTRO DANIEL. Consejero: SANCHEZ BLEDA GARCIA MARIA DEL PILAR;CAMBRA GRAS JOSE MANUEL;GONZALEZVILLALONGA FERNANDO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 38488 , F 201, S 8, H M 610939, I/A 15 (22.08.19).
08 de Julio de 2019Nombramientos. Soc.Prof.: GONZALEZ VILLALONGA FERNANDO. Otros conceptos: Do帽a Yolanda Lobau Andr茅s vende suparticipaci贸n n煤mero 6 al socio profesional don Fernando Gonz谩lez Villalonga. Datos registrales. T 38488 , F 200, S 8, H M 610939,I/A 14 ( 1.07.19).
28 de Marzo de 2019Reelecciones. Auditor: BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 38488 , F 200, S 8, H M 610939, I/A 13(21.03.19).
09 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ VILLALONGA FERNANDO. Datos registrales. T 35469 , F 151, S 8, H M 610939, I/A12 ( 2.02.18).
02 de Enero de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 26.070,00 Euros. Resultante Suscrito: 666.240,00 Euros. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n dela p谩gina web corporativa: http.//intranet.auren.es/. Datos registrales. T 35469 , F 146, S 8, H M 610939, I/A 11 (20.12.17).
13 de Junio de 2017Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 11潞 de los estatutos.. Datos registrales. T 35469 , F 146, S 8, H M 610939,I/A 10 ( 6.06.17).
06 de Abril de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: PARRA GOMEZ RAMON;SAEZ CASTRO DANIEL;SAUCA CANO JOSE IGNACIO;SANCHEZBLEDA GARCIA PILAR;DELGADO MONTERO JOSE IGNACIO;MONTALBAN MASEDA FERNANDO;GALIPIENSO ANGLES JOSELUIS;PEREZ MI脩ANA RICARD;SENTI DOMENECH ANTONIO;CAMBRA GRAS JOSE MANUEL;FERNANDEZ DE PEDROFRANCISCO;CASA脩AS RODRIGUEZ RUPERTO;GARRIDO CACERES JOSE LUIS;PICAZO GONZALEZ PABLOFRANCISCO;SERRANO CLAMAGIRAND PABLO;TORMO SANTONJA GONZALO;VALLDECABRES ORTIZ RAFAELRICARDO;FERRANDEZ MARTINEZ LUISA MARIA;CORTES RUBIRA MANUEL. Datos registrales. T 35469 , F 143, S 8, H M610939, I/A 9 (29.03.17).
24 de Marzo de 2017Otros conceptos: MARIO ALONSO AYALA TRANSMITE SUS PARTICIPACIONES 1 A 29 Y 31 A 297 A LOS SOCIOS INSCRITOSY PUBLICADOS EN LA INSCRIPCION 8陋. Datos registrales. T 33949 , F 40, S 8, H M 610939, I/A 8 ( 9.03.17).
21 de Marzo de 2017Nombramientos. Soc.Prof.: SENTI DOMENECH ANTONIO;MATI LON BALBINA;CAMBRA GRAS JOSE MANUEL;PEREZ MI脩ANARICARD;BASART SERRALLONGA LUIS;LOBAO ANDRES YOLANDA;FERNANDEZ DE PEDRO FRANCISCO;CAMPO VALLEJOJUAN FRANCISCO;CASA脩AS RODRIGUEZ RUPERTO;TORMO SANTONJA GONZALO;VALLDECABRES ORTIZ RAFAEL;CORTESROYO JUAN-JOSE;CORTES CRESPO FRANCISCO JAVIER;GRACIA ESTEVEZ ROBERTO;FANLO JUSTE PEDROMARIA;CAMBRA YA脩EZ ANTONIO;COMPANYS BELVER ALFONS;DE LA CRUZ BLAZQUEZ JOSE LUIS;GALIPIENSO ANGLESJOSE LUIS;CORTES RUBIRA MANUEL;DELGADO MONTERO JOSE IGNACIO;DEL VALLE SCHAAN MARIA CELINA;SAEZCASTRO DANIEL;PARRA GOMEZ RAMON;SAUCA CANO JOSE IGNACIO;GARRIDO CACERES JOSE LUIS;SANCHEZ BLEDAGARCIA PILAR;PICAZO GONZALEZ PABLO FRANCISCO;GOMEZ VALVERDE ANTONIO;AUREN HOLDING SP SLP. Datosregistrales. T 33949 , F 40, S 8, H M 610939, I/A 8 ( 9.03.17).
20 de Febrero de 2017Nombramientos. Auditor: BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 33949 , F 39, S 8, H M 610939, I/A 7(13.02.17).
19 de Diciembre de 2016Modificaciones estatutarias. 11. Funcionamiento Junta General.- Modificaci贸n del art铆culo 11潞 de los estatutos referente a la JuntaGeneral.. Datos registrales. T 33949 , F 39, S 8, H M 610939, I/A 6 ( 9.12.16).
16 de Agosto de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 637.170,00 Euros. Resultante Suscrito: 640.170,00 Euros. Datos registrales. T 33949 , F 36, S 8, HM 610939, I/A 5 ( 3.08.16).
19 de Mayo de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONTALBAN MASEDA FERNANDO;GALIPIENSO ANGLES JOSE LUIS;PEREZ MI脩ANARICARD;SENTI DOMENECH ANTONIO;CAMBRA GRAS JOSE MANUEL;FERNANDEZ DE PEDRO FRANCISCO;CASA脩ASRODRIGUEZ RUPERTO;GARRIDO CACERES JOSE LUIS;PICAZO GONZALEZ PABLO FRANCISCO;SERRANO CLAMAGIRANDPABLO;TORMO SANTONJA GONZALO;VALLDECABRES ORTIZ RAFAEL RICARDO;CORTES RUBIRA MANUEL;FERRANDEZMARTINEZ LUISA MARIA. Datos registrales. T 33949 , F 34, S 8, H M 610939, I/A 4 ( 9.05.16).
06 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALONSO AYALA MARIO. Nombramientos. Adm. Solid.: BARGALLO FERRER JOSEMARIA;PICAZO GONZALEZ JULIO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 33949 , F 33, S 8, H M 610939, I/A 3 (30.03.16).
05 de Abril de 2016Otros conceptos: TRANSMISION DE LA PARTICIPACION NUMERO 298 AL SOCIO PROFESIONAL DON JOSE MARIABARGALLO FERRER TRANSMISION DE LA PARTICIPACION NUMERO 299 AL SOCIO PROFESIONAL DON JULIO PICAZOGONZALEZ. Datos registrales. T 33949 , F 33, S 8, H M 610939, I/A 2 (29.03.16).
21 de Octubre de 2015Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 6.08.15. Objeto social: Constituye el objeto social exclusivo de la Sociedad el ejercicio encom煤n de las siguientes actividades profesionales: a). La prestaci贸n de los servicios profesionales propios de la abogac铆a y de loseconomistas, incluyendo la mediaci贸n y la actuaci贸n en arbitrajes. b). El objeto social de .. Domicilio: AVDA GENERAL PERON 38(MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: ALONSO AYALA MARIO. Datos registrales. T 33949 , F 31, S8, H M 610939, I/A 1 (14.10.15).