Actos BORME de Auren Auditores Sp Slp
13 de Diciembre de 2023Nombramientos. Consejero: MONTES GALNARES CRISTOBAL. Datos registrales. T 42679 , F 164, S 8, H M 608799, I/A 56 (4.12.23).
22 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: JUAN PICO FERNANDO. Datos registrales. T 42679 , F 164, S 8, H M 608799, I/A 55 (15.11.23).
06 de Noviembre de 2023Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 23陋 el socio profesional PAGOLA SIERRA JOSE MARIA, siendo lo correctoPAGOLA SERRA JOSE MARIA. Datos registrales. T 33829 , F 219, S 8, H M 608799, I/A 23 ( 7.01.20).
10 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: CABRERA SANCHEZ JUAN JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: BLAZQUEZ SEVILLANOPATRICIA;ARMAS BRISSON YAIZA. Datos registrales. T 42679 , F 164, S 8, H M 608799, I/A 54 ( 3.08.23).
16 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: AGUI脩AGA SANTOS GIANINA;ARANAGA ELORRIAGA CAROLINA;FERRANDIZ RUBIOJAIME;GARCIA BURGUILLO ANA BELEN;PEINADO DORADO LUIS;TERUEL YA脩EZ JOSE MANUEL;TORNOS RAMIREZEMILIO;VAL DOMINGUEZ VERONICA. Datos registrales. T 42679 , F 163, S 8, H M 608799, I/A 53 ( 8.05.23).
29 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: FERRANDIZ RUBIO JAIME. Datos registrales. T 42679 , F 163, S 8, H M 608799, I/A 52 (22.11.22).
31 de Mayo de 2022Reelecciones. Auditor: BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 42679 , F 163, S 8, H M 608799, I/A 51(24.05.22).
26 de Mayo de 2022Revocaciones. Soc.Prof.: GOMEZ VALVERDE ANTONIO. Otros conceptos: Don Antonio Gomez Valverde vende la participacionsocial numero 299 de su propiedad a la sociedad " AUREN HOLDING SP SLP". Datos registrales. T 42679 , F 162, S 8, H M 608799,I/A 49 (19.05.22).
Nombramientos. Apoderado: AGUI脩AGA SANTOS GIANINA. Datos registrales. T 42679 , F 162, S 8, H M 608799, I/A 50(19.05.22).
03 de Mayo de 2022Nombramientos. Soc.Prof.: ARANAGA ELORRIAGA CAROLINA;BLAZQUEZ SEVILLANO PATRICIA. Ampliaci贸n de capital.Capital: 10,00 Euros. Resultante Suscrito: 488.150,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 10,00 Euros. Resultante Suscrito:488.160,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5潞.-. Capital social.-. Art铆culo de los estatutos: 5潞.-. Capitalsocial.-. Datos registrales. T 42679 , F 161, S 8, H M 608799, I/A 48 (25.04.22).
24 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALCAIDE GOMEZ ANTONIO MANUEL. Datos registrales. T 42679 , F 161, S 8, H M 608799, I/A 47(17.02.22).
11 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ENCISO MONICA;GRACIA ESTEVEZ ROBERTO. Datos registrales. T 40547 , F 59, S8, H M 608799, I/A 46 ( 4.02.22).
29 de Noviembre de 2021Otros conceptos: MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL Y CESE DEL SOCIO PROFESIONAL, DON RAFAEL LLUNA VILLAR.-Datos registrales. T 40547 , F 58, S 8, H M 608799, I/A 45 (22.11.21).
26 de Noviembre de 2021Revocaciones. Soc.Prof.: ESTEBAN COMAMALA IGNACIO. Otros conceptos: Transmisi贸n de la participaci贸n n煤mero 293, a lasociedad "Auren Auditores SP SLP", que la adquiere en Autocartera. Datos registrales. T 40547 , F 58, S 8, H M 608799, I/A 44(19.11.21).
05 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apoderado: AGUI脩AGA SANTOS GIANINA. Datos registrales. T 40547 , F 58, S 8, H M 608799, I/A 43 (28.10.21).
01 de Octubre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CORTES RUBIRA MANUEL;FERNANDEZ ENCISO MONICA. Apo.Man.Soli: BARCOS BARCOS SILVIA.Datos registrales. T 40547 , F 57, S 8, H M 608799, I/A 42 (24.09.21).
24 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: ESTEBAN COMAMALA IGNACIO;LLUNA VILLAR RAFAEL. Datos registrales. T 40547 , F 57, S 8, H M608799, I/A 41 (17.09.21).
24 de Mayo de 2021Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 10, 11, 15 Y 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 40547 , F 55, S 8, H M 608799, I/A 40 (14.05.21).
19 de Mayo de 2021Nombramientos. Soc.Prof.: BENAVENT TRENADO ELENA. Otros conceptos: Compraventa de la participaci贸n social n煤mero 291a favor de la sociedad do帽a Elena Benavent Trenado, y su alta como socio profesional. Datos registrales. T 40547 , F 55, S 8, H M608799, I/A 39 (12.05.21).
16 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: VAL DOMINGUEZ VERONICA. Datos registrales. T 40547 , F 55, S 8, H M 608799, I/A 38 ( 9.04.21).
15 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: SOLOAGA MORALES RAFAEL. Datos registrales. T 40547 , F 54, S 8, H M 608799, I/A 37 (8.02.21).
28 de Enero de 2021Nombramientos. Apoderado: ARMAS BRISSON YAIZA. Datos registrales. T 40547 , F 54, S 8, H M 608799, I/A 36 (21.01.21).
11 de Diciembre de 2020Revocaciones. Soc.Prof.: BARRIONUEVO CASTILLO FRANCISCO JAVIER. Otros conceptos: compraventa de la participaci贸nsocial n煤mero 291 a favor de la sociedad "AUREN HOLDING SP SLP"; EXCLUSION DE DON FRANCISCO JAVIER BARRIONUEVOCASTILLO como SOCIO PROFESIONAL. Datos registrales. T 40547 , F 54, S 8, H M 608799, I/A 35 ( 2.12.20).
10 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: BENAVENT TRENADO ELENA. Datos registrales. T 40547 , F 53, S 8, H M 608799, I/A 34(30.10.20).
27 de Julio de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ MARTINEZ LUISA MARIA. Datos registrales. T 40547 , F 51, S 8, H M 608799, I/A 32(20.07.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARCOS BARCOS SILVIA. Datos registrales. T 40547 , F 52, S 8, H M 608799, I/A 33 (20.07.20).
06 de Julio de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: PAGOLA SERRA JOSE MARIA;MU脩OZ RUIZ FELIX DANIEL;BUSTAMANTE LEON JESUS. Datosregistrales. T 40547 , F 50, S 8, H M 608799, I/A 31 (29.06.20).
22 de Junio de 2020Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ BURGOS ALEJANDRO;RAMOS REY JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 33829 , F 225,S 8, H M 608799, I/A 30 (15.06.20).
08 de Mayo de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: CANTERA HERRERO FRANCISCO JAVIER;SAEZ CASTRO DANIEL;BARGALLO FERRER JOSEMARIA;CATALAN BLASCO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 33829 , F 224, S 8, H M 608799, I/A 29 (30.04.20).
04 de Marzo de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: MONTSERRAT QUEROL MARIA CARMEN. Datos registrales. T 33829 , F 223, S 8, H M 608799, I/A 27(26.02.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: FILIU RODRIGUEZ PABLO. Nombramientos. Apoderado: BLAZQUEZ SEVILLANO PATRICIA;TORNOSRAMIREZ EMILIO;PEINADO DORADO LUIS;GARCIA BURGUILLO ANA BELEN;CIUDAD REAL CALDERON RICARDO;ROELNIETO IAGO;AGUI脩AGA SANTOS GIANINA. Datos registrales. T 33829 , F 223, S 8, H M 608799, I/A 28 (26.02.20).
25 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: GOMEZ VALVERDE ANTONIO. Datos registrales. T 33829 , F 221, S 8, H M 608799, I/A 25(18.02.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: BARRIONUEVO CASTILLO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALCAIDE GOMEZANTONIO MANUEL. Datos registrales. T 33829 , F 222, S 8, H M 608799, I/A 26 (18.02.20).
16 de Enero de 2020Nombramientos. Apoderado: ALONSO AYALA MARIO;MONTALBAN MASEDA FERNANDO;GALIPIENSO ANGLES JOSE LUIS.Datos registrales. T 33829 , F 220, S 8, H M 608799, I/A 24 ( 9.01.20).
14 de Enero de 2020Nombramientos. Soc.Prof.: PAGOLA SIERRA JOSE MARIA;MU脩OZ RUIZ FELIX DANIEL;BUSTAMANTE LEON JESUS. Otrosconceptos: Transmisi贸n por parte del socio profesional Auren Holding SP, SLP de una participaci贸n, la n煤mero 45.553, al socioprofesional don Jos茅 Mar铆a Pagola Serra. Transmisi贸n por parte del socio profesional Auren Holding SP, SLP de una participaci贸n, lan煤mero 45.554, al socio profesional don Felix Daniel Mu帽oz Ruiz. Transmisi贸n por parte del socio profesional Auren Holding SP, SLPde una participaci贸n, la n煤mero 45.555, al socio profesional don Jes煤s Bustamante Le贸n. Datos registrales. T 33829 , F 219, S 8, HM 608799, I/A 23 ( 7.01.20).
12 de Diciembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 32.590,00 Euros. Resultante Suscrito: 488.140,00 Euros. Datos registrales. T 33829 , F 217, S 8, HM 608799, I/A 22 ( 3.12.19).
30 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ALONSO AYALA MARIO;GOMEZ VALVERDE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: NAVACANO RAFAEL. Presidente: NAVA CANO RAFAEL. Consejero: LOPEZ VAZQUEZ JULIO. Secretario: LOPEZ VAZQUEZ JULIO.Consejero: CATALAN BLASCO MIGUEL ANGEL;JIMENEZ MARTIN ANA ISABEL;CABRERA SANCHEZ JUAN JOSE. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T33829 , F 217, S 8, H M 608799, I/A 21 (23.08.19).
02 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Soc.Prof.: MONSERRAT QUEROL MARIA DEL CARMEN;FILIU RODRIGUEZ PABLO. Nombramientos.Soc.Prof.: SU脩ER ADROVER PETRA;GELABERT MORRO MIGUEL FRANCESC. Otros conceptos: El socio MONSERRATQUEROL MARIA DEL CARMEN transmite un n煤mero de 1 participaciones al socio SU脩ER ADROVER PETRA. El socio FILIURODRIGUEZ PABLO transmite un n煤mero de 1 participaciones al socio GELABERT MORRO MIGUEL FRANCESC. Datosregistrales. T 33829 , F 216, S 8, H M 608799, I/A 20 (25.06.19).
04 de Junio de 2019Otros conceptos: Inserci贸n en la p谩gina web del proyecto de segregaci贸n. Datos registrales. T 33829 , F 91, S 8, H M 608799, I/A1-M (28.05.19).
28 de Marzo de 2019Reelecciones. Auditor: BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 33829 , F 216, S 8, H M 608799, I/A 19(21.03.19).
04 de Febrero de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 9.310,00 Euros. Resultante Suscrito: 455.550,00 Euros. Datos registrales. T 33829 , F 213, S 8, HM 608799, I/A 18 (28.01.19).
07 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ BURGOS ALEJANDRO;RAMOS REY JOSE ANTONIO;MORENO LARA LUISALBERTO;CASTRO HERNANDEZ PEDRO;REALES SANCHEZ ANGEL. Datos registrales. T 33829 , F 213, S 8, H M 608799, I/A 17(29.11.18).
26 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL;SU脩ER ADROVER PETRA;GELABERT MORRO MIGUELFRANCESC. Datos registrales. T 33829 , F 211, S 8, H M 608799, I/A 16 (19.11.18).
23 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Soc.Prof.: CASTRO HERNANDEZ PEDRO;MORENO LARA LUIS ALBERTO;REALES SANCHEZ ANGEL.Nombramientos. Soc.Prof.: GONZALEZ VILLALONGA FERNANDO;CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL. Otros conceptos:Transmisi贸n por parte del socio profesional D. Pedro Castro Hern谩ndez de una participaci贸n, la n煤mero 294, al socio profesional D.Fernando Gonz谩lez Villalonga. Transmisi贸n por parte del socio profesional D. Angel Reales S谩nchez de una participaci贸n, la n煤mero279, al socio profesional D. Miguel Angel Crespo Alvarez. Transmisi贸n por parte del socio profesional D. Luis Alberto Moreno Lara deuna participaci贸n, la n煤mero 270, al socio profesional Auren Holding SP SLP. Datos registrales. T 33829 , F 210, S 8, H M 608799,I/A 15 (14.11.18).
29 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ BURGOS ALEJANDRO;RAMOS REY JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 33829 , F209, S 8, H M 608799, I/A 14 (22.10.18).
09 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ VILLALONGA FERNANDO. Datos registrales. T 33829 , F 207, S 8, H M 608799, I/A13 ( 2.02.18).
02 de Enero de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 14.670,00 Euros. Resultante Suscrito: 446.240,00 Euros. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n dela p谩gina web corporativa: http://intranet.auren.es/. Datos registrales. T 33829 , F 203, S 8, H M 608799, I/A 12 (20.12.17).
13 de Junio de 2017Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 11潞 de los Estatutos Sociales. . Datos registrales. T 33829 , F 202, S 8, H M608799, I/A 11 ( 6.06.17).
14 de Febrero de 2017Nombramientos. Auditor: BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 33829 , F 202, S 8, H M 608799, I/A 10 (6.02.17).
10 de Febrero de 2017Otros conceptos: El socio ALONSO AYALA MARIO transmite un n煤mero de 269 participaciones al socio AUREN HOLDING SP SLP.Datos registrales. T 33829 , F 202, S 8, H M 608799, I/A 9 ( 2.02.17).
05 de Septiembre de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: MONTALBAN MASEDA FERNANDO;GALIPIENSO ANGLES JOSE LUIS;BARRIONUEVO CASTILLOFRANCISCO JAVIER;SANCHEZ BURGOS ALEJANDRO;SILVESTRE PICADO MARIA MERCEDES;RAMOS REY JOSEANTONIO;HERRAIZ LINARES CRISTINA;NAVA CANO RAFAEL;CATALAN BLASCO MIGUEL ANGEL;BAILACH ASPA MARIAEUGENIA;MORENO LARA LUIS ALBERTO;IRIGORAS OLABARRIA JUAN IGNACIO;CABRERA SANCHEZ JUAN JOSE;JARAMILLOMELLADO JUAN JOSE;ENRIQUEZ MARI脩O ENRIQUE ALFREDO;DELGADO CLAVERSO JOSE;MIRO GONZALVEZ FRANCISCOJOSE;PINEDO Y DE NORIEGA JOSE MARIA;FILIU RODRIGUEZ PABLO;ESTEBAN COMAMALA IGNACIO;DE JUAN SANCHEZMARIA CRISTINA;CASTRO HERNANDEZ PEDRO;REALES SANCHEZ ANGEL;LLUNA VILLAR RAFAEL;MONDRAGON PE脩AFRANCISCO;SOLOAGA MORALES RAFAEL;FEIJO ALVAREZ ANDRES;VILABOA MARTINEZ MARIA CONCEPCION;CORTESRUBIRA MANUEL;FERNANDEZ ENCISO MONICA;FERRANDEZ MARTINEZ LUISA MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.:MONTALBAN MASEDA FERNANDO;GALIPIENSO ANGLES JOSE LUIS;MONTSERRAT QUEROL MARIA CARMEN;MESTRE VIDALMONTSERRAT;BARRIONUEVO CASTILLO FRANCISCO JAVIER;SANCHEZ BURGOS ALEJANDRO;SILVESTRE PICADO MARIAMERCEDES;RAMOS REY JOSE ANTONIO;HERRAIZ LINARES CRISTINA;NAVA CANO RAFAEL;CATALAN BLASCO MIGUELANGEL;BAILACH ASPA MARIA EUGENIA;MORENO LARA LUIS ALBERTO;IRIGORAS OLABARRIA JUAN IGNACIO;CABRERASANCHEZ JUAN JOSE;DIAZ PERALTA MARIA DE LOS ANGELES;JARAMILLO MELLADO JUAN JOSE;ENRIQUEZ MARI脩OENRIQUE ALFREDO;LOPEZ VAZQUEZ JULIO;MIRO GONZALVEZ FRANCISCO JOSE;FILIU RODRIGUEZ PABLO;ESTEBANCOMAMALA IGNACIO;DE JUAN SANCHEZ MARIA CRISTINA;CASTRO HERNANDEZ PEDRO;REALES SANCHEZANGEL;MONTES GALNARES CRISTOBAL;LLUNA VILLAR RAFAEL;MONDRAGON PE脩A FRANCISCO;SOLOAGA MORALESRAFAEL;FEIJO ALVAREZ ANDRES;VILABOA MARTINEZ MARIA CONCEPCION;CORTES RUBIRA MANUEL;FERNANDEZ ENCISOMONICA;JIMENEZ MARTIN ANA ISABEL;FERNANDEZ MARTINEZ LUISA MARIA. Datos registrales. T 33829 , F 199, S 8, H M608799, I/A 8 (26.08.16).
16 de Agosto de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 428.570,00 Euros. Resultante Suscrito: 431.570,00 Euros. Datos registrales. T 33829 , F 97, S 8, HM 608799, I/A 7 ( 3.08.16).
19 de Mayo de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONTALBAN MASEDA FERNANDO;GALIPIENSO ANGLES JOSE LUIS;BARRIONUEVOCASTILLO FRANCISCO JAVIER;SANCHEZ BURGOS ALEJANDRO;SILVESTRE PICADO MARIA MERCEDES;RAMOS REY JOSEANTONIO;HERRAIZ LINARES CRISTINA;NAVA CANO RAFAEL;CATALAN BLASCO MIGUEL ANGEL;BAILACH ASPA MARIAEUGENIA;MORENO LARA LUIS ALBERTO;IRIGORAS OLABARRIA JUAN IGNACIO;CABRERA SANCHEZ JUAN JOSE;JARAMILLOMELLADO JUAN JOSE;ENRIQUEZ MARI脩O ENRIQUE ALFREDO;DELGADO CLAVERSO JOSE;MIRO GONZALVEZ FRANCISCOJOSE;PINEDO Y DE NORIEGA JOSE MARIA;FILIU RODRIGUEZ PABLO;ESTEBAN COMAMALA IGNACIO;DE JUAN SANCHEZMARIA CRISTINA;CASTRO HERNANDEZ PEDRO;REALES SANCHEZ ANGEL;LLUNA VILLAR RAFAEL;MONDRAGON PE脩AFRANCISCO;SOLOAGA MORALES RAFAEL;FEIJO ALVAREZ ANDRES;VILABOA MARTINEZ MARIA CONCEPCION;CORTESRUBIRA MANUEL;FERNANDEZ ENCISO MONICA;FERRANDEZ MARTINEZ LUISA MARIA. Datos registrales. T 33829 , F 92, S 8,H M 608799, I/A 5 ( 9.05.16).
21 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALONSO AYALA MARIO. Nombramientos. Adm. Solid.: ALONSO AYALA MARIO;GOMEZVALVERDE ANTONIO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios.Datos registrales. T 33829 , F 92, S 8, H M 608799, I/A 4 (11.03.16).
18 de Marzo de 2016Otros conceptos: TRANSMISION DE LA PARTICIPACION NUMERO 299 AL SOCIO PROFESIONAL DON ANTONIO GOMEZVALVERDE. Datos registrales. T 33829 , F 92, S 8, H M 608799, I/A 3 (11.03.16).
12 de Noviembre de 2015Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 11潞 de los estatutos sociales.- Junta general. Datos registrales. T 33829 , F91, S 8, H M 608799, I/A 2 ( 4.11.15).
18 de Septiembre de 2015Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 5.08.15. Objeto social: a) La prestaci贸n de servicios de auditor铆a de cuentas, consistentesen la realizaci贸n de estudios, informes y dict谩menes relacionados con el examen de documentos y contabilidades mercantiles, yservicios relacionados con la auditor铆a de cuentas. b)La prestaci贸n de servicios propios de economistas .. Domicilio: AVDA GENERALPERON 38 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: ALONSO AYALA MARIO. Datos registrales. T33829 , F 89, S 8, H M 608799, I/A 1 (11.09.15).