Actos BORME de Ausur Servicios De La Autopista Sa
13 de Diciembre de 2023Modificaciones estatutarias. Art铆culo 12潞. Juntas Generales. Posibilidad de celebraci贸n de forma telem谩tica. Art铆culo 19.Funcionamiento del consejo. Posibilidad de celebraci贸n de sesiones de forma telem谩tica. Datos registrales. T 4367 , F 38, S 8, H A71189, I/A 26 ( 4.12.23).
23 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Secretario: MU脩OZ CALVO JOSE LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: GALVEZ FERNANDEZ MARIA.Datos registrales. T 4367 , F 38, S 8, H A 71189, I/A 25 (12.08.22).
16 de Abril de 2021Nombramientos. Con.Delegado: PRALESA CONCESIONES SL. Datos registrales. T 3493 , F 152, S 8, H A 71189, I/A 23 (8.04.21).
26 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PRALESA CONCESIONES SL. Reelecciones. Presidente: PRALESA CONCESIONES SL.Consejero: PRALESA CONCESIONES SL;GALVEZ FERNANDEZ LUIS;GALVEZ FERNANDEZ ALICIA;EMPRENDIMIENTOS YDESARROLLOS CONCESIONALES SL;PROMOCIONES AGRARIAS DE LEVANTE SA;GRUPO CORPORATIVO FUERTES SL.Datos registrales. T 3493 , F 152, S 8, H A 71189, I/A 22 (18.02.21).
29 de Mayo de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.885.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 715.000,00 Euros. Reducci贸n de capital.Importe reducci贸n: 275.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 440.000,00 Euros. Cambio de objeto social. La explotaci贸n de 谩reas deservicios incluida el almacenamiento, distribuci贸n y venta de toda clase de combustibles. La realizaci贸n de todo tipo de obras p煤blicaso privadas. La realizaci贸n de actividades de promoci贸n inmobiliaria. El mantenimiento y conservaci贸n de parques y jardines, inmuebles,y. Datos registrales. T 3493 , F 152, S 8, H A 71189, I/A 21 (21.05.18).
19 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: SAEZ PONTE MARIA TERESA. Revocaciones. Apo.Manc.: GALVEZ FERNANDEZ LUIS;GALVEZFERNANDEZ ALICIA;GALVEZ FERNANDEZ MARIA;FUERTES FERNANDEZ TOMAS;PETIT ASUMENDI JAVIER;CASTRESANASANCHEZ LUIS FELIPE;RODRIGUEZ ROMO JOSE LUIS;VAZQUEZ MORENO ENRIQUE;YEBRA SOLA MANUEL. Datosregistrales. T 3493 , F 151, S 8, H A 71189, I/A 20 (10.10.17).
17 de Febrero de 2016Nombramientos. Presidente: PRALESA CONCESIONES SL. Con.Delegado: PRALESA CONCESIONES SL. Datos registrales. T3493 , F 151, S 8, H A 71189, I/A 18 ( 9.02.16).
15 de Febrero de 2016Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: PLODER UICESA SA;PLODER CONCESIONES SA;PRALESA
30 de Julio de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN SARDINA FRANCISCO;RODRIGUEZ ARRANZ FLORENTINO. Apo.Manc.: MARTIN SARDINAFRANCISCO;RODRIGUEZ ARRANZ FLORENTINO. Datos registrales. T 3493 , F 150, S 8, H A 71189, I/A 15 (23.07.13).
27 de Febrero de 2012Nombramientos. Consejero: CAJA DE AHORROS DE MURCIA. Datos registrales. T 2553 , F 108, S 8, H A 71189, I/A 14(15.02.12).
24 de Diciembre de 2010Nombramientos. Presidente: GALVEZ MURCIA LUIS. Reelecciones. Secretario: MU脩OZ CALVO JOSE LUIS. Datos registrales.T 2553 , F 108, S 8, H A 71189, I/A 13 (14.12.10).
23 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: GALVEZ FERNANDEZ MARIA;GALVEZ MURCIA LUIS;PETIT ASUMENDI JAVIER;GALVEZFERNANDEZ ALICIA;GALVEZ FERNANDEZ LUIS. Presidente: GALVEZ MURCIA LUIS. Consejero: PLODER UICESA SA;PLODERCONCESIONES SA;AUDECA SL;GRUPO CORPORATIVO FUERTES SL;CAJA DE AHORROS DE MURCIA;CAJAMAR CAJARURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO;GARCIA LOPEZ EDUARDO. Nombramientos. Consejero: GALVEZ MURCIALUIS;GALVEZ FERNANDEZ ALICIA;GALVEZ FERNANDEZ MARIA;GALVEZ FERNANDEZ LUIS;PETIT ASUMENDI JAVIER;INFUCAPITAL SRC DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA;PLODER UICESA SA;PLODER CONCESIONES SA;GRUPO EMPRESARIALPLODER SL;GARCIA LOPEZ EDUARDO;CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO. Datos registrales. T2553 , F 108, S 8, H A 71189, I/A 12 (13.12.10).
15 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO MORENO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: GARCIA LOPEZ EDUARDO.Datos registrales. T 2553 , F 108, S 8, H A 71189, I/A 11 ( 2.12.09).
17 de Marzo de 2009Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 550.000,00 Euros. Datos registrales. T 2553 , F 108, S 8, H A 71189, I/A 10 (5.03.09).