Buscador CIF Logo

Actos BORME Autocares Beltran Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Autocares Beltran Sa

Actos BORME Autocares Beltran Sa - A28705564

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Autocares Beltran Sa con CIF A28705564

馃敊 Perfil de Autocares Beltran Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Autocares Beltran Sa

11 de Agosto de 2022
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32753 , F 201, S 8, H M 26526, I/A 33 ( 4.08.22).

13 de Septiembre de 2021
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32753 , F 201, S 8, H M 26526, I/A 32 ( 6.09.21).

24 de Agosto de 2020
Nombramientos. Con.Delegado: DE CASTRO SANZ JULIAN. Reelecciones. Consejero: DEL CAMPO OCEJO JAVIERALEJANDRO;DE CASTRO SANZ JULIAN. Presidente: DE CASTRO SANZ JULIAN. Consejero: DE CASTRO SANZ ANTONIO.Secretario: DEL CAMPO OCEJO JAVIER ALEJANDRO. Datos registrales. T 32753 , F 201, S 8, H M 26526, I/A 31 (17.08.20).

06 de Agosto de 2020
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32753 , F 200, S 8, H M 26526, I/A 30 (30.07.20).

06 de Agosto de 2019
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32753 , F 200, S 8, H M 26526, I/A 29 (30.07.19).

03 de Noviembre de 2016
Modificaciones estatutarias. Aprobaci贸n de nuevo texto consolidado de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 32753 , F 196,S 8, H M 26526, I/A 28 (26.10.16).

04 de Mayo de 2016
Revocaciones. Auditor: ESTEO SANCHEZ FRANCISCO. Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T32753 , F 196, S 8, H M 26526, I/A 27 (26.04.16).

04 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apoderado: SANTA MARTA PASTRANA ALVARO. Datos registrales. T 32753 , F 196, S 8, H M 26526, I/A 26(25.02.16).

02 de Febrero de 2016
Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 25 el nombramiento como secretario dedon ANTONIO DE CASTRO SANZ siendolo correcto don JAVIER ALEJANDRO DEL CAMPO OCEJO. Datos registrales. T 32753 , F 196, S 8, H M 26526, I/A 25 (18.12.15).

29 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: AUTOCARES JULIAN DE CASTRO SA. Representan: HERRANZ ARRANZ JUAN CARLOS;DECASTRO SANZ JULIAN JESUS ANTONIO. Presidente: AUTOCARES JULIAN DE CASTRO SA. Secretario: AUTOCARES HERRANZSL. Consejero: VILLORIA VALERA ALBERTO. Cons.Del.Sol: AUTOCARES JULIAN DE CASTRO SA;AUTOCARES HERRANZ SL.Consejero: AUTOCARES HERRANZ SL. Nombramientos. Consejero: DE CASTRO SANZ JULIAN. Presidente: DE CASTRO SANZJULIAN. Cons.Del.Sol: DE CASTRO SANZ JULIAN. Consejero: DE CASTRO SANZ ANTONIO. Secretario: DE CASTRO SANZANTONIO. Datos registrales. T 32753 , F 196, S 8, H M 26526, I/A 25 (18.12.15).

18 de Febrero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: BELTRAN NOGAL FELIPE;BELTRAN GAMELLA ANA;BELTRAN VEIGA EUGENIO;VILLENABONACASA SANTIAGO;ACEDOS BELTRAN PABLO;GAMONAL BELTRAN MARIA ANTONIA. Secretario: BELTRAN VEIGAEUGENIO. Presidente: BELTRAN NOGAL FELIPE. Con.Delegado: ACEDOS BELTRAN PABLO. Cons.Del.Sol: BELTRAN VEIGAEUGENIO. Nombramientos. Representan: HERRANZ ARRANZ JUAN CARLOS;DE CASTRO SANZ JULIAN JESUS ANTONIO.Consejero: AUTOCARES HERRANZ SL;AUTOCARES JULIAN DE CASTRO SA. Presidente: AUTOCARES JULIAN DE CASTRO SA.Secretario: AUTOCARES HERRANZ SL. Datos registrales. T 1425 , F 194, S 8, H M 26526, I/A 23 ( 9.02.15).

17 de Febrero de 2015
Nombramientos. Consejero: VILLORIA VALERA ALBERTO;DEL CAMPO OCEJO JAVIER ALEJANDRO. Cons.Del.Sol:AUTOCARES JULIAN DE CASTRO SA;AUTOCARES HERRANZ SL. Otros conceptos: SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO PORCOOPTACION DE LOS CONSEJEROS "AUTOCARES JULIAN DE CASTRO SA" -TAMBIEN NOMBRADO PRESIDENTE- Y"AUTOCARES HERRANZ SL" - TAMBIEN NOMBRADO SECRETARIO. Datos registrales. T 32753 , F 195, S 8, H M 26526, I/A 24 (9.02.15).

30 de Abril de 2014
Reelecciones. Auditor: ESTEO SANCHEZ FRANCISCO. Aud.Supl.: GONZALEZ ROMERO SINFOROSO. Datos registrales. T 1425, F 194, S 8, H M 26526, I/A 22 (23.04.14).

29 de Abril de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: BELTRAN GAMELLA ADOLFO. Presidente: BELTRAN GAMELLA ADOLFO. Cons.Del.Sol: BELTRANGAMELLA ADOLFO. Nombramientos. Presidente: BELTRAN NOGAL FELIPE. Con.Delegado: ACEDOS BELTRAN PABLO. Datosregistrales. T 1425 , F 194, S 8, H M 26526, I/A 21 (14.04.14).

14 de Diciembre de 2012
Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL EL LANCHAR - NAVES 1 Y 2 (COLMENAR DEL ARROYO). Datos registrales. T1425 , F 193, S 8, H M 26526, I/A 20 (30.11.12).

28 de Junio de 2012
Ceses/Dimisiones. Presidente: BELTRAN GAMELLA ADOLFO. Consejero: BELTRAN NOGAL FELIPE;BELTRAN GAMELLAANA;BELTRAN GAMELLA ADOLFO. Con.Delegado: BELTRAN GAMELLA ADOLFO. Consejero: BELTRAN VEIGA EUGENIO.Secretario: BELTRAN VEIGA EUGENIO. Consejero: GAMONAL BELTRAN MARIA ANTONIA;VILLENA BONACASASANTIAGO;ACEDOS BELTRAN PABLO. Nombramientos. Consejero: BELTRAN GAMELLA ADOLFO. Presidente: BELTRANGAMELLA ADOLFO. Consejero: BELTRAN VEIGA EUGENIO. Secretario: BELTRAN VEIGA EUGENIO. Consejero: BELTRANGAMELLA ANA;BELTRAN NOGAL FELIPE;GAMONAL BELTRAN MARIA ANTONIA;VILLENA BONACASA SANTIAGO;ACEDOSBELTRAN PABLO. Cons.Del.Sol: BELTRAN GAMELLA ADOLFO;BELTRAN VEIGA EUGENIO. Datos registrales. T 1425 , F 192, S8, H M 26526, I/A 18 (18.06.12).

Nombramientos. Apoderado: SANTA MARTA PASTRANA ALVARO. Datos registrales. T 1425 , F 193, S 8, H M 26526, I/A 19(18.06.12).

12 de Agosto de 2011
Nombramientos. Auditor: ESTEO SANCHEZ FRANCISCO. Aud.Supl.: GONZALEZ ROMERO SINFOROSO. Datos registrales. T1425 , F 192, S 8, H M 26526, I/A 17 ( 1.08.11).

05 de Agosto de 2009
Nombramientos. Consejero: GAMONAL BELTRAN MARIA ANTONIA;VILLENA BONACASA SANTIAGO;ACEDOS BELTRANPABLO. Datos registrales. T 1425 , F 192, S 8, H M 26526, I/A 16 (24.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n