Actos BORME de Autocares Galisur Sa
10 de Diciembre de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 514, L 514, F 123, S 8, H PO 4496, I/A 22 (29.11.18).
18 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ RE脩ONES CELSO. Datos registrales. T 514, L 514, F 123, S 8, H PO 4496, I/A 21 (9.05.18).
18 de Agosto de 2016Reelecciones. Consejero: SESTELO TRONCOSO VICTOR;RODRIGUEZ RE脩ONES CELSO;RODRIGUEZ VIDAL JUANMANUEL;ALONSO RODRIGUEZ JOSE FELICIANO;GONZALEZ MARQUIER JOSE;ALONSO HERMIDA FRANCISCO JAVIER.Presidente: SESTELO TRONCOSO VICTOR. Vicepresid.: ALONSO RODRIGUEZ JOSE FELICIANO. Secretario: GONZALEZMARQUIER JOSE. Datos registrales. T 514, L 514, F 122, S 8, H PO 4496, I/A 20 ( 9.08.16).
25 de Noviembre de 2014Revocaciones. D. Gerente: MARTINEZ SOBREIRA MANUEL. Datos registrales. T 514, L 514, F 122, S 8, H PO 4496, I/A 19(14.11.14).
05 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: SESTELO TRONCOSO VICTOR. Secretario: RODRIGUEZ RE脩ONES CELSO. Nombramientos.Presidente: SESTELO TRONCOSO VICTOR. Vicepresid.: ALONSO RODRIGUEZ JOSE FELICIANO. Secretario: GONZALEZMARQUIER JOSE. Datos registrales. T 514, L 514, F 122, S 8, H PO 4496, I/A 18 (29.10.14).
30 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ ROUCO GABRIEL. Presidente: MARTINEZ ROUCO GABRIEL. Datos registrales. T514, L 514, F 122, S 8, H PO 4496, I/A 17 (23.10.14).
13 de Febrero de 2014Nombramientos. Consejero: ALONSO HERMIDA FRANCISCO JAVIER;GONZALEZ MARQUIER JOSE. Datos registrales. T 514, L514, F 121, S 8, H PO 4496, I/A 16 ( 3.02.14).
19 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: GONZALEZ GRANADA JOSE. Nombramientos. Secretario: RODRIGUEZ RE脩ONES CELSO.Datos registrales. T 514, L 514, F 121, S 8, H PO 4496, I/A 15 ( 7.12.12).
18 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO RIAL ANGEL. Datos registrales. T 514, L 514, F 121, S 8, H PO 4496, I/A 14 ( 9.11.11).