Actos BORME de Autocares Tejedor.h Sl
26 de Julio de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ CUESTA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 495 , F 12, S 8, H P 2535, I/A 28 (18.07.23).
21 de Enero de 2022Revocaciones. Apoderado: PESQUERA MATEO MARIANO. Datos registrales. T 495 , F 12, S 8, H P 2535, I/A 27 (12.01.22).
09 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: PESQUERA MATEO MARIANO. Datos registrales. T 495 , F 10, S 8, H P 2535, I/A 25 (30.06.21).
Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ LLORENTE JORGE. Datos registrales. T 495 , F 11, S 8, H P 2535, I/A 26 (30.06.21).
01 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: MARTIN DE POZUELO TRABA CRISTINA;TRABA ALVA MONICA PATRICIA;GARCIA PEREZMIRIAM;VELASCO REYES VICTORIANO;ALVAREZ MACIA LUIS MIGUEL;ALONSO MARTIN MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T495 , F 10, S 8, H P 2535, I/A 24 (24.06.21).
05 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUROL GESTION SL;TRABA AGUADO AVELINO;TRABA AGUADO MARIA CRISTINA;AGUADOBURGAZ MANUEL JUAN. Cons.Del.Sol: TRABA AGUADO AVELINO. Presidente: TRABA AGUADO AVELINO. Secretario: AGUADOBURGAZ MANUEL JUAN. Cons.Del.Sol: AGUADO BURGAZ MANUEL JUAN. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPOEMPRESARIAL MAT SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.Datos registrales. T 495 , F 10, S 8, H P 2535, I/A 23 (25.03.21).
26 de Noviembre de 2020Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de objeto social. 1) La Actividad de transporteterrestre urbano y suburbano de pasajeros de mercancías por jarretera (CNAE 4931) como actividad principal de la Compañía, ademásla actividad dé transporte de mercancías por carretera, la de Operador de Transporte de Mercancía, incluida la mediación ysubcontrataci. Datos registrales. T 330 , F 12, S 8, H P 2535, I/A 22 (17.11.20).
24 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: BURGAZ RUIZ LEONOR. Nombramientos. Consejero: AGUROL GESTION SL. Datos registrales.T 330 , F 12, S 8, H P 2535, I/A 21 (13.08.20).
07 de Febrero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: TEJEDOR HERNANDO SANTIAGO. Datos registrales. T 330 , F 12, S 8, H P 2535, I/A 20 (30.01.18).
28 de Febrero de 2013Ampliación de capital. Capital: 100.006,40 Euros. Resultante Suscrito: 164.012,90 Euros. Datos registrales. T 330 , F 11, S 8, H P2535, I/A 19 (19.02.13).
09 de Agosto de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: TRABA DOMINGUEZ RAFAEL;PEREIRO CASTRO JOSE ALEJANDRO. Datos registrales. T 330 , F11, S 8, H P 2535, I/A 18 (29.07.11).
26 de Abril de 2010Cambio de domicilio social. C/ CAMPANEROS 4 - POLIGONO INDUSTRIAL SAN ANTOLIN (PALENCIA). Datos registrales. T330 , F 11, S 8, H P 2535, I/A 17 (13.04.10).
23 de Junio de 2009Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: LA REGIONAL VALLISOLETANA SA. Datos registrales. T 330 , F11, S 8, H P 2535, I/A 16 (12.06.09).
16 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: TRABA AGUADO FRANCISCO JAVIER. Cons.Del.Sol: TRABA AGUADO FRANCISCO JAVIER.Presidente: BURGAZ RUIZ LEONOR. Vicepresid.: TRABA AGUADO AVELINO. Nombramientos. Presidente: TRABA AGUADOAVELINO. Datos registrales. T 330 , F 11, S 8, H P 2535, I/A 15 ( 6.02.09).