Actos BORME de Autolineas Rubiocar Sociedad Limitada
16 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: RUBIO CASADO RIGOBERTO ANTONIO. Datos registrales. T 759 , F 39, S 8, H CU 9261, I/A 17 (9.11.23).
04 de Marzo de 2022Reelecciones. Auditor: PEREZ Y ASOCIADOS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 759 , F 39, S 8, H CU 9261, I/A 16(17.02.22).
21 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: RUBIO MARTINEZ ULPIANO. Nombramientos. Adm. Solid.: VALLADOLID LUCAS ANA MARIA.Datos registrales. T 759 , F 37, S 8, H CU 9261, I/A 14 (12.11.19).
Revocaciones. Apoderado: VALLADOLID LUCAS ANA MARIA;VERON PEREIRA RAMON. Apo.Sol.: VALLADOLID LUCAS ANAMARIA. Datos registrales. T 759 , F 38, S 8, H CU 9261, I/A 15 (12.11.19).
04 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: VERON PEREIRA RAMON. Datos registrales. T 668 , F 206, S 8, H CU 9261, I/A 13 (22.03.19).
14 de Marzo de 2019Reelecciones. Auditor: PEREZ Y ASOCIADOS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 668 , F 206, S 8, H CU 9261, I/A 12 (7.03.19).
22 de Septiembre de 2016Nombramientos. Auditor: PEREZ Y ASOCIADOS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 668 , F 205, S 8, H CU 9261, I/A 11 (8.09.16).
27 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apoderado: VALLADOLID LUCAS ANA MARIA. Datos registrales. T 626 , F 198, S 8, H CU 9261, I/A 10(17.11.14).
08 de Octubre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 210.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.510.000,00 Euros. Datos registrales. T 626 , F 196, S 8, HCU 9261, I/A 9 (29.09.14).
04 de Septiembre de 2013Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RUBIO CAR SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: RUBIO MARTINEZULPIANO;VALLADOLID LUCAS ANA MARIA;RUBIO MARTINEZ ELOY;GARCIA HERRERO JACOBO AGUSTIN;GARCIA HERREROFRANCISCO DE BORJA. Nombramientos. Adm. Solid.: RUBIO MARTINEZ ELOY;RUBIO MARTINEZ ULPIANO. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Administradores solidarios. Cambio dedomicilio social. AVDA DEL GENERALISIMO 95 (VILLARES DEL SAZ). Datos registrales. T 626 , F 195, S 8, H CU 9261, I/A 6(23.08.13).
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA HERRERO JACOBO AGUSTIN;RUBIO MARTINEZ ULPIANO. Datos registrales. T 626 , F 196,S 8, H CU 9261, I/A 7 (23.08.13).
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA SALMERON JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 626 , F 196, S 8, H CU 9261, I/A 8 (23.08.13).
23 de Octubre de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 180.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.300.000,00 Euros. Datos registrales. T 622 , F 225, S 8, HCU 9261, I/A 5 (10.10.12).
17 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: VALLADOLID LUCAS ANA MARIA;GARCIA SALMERON JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 622 , F221, S 8, H CU 9261, I/A 3 ( 3.09.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO MARTINEZ ULPIANO;GARCIA HERRERO JACOBO AGUSTIN. Datos registrales. T 622 , F223, S 8, H CU 9261, I/A 4 ( 3.09.12).
03 de Septiembre de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.060.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.120.000,00 Euros. Datos registrales. T 622 , F 218, S 8,H CU 9261, I/A 2 (21.08.12).
06 de Agosto de 2012Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 3.07.12. Objeto social: LA REALIZACION DE TRANSPORTE REGULAR, URBANO YDISCRECCIONAL DE VIAJEROS POR CARRETERA. ALQUILER DE VEHICULOS DE TODAS CLASES CON Y SIN CONDUCTOR,PRESTACION DE SERVICIOS DE CHOFERES, ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TALLER PARA LACONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS. Domicilio: C/ SAN PEDRO 39 (CUENCA). Capital: 60.000,00 Euros.Nombramientos. Adm. Mancom.: RUBIO MARTINEZ ELOY;RUBIO MARTINEZ ULPIANO;VALLADOLID LUCAS ANAMARIA;GARCIA HERRERO FRANCISCO DE BORJA;GARCIA HERRERO JACOBO AGUSTIN. Datos registrales. T 622 , F 208, S8, H CU 9261, I/A 1 1 (19.07.12).