Actos BORME de Autoliv Bki Sa
03 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6576, L 3880, F 70, S 8, H V 21108, I/A 82 (25.10.23).
02 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6576, L 3880, F 69, S 8, H V 21108, I/A 81 (25.10.22).
16 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6576, L 3880, F 69, S 8, H V 21108, I/A 80 ( 9.12.21).
18 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ANNIKO CARL HENRIK. Nombramientos. Consejero: HAGSTROM PER ARNE MIKAEL.Reelecciones. Consejero: BURGUEZ FREDERIC PIERRE. Datos registrales. T 6576, L 3880, F 69, S 8, H V 21108, I/A 79(11.11.21).
28 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: NAVARRO BONANAD JUAN ANTONIO;ORTEGA CIVICO ANA Mª. Apo.Sol.: ANTERO HANKECHRISTIAN HERBERT;MARTEN WIRENLIND PAR-OLA. Apo.Man.Soli: DE DIEGO ANTON LUIS. Apo.Manc.: ORTEGA CIVICO ANAMª;NAVARRO BONANAD JUAN ANTONIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE DIEGO ANTON LUIS. Datos registrales. T 6285, L3590, F 99, S 8, H V 21108, I/A 77 (21.09.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTEGA CIVICO ANA Mª. Datos registrales. T 6576, L 3880, F 67, S 8, H V 21108, I/A 78(21.09.20).
03 de Septiembre de 2020Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6285, L 3590, F 98, S 8, H V 21108, I/A 76 (26.08.20).
20 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTERO HANKE CHRISTIAN HERBERT. Presidente: ANTERO HANKE CHRISTIAN HERBERT.Nombramientos. Consejero: WIRENLIND PAR OLA. Presidente: WIRENLIND PAR OLA. Datos registrales. T 6285, L 3590, F 98, S8, H V 21108, I/A 75 (13.03.20).
15 de Enero de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: BOSCH FERRER EDUARDO. Apo.Manc.: BOSCH FERRER EDUARDO. Datos registrales. T 6285, L3590, F 98, S 8, H V 21108, I/A 74 ( 8.01.20).
23 de Diciembre de 2019Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6285, L 3590, F 98, S 8, H V 21108, I/A 73 (16.12.19).
27 de Junio de 2019Otros conceptos: Sufrido error en la escritura objeto de la inscripción 70ª al redactar la facultad número 3 concedida a losapoderados Don Christian Herber Antero Hanke y D. Par-Ola Marten Wirenlind. Datos registrales. T 6285, L 3590, F 98, S 8, H V21108, I/A 72 (20.06.19).
21 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE DIEGO ANTON LUIS. Apo.Manc.: ORTEGA CIVICO ANA Mª;BOSCH FERREREDUARDO;NAVARRO BONANAD JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 6285, L 3590, F 96, S 8, H V 21108, I/A 71 (13.05.19).
05 de Febrero de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: ANTERO HANKE CHRISTIAN HERBERT;MARTEN WIRENLIND PAR-OLA. Datos registrales. T 6285, L3590, F 95, S 8, H V 21108, I/A 70 (29.01.19).
12 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6285, L 3590, F 95, S 8, H V 21108, I/A 69 ( 4.12.18).
13 de Julio de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6285, L 3590, F 95, S 8, H V 21108, I/A 68 ( 6.07.18).
22 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: FOURRIER ISABELLE;WENDELS AMELIE MARIA. Presidente: FOURRIER ISABELLE.Nombramientos. Consejero: ANTERO HANKE CHRISTIAN HERBERT;ANNIKO CARL HENRIK. Presidente: ANTERO HANKECHRISTIAN HERBERT. Datos registrales. T 6285, L 3590, F 95, S 8, H V 21108, I/A 67 (15.06.18).
16 de Enero de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARRIBAS MARTINEZ JESUS;HUMANES RODRIGUEZ CARMEN;NAVARRO BONANAD JUANANTONIO;ORTEGA CIVICO ANA Mª. Nombramientos. Apo.Man.Soli: NAVARRO BONANAD JUAN ANTONIO;ORTEGA CIVICOANA Mª;BOSCH FERRER EDUARDO. Datos registrales. T 6285, L 3590, F 93, S 8, H V 21108, I/A 66 ( 9.01.18).
10 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: KOHRS FRANK. Nombramientos. Consejero: BURGUEZ FREDERIC PIERRE. Datos registrales.T 6127, L 3433, F 143, S 8, H V 21108, I/A 65 ( 3.03.17).
25 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 143, S 8, H V 21108, I/A 64 (18.01.17).
16 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: SJOLUND JAN RAGNAR;NILSSON PER JONAS. Presidente: NILSSON PER JONAS.Nombramientos. Consejero: FOURRIER ISABELLE. Presidente: FOURRIER ISABELLE. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 143,S 8, H V 21108, I/A 63 ( 9.09.16).
29 de Febrero de 2016Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 143, S 8, H V 21108, I/A 62 (22.02.16).
17 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ARRIBAS MARTINEZ JESUS. Presidente: ARRIBAS MARTINEZ JESUS. Nombramientos.Consejero: NILSSON PER JONAS;KOHRS FRANK. Presidente: NILSSON PER JONAS. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 143, S8, H V 21108, I/A 61 (10.11.15).
26 de Octubre de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: VERCHER ROSAT M& DESAMPARADOS. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 142, S 8, H V 21108,I/A 59 (19.10.15).
Modificaciones estatutarias. Creado un nuevo artículo de los Estatutos Sociales con el número 13 bis relativo a la Asistencia a lasJuntas. . Creado un nuevo artículo de los Estatutos Sociales con el número 13 bis relativo a la Asistencia a las reuniones del Consejode Administración. . Datos registrales. T 6127, L 3433, F 142, S 8, H V 21108, I/A 60 (19.10.15).
03 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: NELSON HANS-NICLAS-CLAESSON. Nombramientos. Consejero: SJOLUND JAN RAGNAR.Otros conceptos: D& -Amelie Maria Petersdotter Heiner ha cambiado su nombre por D& Amelie Maria Wendels según la inscripción58&. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 142, S 8, H V 21108, I/A 58 (26.11.14).
12 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARRIBAS MARTINEZ JESUS;VERCHER ROSAT M& DESAMPARADOS;NAVARRO BONANAD JUANANTONIO;HUMANES RODRIGUEZ CARMEN;CUÑAT VILAR JOSE MARIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARRIBAS MARTINEZJESUS;VERCHER ROSAT M& DESAMPARADOS;NAVARRO BONANAD JUAN ANTONIO;HUMANES RODRIGUEZCARMEN;ORTEGA CIVICO ANA M&. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 140, S 8, H V 21108, I/A 57 ( 4.11.14).
03 de Noviembre de 2014Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 140, S 8, H V 21108, I/A 56 (27.10.14).
16 de Agosto de 2013Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 139, S 8, H V 21108, I/A 55 ( 8.08.13).
17 de Julio de 2013Revocaciones. Apoderado: MITTAK LUDWIG HORST;MITTAK LUDWIG HORST;HUMADES RODRIGUEZ MARIACARMEN;VERCHER ROSAT AMPARO;NAVARRO BONONAD JUAN ANTONIO. Apo.Manc.: CUÑAT VILAR JOSE MARIA.Apoderado: LOPEZ ABENTE ORTEGA ARTURO;LOPEZ ABENTE ORTEGA ARTURO;LOPEZ ABENTE ORTEGA ARTURONombramientos. Apo.Man.Soli: ARRIBAS MARTINEZ JESUS;VERCHER ROSAT DESAMPARADOS;NAVARRO BONANAD JUANANTONIO;CUÑAT VILAR JOSE MARIA;HUMANES RODRIGUEZ CARMEN. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 137, S 8, H V21108, I/A 53 (10.07.13).
23 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: WADELL CARL-HANNES-SEVED. Nombramientos. Consejero: PETERSDOTTER HEINERAMELIE MARIA. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 137, S 8, H V 21108, I/A 52 (14.11.12).
24 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 137, S 8, H V 21108, I/A 51 (15.10.12).
16 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: GARCIA LOPEZ LUIS MANUEL. Vicesecret.: BLASCO MUÑOZ AMADEO. Nombramientos.SecreNoConsj: PEMAN CUBILLO CARLOS. VsecrNoConsj: CRUZ VILLALON GARCIA DIEGO. Datos registrales. T 6127, L 3433, F137, S 8, H V 21108, I/A 50 ( 4.05.12).
12 de Marzo de 2012Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: AUTOSAFETY SL. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 136, S 8, HV 21108, I/A 49 ( 1.03.12).
28 de Diciembre de 2011Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 136, S 8, H V 21108, I/A 48 (19.12.11).
29 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apoderado: COMPANY CERA JOSE. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 136, S 8, H V 21108, I/A 47 (18.11.11).
22 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: NELSON HANS NICLAS CALESSON. Consejero: NELSON HANS NICLAS CALESSON;WADELLCARL HANNES SEVED;COMPANY CERA JOSE. Presidente: COMPANY CERA JOSE. Secretario: MONLEON RODRIGUEZ JUANVICENTE. Nombramientos. Consejero: ARRIBAS MARTINEZ JESUS;NELSON HANS-NICLAS-CLAESSON;WADELL CARL-HANNES-SEVED. Secretario: GARCIA LOPEZ LUIS MANUEL. Vicesecret.: BLASCO MUÑOZ AMADEO. Presidente: ARRIBASMARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 135, S 8, H V 21108, I/A 46 (11.11.11).
25 de Febrero de 2011Otros conceptos: Por acuerdo plenario del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, de 26-12-2004 y 6-5-2010, se procede al cambiodel nombre de la calle y del Polígono donde se halla ubicado el domicilio social, siendo el actual el siguiente: Políg Ind "CAP DEL'HORTA", calle Ausias March número 5, Pobla de Vallbona. Datos registrales. T 4256, L 1568, F 147, S 8, H V 21108, I/A32/M1(16.02.11).
12 de Noviembre de 2010Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG MADRID. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 135, S 8, H V 21108, I/A 45 ( 2.11.10).
20 de Mayo de 2010Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG MADRID. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 135, S 8, H V 21108, I/A 44 (11.05.10).
11 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: CARLSON JAN-OVE-MIKAEL. Consejero: CARLSON JAN-OVE-MIKAEL;OLOF WALLIN BJORNMATS;DUART DUART SALVADOR. Nombramientos. Consejero: NELSON HANS NICLAS CALESSON;WADELL CARL HANNESSEVED. Vicepresid.: NELSON HANS NICLAS CALESSON. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 135, S 8, H V 21108, I/A 43 (1.12.09).
30 de Enero de 2009Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6127, L 3433, F 135, S 8, H V 21108, I/A 42 (21.01.09).