Buscador CIF Logo

Actos BORME Autologistica De Andalucia Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Autologistica De Andalucia Sa

Actos BORME Autologistica De Andalucia Sa - A83319061

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Sevilla para Autologistica De Andalucia Sa con CIF A83319061

馃敊 Perfil de Autologistica De Andalucia Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Sevilla

Actos BORME de Autologistica De Andalucia Sa

10 de Marzo de 2017
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 6105 , F 20, S 8, H SE 53356, I/A 27 1 ( 3.03.17).

02 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: HULLERUM BERND. Presidente: HULLERUM BERND. Consejero: ARRIBAS NAVARRO JOSEANDRES;HEINRICH LUBS ANDREAS HUGO. Otros conceptos: Conforme el art铆culo 231 del Reglamento del Registro Mercantil seha extendido nota que NO EXISTEN OBSTACULOS PARA LA FUSION de la Sociedad de esta hoja, que ser谩 ABSORBIDA, por ladenominada "SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y EXPLOTACION DE MATERIAL AUXILIAR DE TRANSPORTES, S.A.", con domicilio enMadrid.- Datos registrales. T 6105 , F 20, S 8, H SE 53356, I/A 26 1 (25.01.17).

12 de Mayo de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: PERALTA ARROYO ABRAHAM. Datos registrales. T 6105 , F 20, S 8, H SE 53356, I/A 26 (4.05.16).

04 de Diciembre de 2015
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y EXPLOTACION DE MATERIAL AUX. Datosregistrales. T 4076 , F 222, S 8, H SE 53356, I/A 23 (25.11.15).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BAUTISTA ENCISO SALVADOR. Consejero: ROCARIES THIERRY;ESTEVEZ MACARROEDUARDO. Nombramientos. Consejero: ARRIBAS NAVARRO ANDRES;HEINRICH LUBS ANDREAS HUGO. SecreNoConsj:LOPEZ TORRES ANA. VsecrNoConsj: VALENTIN-GAMAZO GARCIA-NOBLEJAS GERMAN. Datos registrales. T 4076 , F 222, S 8,H SE 53356, I/A 24 (25.11.15).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: HULLERUM BERND;PERALTA ARROYO ABRAHAM;ROCARIES THIERRY;ESTEVEZ MACARROEDUARDO;ROCARIE THIERRY;GARCIA OCHOA FIDEL ANGEL. Apo.Manc.: HEINRICH LUBS ANDREAS HUGO;GACIMARTINQUI脩ONES JULIAN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: HEINRICH LUBS ANDREAS HUGO;ARRIBAS NAVARRO JOSEANDRES;HULLERUM BERND;PERALTA ARROYO ABRAHAM;GARCIA OCHOA FIDEL ANGEL. Datos registrales. T 4076 , F 223,S 8, H SE 53356, I/A 25 (25.11.15).

23 de Junio de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: BUSTAMENTE GONZALEZ ANGEL LUIS;GARCIA BARROSO BERNARDO;MU脩OZ GARCIAJULIAN;FERRERA MATOS MIRIAM;GALLARDO GARCIA CARMEN;MERINO NAVARRO MANUEL ROMAN;REDONDO RUIZ MARIADEL MAR;DOMINGO FERNANDEZ JUAN ANGEL;CACERES PEREZ MARIO;GIL DE ROZAS SARA Datos registrales. T 4076 , F221, S 8, H SE 53356, I/A 22 (15.06.15).

08 de Abril de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA OCHOA FIDEL ANGEL. Apo.Manc.: HEINRICH LUBS ANDREAS HUGO;GACIMARTINQUI脩ONES JULIAN. Datos registrales. T 4076 , F 220, S 8, H SE 53356, I/A 21 (26.03.15).

06 de Abril de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CARRION RONCERO ANTONIO;GACIMARTIN QUI脩ONES JULIAN;ROCARIE THIERRY. Datosregistrales. T 4076 , F 159, S 8, H SE 53356, I/A 20 (24.03.15).

27 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDEZ GALLEGO JUAN JOSE;HERNANDEZ GALLEGO JUAN JOSE. Apo.Manc.: HERNANDEZGALLEGO JUAN JOSE;UBEDA RODRIGUEZ PEDRO;GACIMARTIN QUI脩ONES JULIAN;HULLERUM BERND;PERALTA ARROYOABRAHAM;ROCARIES THIERRY;ESTEVEZ MACARRO EDUARDO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: HEINRICH LUBS ANDREASHUGO;HULLERUM BERND;GUTIERREZ SANCHO SILVIA;GONZALEZ PISON ALFONSO;CARRION RONCEROANTONIO;PERALTA ARROYO ABRAHAM. Otros conceptos: REVOCADO EL PODER NO INSCRITO CONFERIDO A FAVOR DEDON JUAN JOSE HERNANDEZ GALLEGO Y DON RAUL ALFONSO DE MELO ESTEVES, EN ESCRITURA OTORGADA ANTE ELNOTARIO DE MADRID, DON JAVIER NAVARRO-RUBIO SERRES, EL DIA 18/07/2.006, PROTOCOLO 4.869.- REVOCADO ELPODER NO INSCRITO CONFERIDO A FAVOR DE DON PEDRO UBEDA RODRIGUEZ, EN ESCRITURA OTORGADA ANTE ELNOTARIO DE MADRID, D. JOSE LUIS MARTINEZ-GIL VICH EL DIA 05/07/2.012, PROTOCOLO 1409. Datos registrales. T 4076 , F158, S 8, H SE 53356, I/A 19 (19.03.15).

22 de Octubre de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.904.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 96.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 4076 , F 157, S 8, H SE 53356, I/A 18 (10.10.14).

08 de Marzo de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ GALLEGO JUAN JOSE. Apo.Manc.: HERNANDEZ GALLEGO JUAN JOSE;UBEDARODRIGUEZ PEDRO;GACIMARTIN QUI脩ONES JULIAN. Datos registrales. T 3727 , F 98, S 8, H SE 53356, I/A 16 (20.02.13).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: CAMPO VILLAPLANA LUIS DEL;PERALTA ARROYO ABRAHAM;ARRIBAS NAVARRO ANDRES.Apo.Manc.: HERNANDEZ GALLEGO JUAN JOSE. Apo.Man.Soli: ROCARIES THIERRY;ESTEVEZ MACARRO EDUARDO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: HULLERUM BERND;PERALTA ARROYO ABRAHAM;ROCARIES THIERRY;ESTEVEZ MACARROEDUARDO. Datos registrales. T 4076 , F 154, S 8, H SE 53356, I/A 17 (20.02.13).

26 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Presidente: ROCARIES THIERRY. SecreNoConsj: GALINDO JIMENEZ IDOIA. Nombramientos. Presidente:HULLERUM BERND. SecreNoConsj: BAUTISTA ENCISO SALVADOR. Datos registrales. T 3727 , F 97, S 8, H SE 53356, I/A 14(11.07.12).

Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ GALLEGO JUAN JOSE. Datos registrales. T 3727 , F 98, S 8, H SE 53356, I/A 15(11.07.12).

26 de Marzo de 2012
Revocaciones. Apo.Manc.: DE MELO ESTEVES RAUL AFONSO. Apo.Man.Soli: EULATE CABANYES JOAQUIN. Datosregistrales. T 3727 , F 97, S 8, H SE 53356, I/A 13 ( 9.03.12).

21 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PICO MARTIN MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. SecreNoConsj: GALINDO JIMENEZIDOIA. Datos registrales. T 3727 , F 95, S 8, H SE 53356, I/A 10 ( 9.03.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ARSIE GUTIERREZ JESUS. Datos registrales. T 3727 , F 96, S 8, H SE 53356, I/A 11 ( 9.03.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ARRIBAS NAVARRO ANDRES;ROCARIES THIERRY;ESTEVEZ MACARRO EDUARDO. Presidente:ROCARIES THIERRY. Consejero: CAMPO VILLAPLANA LUIS DEL;PERALTA ARROYO ABRAHAM. Nombramientos. Consejero:HULLERUM BERND;PERALTA ARROYO ABRAHAM;ROCARIES THIERRY. Presidente: ROCARIES THIERRY. Consejero: ESTEVEZMACARRO EDUARDO. Datos registrales. T 3727 , F 96, S 8, H SE 53356, I/A 12 ( 9.03.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n