Buscador CIF Logo

Actos BORME Automaticos Surmatic Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Automaticos Surmatic Sl

Actos BORME Automaticos Surmatic Sl - B82403817

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Automaticos Surmatic Sl con CIF B82403817

馃敊 Perfil de Automaticos Surmatic Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Automaticos Surmatic Sl

01 de Febrero de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34627 , F 107, S 8, H M 238629, I/A 19 (25.01.23).

16 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34627 , F 107, S 8, H M 238629, I/A 18 ( 9.12.22).

09 de Marzo de 2021
Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 12陋 el poder otorgado a GARCIA FERNANDEZ CESAR, siendo lo correctoFERNANDEZ GARCIA CESAR. Datos registrales. T 14435 , F 224, S 8, H M 238629, I/A 12 (11.05.16).

15 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apoderado: SAEZ OLIVEROS UNAX. Datos registrales. T 34627 , F 106, S 8, H M 238629, I/A 17 ( 7.10.20).

17 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTIN MARTIN FERNANDO AUGUSTO. VsecrNoConsj: RIESGO VARELA MARCELO.Nombramientos. SecreNoConsj: RIESGO VARELA MARCELO. Datos registrales. T 34627 , F 106, S 8, H M 238629, I/A 16(10.12.18).

30 de Mayo de 2018
Cambio de domicilio social. C/ GALILEO GALILEO 28 - POLIGONO INDUSTRIAL "LA G (ALCALA DE HENARES). Datosregistrales. T 34627 , F 106, S 8, H M 238629, I/A 15 (22.05.18).

08 de Marzo de 2017
Nombramientos. VsecrNoConsj: RIESGO VARELA MARCELO. Datos registrales. T 34627 , F 105, S 8, H M 238629, I/A 14(28.02.17).

07 de Febrero de 2017
Revocaciones. Auditor: ADVANCE AUDIT SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34627 , F 105, S 8, HM 238629, I/A 13 (30.01.17).

20 de Mayo de 2016
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ GARCIA CESAR;FERNANDEZ GARCIA JAVIER;GONZALEZ LAINEZ JOSE ANTONIO;DEJUAN DE CASTRO CARLOS. Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA FERNANDEZ CESAR;FERNANDEZ GARCIAJAVIER;GONZALEZ LAINEZ JOSE ANTONIO;DE JUAN DE CASTRO CARLOS;RODRIGO GOMEZ OLGA-MARIA. Apoderado: SAEZOLIVEROS UNAX. Datos registrales. T 14435 , F 224, S 8, H M 238629, I/A 12 (11.05.16).

23 de Marzo de 2016
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n y Aprobaci贸n de nuevo Texto de los Estatutos Sociales.. Cambio de objeto social.FABRICACION, DISTRIBUCION, COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO, IMPORTACION Y EXPORTACION DE MAQUINASRECREATIVAS Y DE AZAR, EXPLOTACION DE SALONES DE JUEGO... Datos registrales. T 14435 , F 221, S 8, H M 238629, I/A11 (16.03.16).

17 de Marzo de 2016
Nombramientos. Auditor: ADVANCE AUDIT SL. Datos registrales. T 14435 , F 220, S 8, H M 238629, I/A 10 ( 9.03.16).

18 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ESTALELLA CARVAJAL JAIME. Presidente: ESTALELLA CARVAJAL JAIME. Revocaciones.Apoderado: ESTALELLA CARVAJAL JAIME. Nombramientos. Consejero: RODRIGO GOMEZ OLGA-MARIA. Presidente: RODRIGOGOMEZ OLGA-MARIA. Apoderado: RODRIGO GOMEZ OLGA-MARIA. Datos registrales. T 14435 , F 219, S 8, H M 238629, I/A 9 (1.02.16).

14 de Septiembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARQUEZ CANO EMILIO ANGEL;MARQUEZ CANO JUAN ANTONIO;MARQUEZ CANO JOSEPEDRO. Secretario: MARQUEZ CANO EMILIO ANGEL. Presidente: FERNANDEZ GARCIA JAVIER. Revocaciones. Apoderado:FERNANDEZ GARCIA CESAR;FERNANDEZ GARCIA JAVIER;MARQUEZ CANO EMILIO ANGEL;FERNANDEZ GARCIACESAR;FERNANDEZ GARCIA JAVIER;MARQUEZ CANO EMILIO ANGEL;MARQUEZ CANO JUAN ANTONIO;MARQUEZ CANOJOSE PEDRO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ LAINEZ JOSE ANTONIO;DE JUAN DE CASTRO CARLOS;ESTALELLACARVAJAL JAIME. Presidente: ESTALELLA CARVAJAL JAIME. SecreNoConsj: MARTIN MARTIN FERNANDO AUGUSTO.Apoderado: FERNANDEZ GARCIA CESAR;FERNANDEZ GARCIA JAVIER. Datos registrales. T 14435 , F 215, S 8, H M 238629, I/A6 ( 4.09.15).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 49.991,18 Euros. Resultante Suscrito: 200.000,78 Euros. Datos registrales. T 14435 , F 215, S 8, HM 238629, I/A 7 ( 4.09.15).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ LAINEZ JOSE ANTONIO;ESTALELLA CARVAJAL JAIME;DE JUAN DE CASTROCARLOS. Datos registrales. T 14435 , F 218, S 8, H M 238629, I/A 8 ( 4.09.15).

05 de Septiembre de 2013
Modificaciones estatutarias. DEROGACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y APROBACION DE UN NUEVO TEXTOREFUNDIDO DE ESTATUTOS SOCIALES AJUSTADO A LA LEY DESOCIEDADES DE CAPITAL.. Cambio de objeto social. A) Lacompraventa, importaci贸n, exportaci贸n, Instalaci贸n y explotaci贸n de m谩quinas recreativas y de azar de tipo B y/o A, y/o de m谩quinasde apuestas deportivas. B) La instalaci贸n y explotaci贸n de Salones de Juego de tipo B y/o A. C) La instalaci贸n y explotaci贸n de Casasde Apuestas Deportivas. Datos registrales. T 14435 , F 210, S 8, H M 238629, I/A 4 (26.08.13).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARQUEZ CANO EMILIO ANGEL;FERNANDEZ GARCIA JAVIER. Nombramientos. Consejero:MARQUEZ CANO EMILIO ANGEL;MARQUEZ CANO JUAN ANTONIO;MARQUEZ CANO JOSE PEDRO;FERNANDEZ GARCIACESAR;FERNANDEZ GARCIA JAVIER. Presidente: FERNANDEZ GARCIA JAVIER. Secretario: MARQUEZ CANO EMILIO ANGEL.Apoderado: FERNANDEZ GARCIA CESAR;FERNANDEZ GARCIA JAVIER;MARQUEZ CANO EMILIO ANGEL;FERNANDEZ GARCIACESAR;FERNANDEZ GARCIA JAVIER;MARQUEZ CANO EMILIO ANGEL;MARQUEZ CANO JUAN ANTONIO;MARQUEZ CANOJOSE PEDRO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 14435 , F 212, S 8, H M 238629, I/A 5 (26.08.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n