Actos BORME de Automoviles Aviles Sa
16 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: INA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3449 , F 225, S 8, H AS 5113, I/A 50 ( 8.11.23).
25 de Octubre de 2022Reelecciones. Adm. Solid.: CRIADO LAVIN MARIA ESTELA;CRIADO LAVIN JOSE EMILIO. Datos registrales. T 3449 , F 224, S 8,H AS 5113, I/A 49 (18.10.22).
04 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: CASO-LOPEZ SAIZ VALENTIN. Apo.Manc.: CASO-LOPEZ SAIZ VALENTIN. Datos registrales. T 3449 ,F 224, S 8, H AS 5113, I/A 48 (26.04.22).
16 de Febrero de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA JOSE RAMON. Apo.Manc.: GOMEZ GARCIA JOSE RAMON;CASO-LOPEZ SAIZVALENTIN. Datos registrales. T 3449 , F 224, S 8, H AS 5113, I/A 47 ( 8.02.22).
17 de Noviembre de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: BLENDIO MOTOR SL. Datos registrales. T 3449 , F 223, S 8, H AS5113, I/A 46 ( 9.11.21).
31 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: INA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3449 , F 223, S 8, H AS 5113, I/A 45 (22.12.20).
17 de Abril de 2020Nombramientos. Apoderado: FCE BANK PLC SUC EN ESPA脩A. Datos registrales. T 3449 , F 223, S 8, H AS 5113, I/A 44 (7.04.20).
16 de Julio de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 17.308,80 Euros. Resultante Suscrito: 109.862,80 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 3449 , F 223, S 8, H AS 5113, I/A 43 ( 9.07.19).
15 de Octubre de 2018Nombramientos. Auditor: INA AUDIFORES SLP. Datos registrales. T 3449 , F 200, S 8, H AS 5113, I/A 42 ( 4.10.18).
25 de Abril de 2018Revocaciones. Apoderado: GOMEZ GARCIA JOSE RAMON. Datos registrales. T 3449 , F 200, S 8, H AS 5113, I/A 39 (17.04.18).
Nombramientos. Apoderado: BARANDIARAN FRANCES UNAI. Datos registrales. T 3449 , F 200, S 8, H AS 5113, I/A 40(17.04.18).
16 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO RODRIGUEZ DANIEL. Presidente: ALONSO RODRIGUEZ DANIEL. Consejero: VILLARONDIEGO MARIA AGUSTINA. Secretario: VILLARON DIEGO MARIA AGUSTINA. Consejero: GOMEZ GARCIA JOSE RAMON.Cons.Del.Man: GOMEZ GARCIA JOSE RAMON;VILLARON DIEGO MARIA AGUSTINA;ALONSO RODRIGUEZ DANIEL.Cons.Del.Sol: GOMEZ GARCIA JOSE RAMON. Nombramientos. Adm. Solid.: CRIADO LAVIN JOSE EMILIO;CRIADO LAVINMARIA ESTELA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios.MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7 AL 45 DE LOS ESTATUTOS SUSTITUYENDOLOS POR LOS ARTICULOS 7 AL 37 DE LOSESTATUTOS. Datos registrales. T 3449 , F 198, S 8, H AS 5113, I/A 36 ( 5.10.17).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ GARCIA JOSE RAMON. Datos registrales. T 3449 , F 200, S 8, H AS 5113, I/A 37 ( 5.10.17).
Revocaciones. Apo.Manc.: ALONSO VILLARON ORLANDO;ALONSO VILLARON DANIEL. Apo.Sol.: ALONSO VILLARONORLANDO;ALONSO VILLARON DANIEL. Apo.Manc.: GOMEZ GARCIA JOSE RAMON. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA JOSE RAMON.Datos registrales. T 3449 , F 200, S 8, H AS 5113, I/A 38 ( 5.10.17).
10 de Julio de 2017Reelecciones. Auditor: NORTE AUDITORES Y ASESORES SL. Datos registrales. T 3449 , F 198, S 8, H AS 5113, I/A 35(30.06.17).
22 de Marzo de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 47.118,40 Euros. Resultante Suscrito: 127.171,60 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 3449 , F 197, S 8, H AS 5113, I/A 33 (14.03.17).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO RODRIGUEZ DANIEL;VILLARON DIEGO MARIA AGUSTINA. Secretario: VILLARONDIEGO MARIA AGUSTINA. Presidente: ALONSO RODRIGUEZ DANIEL. Consejero: ALONSO VILLARON ORLANDO.Nombramientos. Consejero: ALONSO RODRIGUEZ DANIEL. Presidente: ALONSO RODRIGUEZ DANIEL. Consejero: VILLARONDIEGO MARIA AGUSTINA. Secretario: VILLARON DIEGO MARIA AGUSTINA. Consejero: GOMEZ GARCIA JOSE RAMON.Cons.Del.Man: GOMEZ GARCIA JOSE RAMON;VILLARON DIEGO MARIA AGUSTINA;ALONSO RODRIGUEZ DANIEL.Cons.Del.Sol: GOMEZ GARCIA JOSE RAMON. Datos registrales. T 3449 , F 197, S 8, H AS 5113, I/A 34 (14.03.17).
11 de Marzo de 2016Reelecciones. Auditor: NORTE AUDITORES Y ASESORES SL. Datos registrales. T 3449 , F 197, S 8, H AS 5113, I/A 32 (4.03.16).
14 de Mayo de 2015Reelecciones. Auditor: NORTE AUDITORES Y ASESORES SL. Datos registrales. T 3449 , F 197, S 8, H AS 5113, I/A 31 (6.05.15).
04 de Mayo de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ALONSO RODRIGUEZ DANIEL. Datos registrales. T 3449 , F 197, S 8, H AS5113, I/A 30 (23.04.15).
24 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: ARTIME FREIRE MANUEL. Revocaciones. Apo.Manc.: ARTIME FREIRE MANUEL. Apo.Sol.:ARTIME FREIRE MANUEL. Nombramientos. Consejero: ALONSO VILLARON ORLANDO. Datos registrales. T 3449 , F 196, S 8,H AS 5113, I/A 29 (13.11.14).
16 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: GOMEZ GARCIA JOSE RAMON. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA JOSE RAMON. Datos registrales. T3449 , F 187, S 8, H AS 5113, I/A 28 ( 5.09.14).
17 de Octubre de 2012Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: GIJON MOTOR SOCIEDAD ANONIMA. COMERCIAL HERRERO SA. Datosregistrales. T 3449 , F 187, S 8, H AS 5113, I/A 27 ( 1.10.12).
04 de Abril de 2012Nombramientos. Auditor: NORTE AUDITORES Y ASESORES SL. Datos registrales. T 3449 , F 186, S 8, H AS 5113, I/A 25(22.03.12).
Revocaciones. Cons.Del.Sol: ALONSO RODRIGUEZ DANIEL;VILLARON DIEGO MARIA AGUSTINA. Reelecciones. Consejero:ALONSO RODRIGUEZ DANIEL;VILLARON DIEGO MARIA AGUSTINA;ARTIME FREIRE MANUEL. Secretario: VILLARON DIEGOMARIA AGUSTINA. Presidente: ALONSO RODRIGUEZ DANIEL. Datos registrales. T 3449 , F 186, S 8, H AS 5113, I/A 26(22.03.12).
19 de Octubre de 2010Reelecciones. Auditor: BLANCO GONZALEZ Y MIER SOCIEDAD LIMITADA CENSORES. Datos registrales. T 3449 , F 186, S 8, HAS 5113, I/A 23 ( 6.10.10).
Reelecciones. Auditor: BLANCO GONZALEZ Y MIER SOCIEDAD LIMITADA CENSORES. Datos registrales. T 3449 , F 186, S 8, HAS 5113, I/A 24 ( 6.10.10).
21 de Enero de 2010Reelecciones. Auditor: BLANCO GONZALEZ Y MIER SOCIEDAD LIMITADA CENSORES. Datos registrales. T 3449 , F 186, S 8, HAS 5113, I/A 22 (11.01.10).