Actos BORME de Automoviles La Oscense Sa
26 de Diciembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA ISABEL. Vicesecret.: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA ISABEL.Datos registrales. T 570 , F 80, S 8, H HU 1192, I/A 101 (18.12.23).
20 de Septiembre de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 79, S 8, H HU 1192, I/A 99(13.09.23).
Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 80, S 8, H HU 1192, I/A100 (13.09.23).
29 de Agosto de 2022Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 79, S 8, H HU 1192,I/A 97 (22.08.22).
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 79, S 8, H HU 1192, I/A98 (22.08.22).
19 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 78, S 8, H HU 1192, I/A 93(12.01.21).
Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 78, S 8, H HU 1192, I/A94 (12.01.21).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 79, S 8, H HU 1192, I/A 95(12.01.21).
Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 79, S 8, H HU 1192, I/A96 (12.01.21).
30 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO;URIEL GONZALEZ CONRADO. Presidente: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Vicesecret.: URIEL GONZALEZ CONRADO. Nombramientos. Consejero: MARTIN-RETORTILLOLEGUINA ISABEL. Presidente: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Vicesecret.: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA ISABEL.Reelecciones. Consejero: BAQUER MASGRAU LUIS;ARAN SANTAMARIA MARIA JOSE;CALVO PUJOL JUAN JOSE. Vicepresid.:CALVO PUJOL JUAN JOSE. Consejero: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Con.Delegado: MARTIN-RETORTILLO LEGUINAPABLO. Secretario: BAQUER MASGRAU LUIS. Datos registrales. T 570 , F 78, S 8, H HU 1192, I/A 92 (23.07.19).
20 de Diciembre de 2018Otros conceptos: Modificaci贸n del Art铆culo 23潞 relativo a la retribuci贸n del Organo de Administraci贸n. Datos registrales. T 570 , F78, S 8, H HU 1192, I/A 91 (13.12.18).
01 de Octubre de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 77, S 8, H HU 1192, I/A 90 (24.09.18).
14 de Noviembre de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 77, S 8, H HU 1192, I/A 89 ( 6.11.17).
18 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: TRESACO CIDON MANUEL;BARATECH AVELLANAS PILAR. Secretario: TRESACO CIDONMANUEL. Con.Delegado: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Nombramientos. Consejero: BAQUER MASGRAU LUIS.Con.Delegado: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Reelecciones. Consejero: ARAN SANTAMARIA MARIA JOSE;CALVOPUJOL JUAN JOSE;MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO;URIEL GONZALEZ CONRADO. Vicesecret.: URIEL GONZALEZCONRADO. Presidente: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Vicepresid.: CALVO PUJOL JUAN JOSE. Consejero: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Datos registrales. T 570 , F 76, S 8, H HU 1192, I/A 88 (11.07.17).
14 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Datos registrales. T 570 , F 76, S 8, H HU 1192, I/A 87 (7.07.17).
11 de Octubre de 2016Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 76, S 8, H HU 1192, I/A 86 ( 5.10.16).
26 de Septiembre de 2013Cancelaciones de oficio de nombramientos. Aud.C.Con.: TRUJILLANO Y ASOCIADOS AUDITORES C.J.C. SL. Auditor:TRUJILLANO Y ASOCIADOS AUDITORES C.J.C. SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 76, S 8, H HU 1192, I/A 85 (19.09.13).
19 de Septiembre de 2013Otros conceptos: CAMBIADA la Retribuci贸n del Organo de Administraci贸n y RENUMERADOS y REFUNDIDOS en su totalidad losEstatutos Sociales. Datos registrales. T 570 , F 72, S 8, H HU 1192, I/A 84 (13.09.13).
27 de Febrero de 2013Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: HUDEBUS SL. Datos registrales. T 570 , F 71, S 8, H HU 1192, I/A 83 (20.02.13).
04 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Revocaciones. Apo.Manc.: NAVALES MENDOZARAQUEL. Apoderado: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Nombramientos. Apo.Manc.: MARTIN-RETORTILLO BAQUERIGNACIO. Apo.Sol.: NAVALES MENDOZA RAQUEL. Apo.Manc.: NAVALES MENDOZA RAQUEL. Apo.Sol.: MARTIN-RETORTILLOBAQUER IGNACIO. Datos registrales. T 570 , F 71, S 8, H HU 1192, I/A 82 (28.01.13).
29 de Octubre de 2012Otros conceptos: Practicado el Deposito del Proyecto de FUSION POR ABSORCIONen este Registro, siendo la Entidad de estaHoja, la Entidad ABSORBENTE, y la Entidad HUDEBUS SL, la ABSORBIDA, 茅sta inscrita en este Registro. Datos registrales. T 195,L 109, F 137, S 8, H HU 1192, I/A 41 F (18.10.12).
02 de Agosto de 2012Reelecciones. Auditor: TRUJILLANO Y ASOCIADOS AUDITORES C.J.C. SL. Aud.C.Con.: TRUJILLANO Y ASOCIADOSAUDITORES C.J.C. SL. Datos registrales. T 570 , F 70, S 8, H HU 1192, I/A 81 (25.07.12).
26 de Julio de 2012Reelecciones. Consejero: ARAN SANTAMARIA MARIA JOSE;TRESACO CIDON MANUEL;CALVO PUJOL JUAN JOSE;MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Secretario: TRESACO CIDON MANUEL. Con.Delegado: MARTIN-RETORTILLO BAQUERIGNACIO. Consejero: URIEL GONZALEZ CONRADO. Vicesecret.: URIEL GONZALEZ CONRADO. Con.Delegado: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Presidente: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Vicepresid.: CALVO PUJOL JUAN JOSE.Consejero: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO;BARATECH AVELLANAS PILAR. Datos registrales. T 570 , F 70, S 8, H HU1192, I/A 80 (18.07.12).
14 de Diciembre de 2011Reelecciones. Auditor: TRUJILLANO Y ASOCIADOS AUDITORES C.J.C. SL. Datos registrales. T 570 , F 70, S 8, H HU 1192, I/A79 ( 2.12.11).
21 de Marzo de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 115.908,86 Euros. Resultante Suscrito: 2.312.684,06 Euros. Datos registrales. T 570 , F69, S 8, H HU 1192, I/A 78 (10.03.11).
14 de Febrero de 2011Ampliacion del objeto social. H) La promoci贸n, dise帽o, estudio, construcci贸n, explotaci贸n, comercializaci贸n, y/o titularidad de plantasde producci贸n de energias renovables, as铆 como la producci贸n y comercializaci贸n de electricidad mediante instalacionesque utilicenfuentes de energias renovables. En todo caso quedan excluidas. Datos registrales. T 570 , F 69, S 8, H HU 1192, I/A 77 ( 4.02.11).
14 de Enero de 2011Reelecciones. Aud.C.Con.: BERMUDEZ Y TRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D. Auditor: BERMUDEZ YTRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D. Datos registrales. T 570 , F 69, S 8, H HU 1192, I/A 76 ( 3.01.11).
07 de Junio de 2010Nombramientos. Auditor: BERMUDEZ Y TRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D. Aud.C.Con.: BERMUDEZ YTRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D. Datos registrales. T 492, L 141, F 82, S 8, H HU 1192, I/A 74 (26.05.10).
Nombramientos. Auditor: BERMUDEZ Y TRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D. Aud.C.Con.: BERMUDEZ YTRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D. Otros conceptos: Ratificados por Junta de fecha 30/06/2009, do帽a PilarBaratech Avellanas y don Pablo Mart铆n-Retortillo Leguina en sus cargos de Consejeros, nombrados por cooptaci贸n. Datosregistrales. T 492, L 141, F 82, S 8, H HU 1192, I/A 75 (26.05.10).
26 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BARATECH BONED MARIA ANGEL. Nombramientos. Consejero: BARATECH AVELLANASPILAR. Datos registrales. T 492, L 141, F 81, S 8, H HU 1192, I/A 72 (14.05.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CABRERO BALAGUER GREGORIO. Presidente: CABRERO BALAGUER GREGORIO. Vicepresid.:MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Nombramientos. Consejero: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Con.Delegado:MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Presidente: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Vicepresid.: CALVO PUJOL JUANJOSE. Datos registrales. T 492, L 141, F 81, S 8, H HU 1192, I/A 73 (14.05.09).