Buscador CIF Logo

Actos BORME Automoviles La Oscense Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Automoviles La Oscense Sa

Actos BORME Automoviles La Oscense Sa - A22000582

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Huesca para Automoviles La Oscense Sa con CIF A22000582

馃敊 Perfil de Automoviles La Oscense Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Huesca

Actos BORME de Automoviles La Oscense Sa

26 de Diciembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA ISABEL. Vicesecret.: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA ISABEL.Datos registrales. T 570 , F 80, S 8, H HU 1192, I/A 101 (18.12.23).

20 de Septiembre de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 79, S 8, H HU 1192, I/A 99(13.09.23).

Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 80, S 8, H HU 1192, I/A100 (13.09.23).

29 de Agosto de 2022
Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 79, S 8, H HU 1192,I/A 97 (22.08.22).

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 79, S 8, H HU 1192, I/A98 (22.08.22).

19 de Enero de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 78, S 8, H HU 1192, I/A 93(12.01.21).

Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 78, S 8, H HU 1192, I/A94 (12.01.21).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 79, S 8, H HU 1192, I/A 95(12.01.21).

Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 79, S 8, H HU 1192, I/A96 (12.01.21).

30 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO;URIEL GONZALEZ CONRADO. Presidente: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Vicesecret.: URIEL GONZALEZ CONRADO. Nombramientos. Consejero: MARTIN-RETORTILLOLEGUINA ISABEL. Presidente: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Vicesecret.: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA ISABEL.Reelecciones. Consejero: BAQUER MASGRAU LUIS;ARAN SANTAMARIA MARIA JOSE;CALVO PUJOL JUAN JOSE. Vicepresid.:CALVO PUJOL JUAN JOSE. Consejero: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Con.Delegado: MARTIN-RETORTILLO LEGUINAPABLO. Secretario: BAQUER MASGRAU LUIS. Datos registrales. T 570 , F 78, S 8, H HU 1192, I/A 92 (23.07.19).

20 de Diciembre de 2018
Otros conceptos: Modificaci贸n del Art铆culo 23潞 relativo a la retribuci贸n del Organo de Administraci贸n. Datos registrales. T 570 , F78, S 8, H HU 1192, I/A 91 (13.12.18).

01 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 77, S 8, H HU 1192, I/A 90 (24.09.18).

14 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 77, S 8, H HU 1192, I/A 89 ( 6.11.17).

18 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: TRESACO CIDON MANUEL;BARATECH AVELLANAS PILAR. Secretario: TRESACO CIDONMANUEL. Con.Delegado: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Nombramientos. Consejero: BAQUER MASGRAU LUIS.Con.Delegado: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Reelecciones. Consejero: ARAN SANTAMARIA MARIA JOSE;CALVOPUJOL JUAN JOSE;MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO;URIEL GONZALEZ CONRADO. Vicesecret.: URIEL GONZALEZCONRADO. Presidente: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Vicepresid.: CALVO PUJOL JUAN JOSE. Consejero: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Datos registrales. T 570 , F 76, S 8, H HU 1192, I/A 88 (11.07.17).

14 de Julio de 2017
Nombramientos. Apoderado: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Datos registrales. T 570 , F 76, S 8, H HU 1192, I/A 87 (7.07.17).

11 de Octubre de 2016
Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 76, S 8, H HU 1192, I/A 86 ( 5.10.16).

26 de Septiembre de 2013
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Aud.C.Con.: TRUJILLANO Y ASOCIADOS AUDITORES C.J.C. SL. Auditor:TRUJILLANO Y ASOCIADOS AUDITORES C.J.C. SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 570 , F 76, S 8, H HU 1192, I/A 85 (19.09.13).

19 de Septiembre de 2013
Otros conceptos: CAMBIADA la Retribuci贸n del Organo de Administraci贸n y RENUMERADOS y REFUNDIDOS en su totalidad losEstatutos Sociales. Datos registrales. T 570 , F 72, S 8, H HU 1192, I/A 84 (13.09.13).

27 de Febrero de 2013
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: HUDEBUS SL. Datos registrales. T 570 , F 71, S 8, H HU 1192, I/A 83 (20.02.13).

04 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Revocaciones. Apo.Manc.: NAVALES MENDOZARAQUEL. Apoderado: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Nombramientos. Apo.Manc.: MARTIN-RETORTILLO BAQUERIGNACIO. Apo.Sol.: NAVALES MENDOZA RAQUEL. Apo.Manc.: NAVALES MENDOZA RAQUEL. Apo.Sol.: MARTIN-RETORTILLOBAQUER IGNACIO. Datos registrales. T 570 , F 71, S 8, H HU 1192, I/A 82 (28.01.13).

29 de Octubre de 2012
Otros conceptos: Practicado el Deposito del Proyecto de FUSION POR ABSORCIONen este Registro, siendo la Entidad de estaHoja, la Entidad ABSORBENTE, y la Entidad HUDEBUS SL, la ABSORBIDA, 茅sta inscrita en este Registro. Datos registrales. T 195,L 109, F 137, S 8, H HU 1192, I/A 41 F (18.10.12).

02 de Agosto de 2012
Reelecciones. Auditor: TRUJILLANO Y ASOCIADOS AUDITORES C.J.C. SL. Aud.C.Con.: TRUJILLANO Y ASOCIADOSAUDITORES C.J.C. SL. Datos registrales. T 570 , F 70, S 8, H HU 1192, I/A 81 (25.07.12).

26 de Julio de 2012
Reelecciones. Consejero: ARAN SANTAMARIA MARIA JOSE;TRESACO CIDON MANUEL;CALVO PUJOL JUAN JOSE;MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Secretario: TRESACO CIDON MANUEL. Con.Delegado: MARTIN-RETORTILLO BAQUERIGNACIO. Consejero: URIEL GONZALEZ CONRADO. Vicesecret.: URIEL GONZALEZ CONRADO. Con.Delegado: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Presidente: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Vicepresid.: CALVO PUJOL JUAN JOSE.Consejero: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO;BARATECH AVELLANAS PILAR. Datos registrales. T 570 , F 70, S 8, H HU1192, I/A 80 (18.07.12).

14 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Auditor: TRUJILLANO Y ASOCIADOS AUDITORES C.J.C. SL. Datos registrales. T 570 , F 70, S 8, H HU 1192, I/A79 ( 2.12.11).

21 de Marzo de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 115.908,86 Euros. Resultante Suscrito: 2.312.684,06 Euros. Datos registrales. T 570 , F69, S 8, H HU 1192, I/A 78 (10.03.11).

14 de Febrero de 2011
Ampliacion del objeto social. H) La promoci贸n, dise帽o, estudio, construcci贸n, explotaci贸n, comercializaci贸n, y/o titularidad de plantasde producci贸n de energias renovables, as铆 como la producci贸n y comercializaci贸n de electricidad mediante instalacionesque utilicenfuentes de energias renovables. En todo caso quedan excluidas. Datos registrales. T 570 , F 69, S 8, H HU 1192, I/A 77 ( 4.02.11).

14 de Enero de 2011
Reelecciones. Aud.C.Con.: BERMUDEZ Y TRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D. Auditor: BERMUDEZ YTRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D. Datos registrales. T 570 , F 69, S 8, H HU 1192, I/A 76 ( 3.01.11).

07 de Junio de 2010
Nombramientos. Auditor: BERMUDEZ Y TRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D. Aud.C.Con.: BERMUDEZ YTRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D. Datos registrales. T 492, L 141, F 82, S 8, H HU 1192, I/A 74 (26.05.10).

Nombramientos. Auditor: BERMUDEZ Y TRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D. Aud.C.Con.: BERMUDEZ YTRUJILLANO AUDITORES CENSORES JURADOS D. Otros conceptos: Ratificados por Junta de fecha 30/06/2009, do帽a PilarBaratech Avellanas y don Pablo Mart铆n-Retortillo Leguina en sus cargos de Consejeros, nombrados por cooptaci贸n. Datosregistrales. T 492, L 141, F 82, S 8, H HU 1192, I/A 75 (26.05.10).

26 de Mayo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARATECH BONED MARIA ANGEL. Nombramientos. Consejero: BARATECH AVELLANASPILAR. Datos registrales. T 492, L 141, F 81, S 8, H HU 1192, I/A 72 (14.05.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CABRERO BALAGUER GREGORIO. Presidente: CABRERO BALAGUER GREGORIO. Vicepresid.:MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Nombramientos. Consejero: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Con.Delegado:MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Presidente: MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO. Vicepresid.: CALVO PUJOL JUANJOSE. Datos registrales. T 492, L 141, F 81, S 8, H HU 1192, I/A 73 (14.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n