Actos BORME de Automoviles Louzao Vigo Sl
13 de Enero de 2020Nombramientos. Auditor: NEXSO AUDIT GROUP S.L. Datos registrales. T 3996, L 3996, F 218, S 8, H PO 10347, I/A 60 ( 7.01.20).
24 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ FRANKE INGRID EVELIN. Datos registrales. T 3996, L 3996, F 218, S 8, H PO 10347, I/A 59(17.07.19).
22 de Mayo de 2019Revocaciones. Apoderado: GARZA LOPEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3996, L 3996, F 218, S 8, H PO 10347, I/A 58(13.05.19).
18 de Febrero de 2019Nombramientos. Apoderado: GARZA LOPEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3996, L 3996, F 218, S 8, H PO 10347, I/A 57(11.02.19).
10 de Enero de 2019Revocaciones. Apoderado: LOUZAO CABO JESUS BENIGNO. Datos registrales. T 3924, L 3924, F 225, S 8, H PO 10347, I/A 56(28.12.18).
26 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: TOBIO FERREIROS REBECA. Datos registrales. T 3924, L 3924, F 225, S 8, H PO 10347, I/A 53(20.03.18).
Nombramientos. Apoderado: LAGO PORTELA EMMA. Datos registrales. T 3924, L 3924, F 225, S 8, H PO 10347, I/A 54(20.03.18).
Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ GARA脩A SUSANA. Datos registrales. T 3924, L 3924, F 225, S 8, H PO 10347, I/A 55(20.03.18).
23 de Marzo de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: COMESA脩A ALVAREZ VICENTE. Datos registrales. T 3924, L 3924, F 224, S 8, H PO 10347, I/A 52(19.03.18).
10 de Enero de 2018Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ SOUTO MARIA LUISA. Datos registrales. T 3924, L 3924, F 224, S 8, H PO 10347, I/A 51( 2.01.18).
21 de Noviembre de 2016Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: NEXSO AUDIT &FORENSIC SL. Datos registrales. T 3924, L 3924, F 224, S 8, H PO 10347, I/A 50 (11.11.16).
28 de Julio de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: MU脩OZ FRANKE INGRID EVELINA. Apoderado: TABOADA BOCELO RAQUEL. Apo.Man.Soli:GUTIERREZ SOUTO MARIA LUISA. Datos registrales. T 3924, L 3924, F 224, S 8, H PO 10347, I/A 49 (18.07.16).
26 de Julio de 2016Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ SOUTO MARIA LUISA. Datos registrales. T 3924, L 3924, F 223, S 8, H PO 10347, I/A48 (14.07.16).
20 de Julio de 2016Nombramientos. Apoderado: CARABEL PEDREIRA MARIA REYES. Datos registrales. T 3924, L 3924, F 223, S 8, H PO 10347,I/A 47 (12.07.16).
23 de Octubre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.203.237,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.554.005,00 Euros. Datos registrales. T 3924, L 3924, F222, S 8, H PO 10347, I/A 46 (15.10.15).