Actos BORME de Automoviles Y Motores Europeos Sa
02 de Marzo de 2023Nombramientos. Auditor: ANALISIS Y CONTROL DE CUENTAS SLP. Datos registrales. T 2889, L 2889, F 183, S 8, H PO 3003,I/A 42 (21.02.23).
17 de Agosto de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 100.000,00 Euros. Desembolsado: 100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 160.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 160.000,00 Euros. Datos registrales. T 2889, L 2889, F 183, S 8, H PO 3003, I/A 41 ( 6.08.21).
16 de Septiembre de 2020Nombramientos. Auditor: CASTLE SPAIN AUDITORES SL. Datos registrales. T 2889, L 2889, F 182, S 8, H PO 3003, I/A 40 (8.09.20).
20 de Marzo de 2020Cancelaciones de oficio de nombramientos. Adm. Unico: BILBATUA FERRER YURI. Nombramientos. Adm. Unico: BILBATUAFERRER YURI. Datos registrales. T 2889, L 2889, F 182, S 8, H PO 3003, I/A 39 (12.03.20).
11 de Abril de 2019Revocaciones. Apoderado: PRIETO QUINTELA JOSE MANUEL;PRIETO QUINTELA JOSE MANUEL;PRIETO QUINTELA JOSEMANUEL. Nombramientos. Apoderado: CRESPO MOREIRA PABLO. Datos registrales. T 2889, L 2889, F 182, S 8, H PO 3003,
17 de Junio de 2016Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BILBATUA FERRER YURI. Datos registrales. T 2889, L 2889, F 181, S 8, H PO3003, I/A 36 ( 9.06.16).
Nombramientos. Apoderado: PRIETO QUINTELA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2889, L 2889, F 181, S 8, H PO 3003, I/A37 ( 9.06.16).
17 de Febrero de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 426.718,59 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:60.000,00 Euros. Desembolsado: 60.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 60.000,00 Euros.Datos registrales. T 2889, L 2889, F 180, S 8, H PO 3003, I/A 35 ( 8.02.16).
30 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: PRIETO QUINTELA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2889, L 2889, F 180, S 8, H PO 3003, I/A34 (22.12.15).
19 de Enero de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: EIRIN BARRIO MARIA AVELINA;TORRES MARTINEZ GERARDO ANTONIO. Datos registrales. T 2889,L 2889, F 180, S 8, H PO 3003, I/A 33 ( 9.01.15).
18 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: PRIETO QUINTELA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2889, L 2889, F 180, S 8, H PO 3003, I/A32 ( 9.12.14).
17 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES TORRES JOSE;TORRES MARTINEZ GERARDO ANTONIO;EIRIN BARRIO MARIA.Presidente: TORRES TORRES JOSE. Secretario: TORRES MARTINEZ GERARDO ANTONIO. Revocaciones. Apoderado:TORRES MARTINEZ GERARDO ANTONIO;EIRIN BARRIO MARIA AVELINA. Apo.Man.Soli: TORRES TORRES JOSE;TORRESMARTINEZ GERARDO ANTONIO. Apoderado: TORRES MARTINEZ GERARDO ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico:BILBATUA FERRER YURI. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Otros conceptos: SE REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 419, L 419, F 172, S 8,H PO 3003, I/A 30 (11.06.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: EIRIN BARRIO MARIA AVELINA;TORRES MARTINEZ GERARDO ANTONIO. Datos registrales. T2889, L 2889, F 179, S 8, H PO 3003, I/A 31 (11.06.14).
09 de Mayo de 2014Reelecciones. Consejero: TORRES TORRES JOSE;TORRES MARTINEZ GERARDO ANTONIO;EIRIN BARRIO MARIA. Presidente:TORRES TORRES JOSE. Secretario: TORRES MARTINEZ GERARDO ANTONIO. Datos registrales. T 419, L 419, F 172, S 8, H PO3003, I/A 29 (30.04.14).
24 de Diciembre de 2009Cancelaciones de oficio de nombramientos. Presidente: TORRES TORRES JOSE. Consejero: TORRES TORRES JOSE;TORRESMARTINEZ GERARDO ANTONIO. Secretario: TORRES MARTINEZ GERARDO ANTONIO. Consejero: EIRIN BARRIO MARIA.Nombramientos. Consejero: TORRES TORRES JOSE;TORRES MARTINEZ GERARDO ANTONIO;EIRIN BARRIO MARIA.Presidente: TORRES TORRES JOSE. Secretario: TORRES MARTINEZ GERARDO ANTONIO. Datos registrales. T 419, L 419, F171, S 8, H PO 3003, I/A 28 (11.12.09).