Buscador CIF Logo

Actos BORME Autopistas De Leon Sociedad Anonima Concesionaria Del Estado

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Autopistas De Leon Sociedad Anonima Concesionaria Del Estado

Actos BORME Autopistas De Leon Sociedad Anonima Concesionaria Del Estado - A82642539

Tenemos registrados 53 Actos BORME del Registro Mercantil de Leon para Autopistas De Leon Sociedad Anonima Concesionaria Del Estado con CIF A82642539

馃敊 Perfil de Autopistas De Leon Sociedad Anonima Concesionaria Del Estado
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Leon

Actos BORME de Autopistas De Leon Sociedad Anonima Concesionaria Del Estado

03 de Noviembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ROGOWSKI ANDRE. Nombramientos. Adm. Solid.: D'UVA SALGUEIRO MARTIN-EDUARDO.Datos registrales. T 1072 , F 113, S 8, H LE 14181, I/A 113 (27.10.23).

17 de Agosto de 2022
Revocaciones. Apoderado: ALLES DE OLIVES MONICA;ALLES DE OLIVES MONICA. Datos registrales. T 1072 , F 113, S 8, H LE14181, I/A 112 (10.08.22).

19 de Julio de 2022
Reelecciones. Adm. Solid.: CORONAS GUINART JOSEP MARIA. Datos registrales. T 1072 , F 113, S 8, H LE 14181, I/A 111(13.07.22).

08 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BONET OLIVART ANA;ROQUET PORTELLA LOURDES;CARRO RODRIGUEZ GONZALO;DE DIEGOCASTRO JORGE;LARRAINZAR ALOY IGNACIO-JESUS;LOPEZ ARCEDIANO MARIANO;VILANOVA ABAD DANIEL;GARCIABURGOS ANA MARIA;VIEJO BELON JOSE LUIS. Datos registrales. T 1072 , F 112, S 8, H LE 14181, I/A 110 ( 2.11.21).

24 de Agosto de 2021
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datosregistrales. T 1072 , F 112, S 8, H LE 14181, I/A 109 (18.08.21).

16 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILANOVA ABAD DANIEL;GASULLA ABAD OSCAR;CARNICAS ISIDRO PATRICIA;CARRORODRIGUEZ GONZALO;LARRAINZAR ALOY IGNACIO-JESUS;LOPEZ ARCEDIANO MARIANO;GARCIA BURGOS ANAMARIA;JIMENEZ CARRO ANA BELEN;VIEJO BELON JOSE LUIS. Datos registrales. T 1072 , F 110, S 8, H LE 14181, I/A 108 (9.08.21).

16 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1072 , F 110, S 8, H LE 14181, I/A 107 ( 9.10.20).

07 de Octubre de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BONET OLIVART ANA;ROQUET PORTELLA LOURDES;CUARTERO PELEGAY CAROLINA;CARRORODRIGUEZ GONZALO;DE DIEGO CASTRO JORGE;LARRAINZAR ALOY IGNACIO-JESUS;LOPEZ ARCEDIANOMARIANO;CUARTERO PELEGAY CAROLINA;GARCIA BURGOS ANA MARIA;JIMENEZ CARRO ANA BELEN;LARRAINZAR ALOYIGNACIO-JESUS;VIEJO BELON JOSE LUIS. Datos registrales. T 1072 , F 110, S 8, H LE 14181, I/A 106 ( 1.10.20).

10 de Junio de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BONET OLIVART ANA;ROQUET PORTELLA LOURDES;CARRO RODRIGUEZ GONZALO;DEDIEGO CASTRO JORGE;LARRAINZAR ALOY IGNACIO-JESUS;LOPEZ ARCEDIANO MARIANO;VILANOVA ABAD DANIEL;GARCIABURGOS ANA MARIA;JIMENEZ CARRO ANA BELEN;VIEJO BELON JOSE LUIS. Datos registrales. T 1072 , F 108, S 8, H LE14181, I/A 105 ( 4.06.20).

30 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ALJARO NAVARRO FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Adm. Solid.: ROGOWSKI ANDRE.Datos registrales. T 1072 , F 108, S 8, H LE 14181, I/A 103 (24.10.19).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1072 , F 108, S 8, H LE 14181, I/A 104 (24.10.19).

19 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GIMENEZ SEVILLA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 1072 , F 107, S 8, H LE 14181, I/A 102(13.03.19).

14 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ALBARRAN OSCAR ANTONIO. Datos registrales. T 1072 , F 107, S 8, H LE 14181, I/A101 ( 7.11.18).

05 de Septiembre de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1072 , F 106, S 8, H LE 14181, I/A 100 (30.08.18).

30 de Julio de 2018
Nombramientos. Apoderado: ALLES DE OLIVES MONICA. Datos registrales. T 1072 , F 106, S 8, H LE 14181, I/A 99 (24.07.18).

26 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: REYNES MASSANET FRANCISCO. Otros conceptos: Cambio de la estructura del 贸rgano deAdministraci贸n por la de dos Administradores Solidarios, manteni茅ndose en el cargo a los Administradores Solidarios don Josep Mar铆aCoronas Guinart y don Francisco Jos茅 Aljaro Navarro conforme a su anterior designaci贸n efectuada en la Junta de 9 de junio de 2017.Datos registrales. T 1072 , F 106, S 8, H LE 14181, I/A 98 (20.04.18).

19 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: ALLES DE OLIVES MONICA. Datos registrales. T 1072 , F 105, S 8, H LE 14181, I/A 96 (13.02.18).

Revocaciones. Apoderado: ARMENTIA AMANTEGUI ANDONI. Datos registrales. T 1072 , F 106, S 8, H LE 14181, I/A 97(13.02.18).

13 de Septiembre de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1072 , F 105, S 8, H LE 14181, I/A 95 ( 7.09.17).

09 de Agosto de 2017
Reelecciones. Adm. Solid.: ALJARO NAVARRO FRANCISCO JOSE;CORONAS GUINART JOSEP MARIA. Datos registrales. T1072 , F 105, S 8, H LE 14181, I/A 94 ( 3.08.17).

14 de Marzo de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BONET OLIVART ANA;ROQUET PORTELLA LOURDES;ARBILLA SAMPOL IGNACIO;CARRORODRIGUEZ GONZALO;CUARTERO PELEGAY CAROLINA;LARRAINZAR ALOY IGNACIO-JESUS;LOPEZ ARCEDIANOMARIANO;GIMENEZ SEVILLA JOSE-LUIS;GARCIA BURGOS ANA MARIA;JIMENEZ CARRO ANA BELEN;VIEJO BELON JOSELUIS. Datos registrales. T 1072 , F 105, S 8, H LE 14181, I/A 93 ( 7.03.17).

26 de Enero de 2017
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.748.000,00 Euros. Datos registrales. T 1072 , F 104, S 8, H LE 14181, I/A92 (20.01.17).

15 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BONET OLIVART ANA;ROQUET PORTELLA LOURDES;CUARTERO PELEGAYCAROLINA;CARRO RODRIGUEZ GONZALO;DE DIEGO CASTRO JORGE;LARRAINZAR ALOY IGNACIO-JESUS;LOPEZARCEDIANO MARIANO;GIMENEZ SEVILLA JOSE-LUIS;CUARTERO PELEGAY CAROLINA;GARCIA BURGOS ANAMARIA;JIMENEZ CARRO ANA BELEN;LARRAINZAR ALOY IGNACIO-JESUS;VIEJO BELON JOSE LUIS. Datos registrales. T 1072, F 103, S 8, H LE 14181, I/A 91 ( 9.12.16).

10 de Noviembre de 2016
Reelecciones. Adm. Solid.: REYNES MASSANET FRANCISCO. Datos registrales. T 1072 , F 102, S 8, H LE 14181, I/A 89 (3.11.16).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ESPA脩OL REALP ANTONIO-JOSE;ARBILLA SAMPOL IGNACIO;CARRO RODRIGUEZGONZALO;BONET OLIVART ANA;LARRAINZAR ALOY IGNACIO-JESUS;LOPEZ ARCEDIANO MARIANO;ROQUET PORTELLALOURDES;GIMENEZ SEVILLA JOSE-LUIS;GARCIA BURGOS ANA MARIA;JIMENEZ CARRO ANA BELEN;VIEJO BELON JOSELUIS. Datos registrales. T 1072 , F 102, S 8, H LE 14181, I/A 90 ( 3.11.16).

03 de Octubre de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1072 , F 102, S 8, H LE 14181, I/A 88 (27.09.16).

29 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BONET OLIVART ANA;ROQUET PORTELLA LOURDES;ARBILLA SAMPOL IGNACIO;CARRORODRIGUEZ GONZALO;CUARTERO PELEGAY CAROLINA;LARRAINZAR ALOY IGNACIO-JESUS;LOPEZ ARCEDIANOMARIANO;GIMENEZ SEVILLA JOSE-LUIS;GARCIA BURGOS ANA MARIA;JIMENEZ CARRO ANA BELEN;VIEJO BELON JOSELUIS. Datos registrales. T 1072 , F 100, S 8, H LE 14181, I/A 87 (23.08.16).

07 de Enero de 2016
Nombramientos. Apoderado: URGELLES CASADEMUNT ALBERTO. Datos registrales. T 1072 , F 100, S 8, H LE 14181, I/A 86(29.12.15).

22 de Octubre de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1072 , F 100, S 8, H LE 14181, I/A 85 (15.10.15).

17 de Junio de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GIMENEZ SEVILLA JOSE-LUIS;ESPA脩OL REALP ANTONIO-JOSE;ARBILLA SAMPOLIGNACIO;CARRO RODRIGUEZ GONZALO;BONET OLIVART ANA;LARRAINZAR ALOY IGNACIO-JESUS;LOPEZ ARCEDIANOMARIANO;DEULOFEU FUGUET LUIS;GARCIA BURGOS ANA MARIA;SANCHEZ FARRE FRANCESC. Datos registrales. T 1072 , F100, S 8, H LE 14181, I/A 84 (11.06.15).

05 de Marzo de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPA脩OL REALP ANTONIO-JOSE;ARBILLA SAMPOL IGNACIO;CARRO RODRIGUEZGONZALO;BONET OLIVART ANA;LARRAINZAR ALOY IGNACIO-JESUS;LOPEZ ARCEDIANO MARIANO;ROQUET PORTELLALOURDES;GIMENEZ SEVILLA JOSE-LUIS;GARCIA BURGOS ANA MARIA;JIMENEZ CARRO ANA BELEN;VIEJO BELON JOSELUIS. Datos registrales. T 1072 , F 98, S 8, H LE 14181, I/A 83 (27.02.15).

17 de Septiembre de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GIMENEZ SEVILLA JOSE-LUIS;ESPA脩OL REALP ANTONIO-JOSE;ARBILLA SAMPOLIGNACIO;CARRO RODRIGUEZ GONZALO;BONET OLIVART ANA;LARRAINZAR ALOY IGNACIO-JESUS;LOPEZ ARCEDIANOMARIANO;DEULOFEU FUGUET LUIS;PEREZ CANTO ANTONIO JOSE;SANCHEZ FARRE FRANCESC Datos registrales. T 1072 ,F 98, S 8, H LE 14181, I/A 82 (10.09.14).

09 de Mayo de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIMENEZ SEVILLA JOSE-LUIS;ESPA脩OL REALP ANTONIO-JOSE;ARBILLA SAMPOLIGNACIO;CARRO RODRIGUEZ GONZALO;BONET OLIVART ANA;LARRAINZAR ALOY IGNACIO-JESUS;LOPEZ ARCEDIANOMARIANO;DEULOFEU FUGUET LUIS;GARCIA BURGOS ANA MARIA;SANCHEZ FARRE FRANCESC. Datos registrales. T 1072 , F96, S 8, H LE 14181, I/A 81 ( 5.05.14).

08 de Marzo de 2013
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;ESPA脩OL REALP ANTONIO-JOSE;ARBILLA SAMPOLIGNACIO;CARRO RODRIGUEZ GONZALO;FERNANDEZ MARTIN ROSARIO;FUERTES GARCIA JOSE ANGEL;LARRAINZAR ALOYIGNACIO-JESUS;LOPEZ ARCEDIANO MARIANO;PEREZ ARENAS RAFAEL;ALJARO NAVARRO FRANCISCO JOSE;CORONAS

08 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1072 , F 93, S 8, H LE 14181, I/A 76 (30.10.12).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LOPEZ CASAS JOSE ANTONIO;GIMENEZ SEVILLA JOSE-LUIS. Nombramientos. Adm. Solid.:ALJARO NAVARRO FRANCISCO JOSE;CORONAS GUINART JOSEP MARIA. Datos registrales. T 1072 , F 94, S 8, H LE 14181,I/A 77 (30.10.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIMENEZ SEVILLA JOSE-LUIS;ESPA脩OL REALP ANTONIO-JOSE;ARBILLA SAMPOLIGNACIO;CARRO RODRIGUEZ GONZALO;BONET OLIVART ANA;LARRAINZAR ALOY IGNACIO-JESUS;LOPEZ ARCEDIANOMARIANO;DEULOFEU FUGUET LUIS;PEREZ CANTO ANTONIO JOSE;SANCHEZ FARRE FRANCESC Datos registrales. T 1072 ,F 94, S 8, H LE 14181, I/A 78 (30.10.12).

Nombramientos. Apoderado: FUERTES GARCIA JOSE ANGEL. Datos registrales. T 1072 , F 96, S 8, H LE 14181, I/A 79(30.10.12).

31 de Enero de 2012
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;ARBILLA SAMPOL IGNACIO;CARRO RODRIGUEZGONZALO;FERNANDEZ MARTIN ROSARIO;FUERTES GARCIA JOSE ANGEL;PEREZ ARENAS RAFAEL;ZABIA LASALAJUAN;ALJARO NAVARRO FRANCISCO JOSE;CORONAS GUINART JOSE MARIA;REYNES MASSANET FRANCISCO;RODRIGUEZMARTINEZ JOSE LUIS;SANCHEZ FARRE FRANCESC;SOUCHEIRON MARCET ALBERT. Datos registrales. T 1072 , F 93, S 8, HLE 14181, I/A 75 (20.01.12).

21 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1072 , F 93, S 8, H LE 14181, I/A74 (12.12.11).

08 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARTINEZ VILA JOSEP. Nombramientos. Adm. Solid.: REYNES MASSANET FRANCISCO.Datos registrales. T 1072 , F 93, S 8, H LE 14181, I/A 73 (27.10.11).

19 de Mayo de 2011
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ CASAS JOSE ANTONIO;RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;IGLESIAS VALDESGONZALO;ARBILLA SAMPOL IGNACIO;CARRO RODRIGUEZ GONZALO;FERNANDEZ MARTIN ROSARIO;FUERTES GARCIAJOSE ANGEL;PEREZ ARENAS RAFAEL;ALJARO NAVARRO FRANCISCO JOSE;MARGENAT PADROS JUAN ARTURO;MARTINEZVILA JOSEP;REYNES MASSANET FRANCISCO;RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS;SANCHEZ FARREFRANCESC;SOUCHEIRON MARCET ALBERT;ZABIA LASALA JUAN. Datos registrales. T 1072 , F 90, S 8, H LE 14181, I/A 70(10.05.11).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;ESPA脩OL REALP ANTONIO-JOSE;ARBILLA SAMPOLIGNACIO;CARRO RODRIGUEZ GONZALO;FERNANDEZ MARTIN ROSARIO;FUERTES GARCIA JOSE ANGEL;LARRAINZAR ALOYIGNACIO-JESUS;LOPEZ ARCEDIANO MARIANO;PEREZ ARENAS RAFAEL;ALJARO NAVARRO FRANCISCO JOSE;CORONASGUINART JOSE MARIA;LAGARES PUIG JORDI;REYNES MASSANET FRANCISCO;RODRIGUEZ MARTINEZ JOSELUIS;SANCHEZ FARRE FRANCESC;SOUCHEIRON MARCET ALBERT. Datos registrales. T 1072 , F 91, S 8, H LE 14181, I/A 71(10.05.11).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MORERA BOSCH JOSE MARIA. Nombramientos. Adm. Solid.: GIMENEZ SEVILLA JOSE-LUIS.Datos registrales. T 1072 , F 92, S 8, H LE 14181, I/A 72 (10.05.11).

10 de Marzo de 2011
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1072 , F 90, S 8, H LE 14181, I/A69 ( 1.03.11).

13 de Diciembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ CASAS JOSE ANTONIO;RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;IGLESIAS VALDESGONZALO;FERNANDEZ MARTIN ROSARIO;HENCHE HERNANDEZ BEATRIZ;OLABARRIA RUIZ JAVIER DE;OLMO RODRIGUEZJUAN ANTONIO DEL;PEREZ ARENAS RAFAEL;ZABIA LASALA JUAN;ZAMORANO MARTIN JUAN;CARRO RODRIGUEZGONZALO;FUERTES GARCIA JOSE ANGEL;MARTINEZ VILA JOSEP;ALJARO NAVARRO FRANCISCO JOSE;MARGENATPADROS JUAN ARTURO;SOUCHEIRON MARCET ALBERT;SANCHEZ FARRE FRANCESC;RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS.Datos registrales. T 1072 , F 90, S 8, H LE 14181, I/A 68 (30.11.10).

24 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;ARBILLA SAMPOL IGNACIO;CARRO RODRIGUEZGONZALO;FERNANDEZ MARTIN ROSARIO;FUERTES GARCIA JOSE ANGEL;PEREZ ARENAS RAFAEL;ZABIA LASALAJUAN;ALJARO NAVARRO FRANCISCO JOSE;CORONAS GUINART JOSE MARIA;REYNES MASSANET FRANCISCO;RODRIGUEZMARTINEZ JOSE LUIS;SANCHEZ FARRE FRANCESC;SOUCHEIRON MARCET ALBERT. Datos registrales. T 1072 , F 88, S 8, HLE 14181, I/A 67 (15.09.10).

24 de Mayo de 2010
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ CASAS JOSE ANTONIO;RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;IGLESIAS VALDESGONZALO;ARBILLA SAMPOL IGNACIO;CARRO RODRIGUEZ GONZALO;FERNANDEZ MARTIN ROSARIO;FUERTES GARCIAJOSE ANGEL;PEREZ ARENAS RAFAEL;ALJARO NAVARRO FRANCISCO JOSE;MARGENAT PADROS JUAN ARTURO;MARTINEZVILA JOSEP;REYNES MASSANET FRANCISCO;RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS;SANCHEZ FARREFRANCESC;SOUCHEIRON MARCET ALBERT;ZABIA LASALA JUAN. Datos registrales. T 1072 , F 86, S 8, H LE 14181, I/A 66(14.05.10).

05 de Febrero de 2010
Nombramientos. Apoderado: GARCIA GOMEZ NURIA-TERESA. Datos registrales. T 1072 , F 86, S 8, H LE 14181, I/A 65(28.01.10).

03 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: ARMENTIA AMANTEGUI ANDONI. Datos registrales. T 1072 , F 85, S 8, H LE 14181, I/A 63(23.10.09).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1072 , F 86, S 8, H LE 14181, I/A64 (23.10.09).

20 de Julio de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ ARCEDIANO MARIANO;BASTIDA DE DIEGO MARIA TERESA;SANCHEZ ALBARRAN OSCAR.Datos registrales. T 1072 , F 85, S 8, H LE 14181, I/A 61 ( 9.07.09).

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ LOPEZ ANTONIA;MARTINEZ LOPEZ ANTONIA;RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;MORERABOSCH JOSE MARIA;OLABARRIA RUIZ FRANCISCO JAVIER DE;OLABARRIA RUIZ FRANCISCO JAVIER DE;MARTINEZ LOPEZANTONIA;RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO;TORRES ZABALA JOSE MARIA DE. Datos registrales.T 1072 , F 85, S 8, H LE 14181, I/A 62 ( 9.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n