Actos BORME de Autoprais Sl
24 de Noviembre de 2014Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 698/2010. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 30/09/2014. Auto de conclusi贸n delconcurso. Inexistencia de bienes. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Y MERCANTIL. Juez: AURELIA BELLOFERNANDEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 698/2010. Fecha de resoluci贸n 1/06/2010. Revocaci贸n deadministradores concursales. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Y MERCANTIL. Juez: AURELIA BELLO FERNANDEZ.Administrador Concursal. Fecha 30/09/2014, NIF/CIF 33801513T. RODRIGUEZ DOCAMPO ENRIQUE JESUS. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 698/2010. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 30/09/2014. Cese de las limitaciones de las facultades deadministraci贸n. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Y MERCANTIL. Juez: AURELIA BELLO FERNANDEZ. Extinci贸n.Datos registrales. T 416 , F 163, S 8, H LU 4739, I/A 25 (13.11.14).
23 de Julio de 2010Revocaciones. Apoderado: MOYA MENDIETA MARTIN. Apo.Manc.: APARICIO DESIDERIO ANA;MOYA MENDIETA MARTIN.Datos registrales. T 416 , F 163, S 8, H LU 4739, I/A 24 (10.07.10).
02 de Julio de 2010Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 698/2010. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 1/06/2010. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Y MERCANTIL. Juez: AURELIA BELLO FERNANDEZ.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 698/2010. Fecha de resoluci贸n 1/06/2010. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 2 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Y MERCANTIL. Juez: AURELIA BELLO FERNANDEZ. Administrador Concursal.Fecha 1/06/2010, NIF/CIF 33801513T. RODRIGUEZ DOCAMPO ENRIQUE JESUS. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal698/2010. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 1/06/2010. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades deadministraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Y MERCANTIL. Juez: AURELIA BELLOFERNANDEZ. Datos registrales. T 416 , F 162, S 8, H LU 4739, I/A C (21.06.10).
11 de Junio de 2010Cambio de domicilio social. CTRA DE A CORU脩A 143 (LUGO). Datos registrales. T 416 , F 162, S 8, H LU 4739, I/A 22(27.05.10).
14 de Abril de 2010Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ BARCIA RAMON. Datos registrales. T 400 , F 163, S 8, H LU 4739, I/A 21 (29.03.10).
23 de Febrero de 2010Reelecciones. Auditor: AUDITORES CONSULTORES Y EXPERTOS INDEPENDIENTES SR. Datos registrales. T 400 , F 163, S 8,H LU 4739, I/A 20 (10.02.10).
25 de Marzo de 2009Nombramientos. Apoderado: MOYA MENDIETA MARTIN. Datos registrales. T 400 , F 161, S 8, H LU 4739, I/A 16 (10.03.09).
Nombramientos. Apoderado: APARICIO DESIDERIO ANA. Datos registrales. T 400 , F 162, S 8, H LU 4739, I/A 17 (10.03.09).
Nombramientos. Apo.Manc.: APARICIO DESIDERIO ANA;MOYA MENDIETA MARTIN. Datos registrales. T 400 , F 162, S 8, H LU4739, I/A 18 (10.03.09).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ BARCIA RAMON. Datos registrales. T 400 , F 162, S 8, H LU 4739, I/A 19 (10.03.09).
26 de Febrero de 2009Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ GARCIA RAMON. Apo.Man.Soli: NU脩EZ GONZALEZ JOSE LUIS;SAEZ ABUIN JOSEMANUEL. Datos registrales. T 400 , F 161, S 8, H LU 4739, I/A 15 (12.02.09).
12 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: CARIDE CORTIZO JOSE;CARIDE PUENTE JUAN CARLOS;CARIDE PUENTE ANDRES;IGLESIASVAZQUEZ ANTONIO. Cons.Del.Sol: CARIDE CORTIZO JOSE. Presidente: CARIDE CORTIZO JOSE. Secretario: CARIDE PUENTEJUAN CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO MOYVESA SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 400 , F 161, S 8, H LU 4739, I/A 14 (30.01.09).