Actos BORME de Autopremier Baviera Sa
09 de Febrero de 2023Modificaciones estatutarias. Se modifica el art铆culo 27 de los estatutos estableciendo el car谩cter retribuido del cargo deadministrador . Datos registrales. T 38057 , F 195, S 8, H M 118429, I/A 10 ( 2.02.23).
09 de Julio de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.000.000,26 Euros. Desembolsado: 1.000.000,26 Euros. Resultante Suscrito: 1.060.200,26 Euros.Resultante Desembolsado: 1.060.200,26 Euros. Datos registrales. T 38057 , F 194, S 8, H M 118429, I/A 9 ( 2.07.21).
26 de Marzo de 2019Cambio de domicilio social. CTRA DE VALENCIA Km 7,300 (MADRID). Datos registrales. T 38057 , F 194, S 8, H M 118429, I/A 8(19.03.19).
28 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARTINEZ SANCHEZ GERARDO;MARTINEZ SANCHEZ JOSE JAVIER. Nombramientos.Consejero: MARTINEZ SANCHEZ JOSE JAVIER;MARTINEZ SANCHEZ GERARDO;MARTINEZ SANCHEZ JULIOFERNANDO;MARTINEZ SANCHEZ ADRIAN DIEGO. Presidente: MARTINEZ SANCHEZ GERARDO. Secretario: MARTINEZSANCHEZ JULIO FERNANDO. Cons.Del.Man: MARTINEZ SANCHEZ JOSE JAVIER;MARTINEZ SANCHEZ GERARDO;MARTINEZSANCHEZ JULIO FERNANDO;MARTINEZ SANCHEZ ADRIAN DIEGO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 622 , F 77, S 8, H GU 6468, I/A 17 (18.02.19).
14 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Auditor: GALVEZ AUDITORES S.L.P. Nombramientos. Auditor: CARPE AUDITORIA SLP. Datos registrales.T 622 , F 77, S 8, H GU 6468, I/A 16 ( 4.12.18).
15 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ SANCHEZ JOSE JAVIER;MARTINEZ SANCHEZ GERARDO;MARTINEZ SANCHEZ JULIOFERNANDO;MARTINEZ SANCHEZ ADRIAN DIEGO;VENTURA CARO JOSE MARIA;PLAZA GARCIA JUAN PEDRO. Datosregistrales. T 568 , F 168, S 8, H GU 6468, I/A 13 ( 7.06.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: APRO CONSTRUCTION MANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 622 , F 76, S 8, HGU 6468, I/A 14 ( 7.06.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: PYRAMID CONSULTING S.L. Datos registrales. T 622 , F 77, S 8, H GU 6468, I/A 15 ( 7.06.18).
16 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: VENTURA CARO JOSE MARIA;PLAZA GARCIA JUAN PEDRO. Datos registrales. T 568 , F 166, S8, H GU 6468, I/A 12 ( 5.03.18).
27 de Octubre de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MOMENTUM MOTOR MADRID SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CORROMARTIN CARLOS ALBERTO;MARTINEZ LOPEZ PABLO. Nombramientos. Adm. Solid.: MARTINEZ SANCHEZGERARDO;MARTINEZ SANCHEZ JOSE JAVIER. Datos registrales. T 568 , F 165, S 8, H GU 6468, I/A 11 (16.10.17).
06 de Noviembre de 2015Revocaciones. Auditor: GALVEZ AUDITORES S.L.P. Datos registrales. T 568 , F 165, S 8, H GU 6468, I/A 9 (26.10.15).
Nombramientos. Auditor: GALVEZ AUDITORES S.L.P. Datos registrales. T 568 , F 165, S 8, H GU 6468, I/A 10 (26.10.15).