Actos BORME de Autos Montalt Sa
23 de Octubre de 2023Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: VALSUR-CAR S.A. Datos registrales. T 10537, L 7818, F 168, S 8, H V 22815, I/A90 (16.10.23).
04 de Agosto de 2023Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GM NEOLOGIC SL. Datos registrales. T 10537, L 7818, F 168, S 8,H V 22815, I/A 89 (28.07.23).
09 de Diciembre de 2022Nombramientos. Auditor: ESPACIO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 10537, L 7818, F 167, S 8, H V 22815, I/A 88(18.11.22).
24 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: BARCELO TOMAR SALVADOR. Datos registrales. T 10537, L 7818, F 167, S 8, H V 22815, I/A 86(17.05.22).
Nombramientos. Apoderado: MARTIN MACHO ALBERTO. Datos registrales. T 10537, L 7818, F 167, S 8, H V 22815, I/A 87(17.05.22).
24 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: HALL FIELDS MARTIN ANTHONY. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 214, S 8, H V 22815, I/A 85(17.03.22).
16 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: DURA CATALA JUAN ELOY. Secretario: DONAT ALIAGA EMILIO. Consejero: DONAT ALIAGAEMILIO;POYATOS GARCIA BARTOLOME. Presidente: DURA CATALA JUAN ELOY. Cons.Del.Sol: POYATOS GARCIABARTOLOME;DONAT ALIAGA EMILIO. Nombramientos. Adm. Unico: MARCOS BA脩ULS FRANCISCO JOAQUIN. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 4358, L
Nombramientos. Apoderado: VERDEJO GARCIA DAVID. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 213, S 8, H V 22815, I/A 83 (9.02.22).
Revocaciones. Apoderado: MONLLOR ROCA RAFAEL GENARO;BARCELO TOMAR SALVADOR;MARTIN MACHO ALBERTO.Datos registrales. T 4358, L 1670, F 214, S 8, H V 22815, I/A 84 ( 9.02.22).
21 de Diciembre de 2020Otros conceptos: Revocado el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL como auditor de cuentas delGRUPO CONSOLIDADO de MONTALT antes de finalizar el periodo para el que inicialmente fue nombrado, por concurrir justa causa,con efectos a partir del ejercicio 2020. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 212, S 8, H V 22815, I/A 81 (14.12.20).
18 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: PRATS GOMEZ ANTONIO JOSE. Apo.Manc.: HERNANDEZ PEREZ EMILIA;OLTRA BENAVENTMARCOS ANTONIO;MARTIN SAEZ ARACELI. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 211, S 8, H V 22815, I/A 79 (11.12.20).
Nombramientos. Apoderado: CRUZ RUEDAS JUAN. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 211, S 8, H V 22815, I/A 80 (11.12.20).
02 de Octubre de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 8.676.138,17 Euros. Resultante Suscrito: 2.208.596,87 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: ARTICULO 5..- El capital social se fija en DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MILQUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS Y OCHENTA Y SIETE CENTIMOS -2.208.596,87 Euros-, dividido y representado porTRESCIENTAS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y SIETE acciones nominativas. Escisi贸n parcial.Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: GRUPO MONTALT SERVICAR SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4358, L 1670, F210, S 8, H V 22815, I/A 78 (25.09.20).
07 de Julio de 2020Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRUPO MONTALT SERVICAR SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4358,L 1670, F 209, S 8, H V 22815, I/A 76 (30.06.20).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 10.604.999,59 Euros. Desembolsado: 10.604.999,59 Euros. Resultante Suscrito: 10.884.735,04Euros. Resultante Desembolsado: 10.884.735,04 Euros. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 210, S 8, H V 22815, I/A 77 (30.06.20).
20 de Abril de 2020Nombramientos. Apoderado: FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPA脩A. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 209, S 8, H V 22815,I/A 75 (14.04.20).
15 de Enero de 2020Reelecciones. Consejero: DURA CATALA JUAN ELOY. Secretario: DONAT ALIAGA EMILIO. Consejero: DONAT ALIAGAEMILIO;POYATOS GARCIA BARTOLOME. Presidente: DURA CATALA JUAN ELOY. Cons.Del.Sol: POYATOS GARCIABARTOLOME;DONAT ALIAGA EMILIO. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 208, S 8, H V 22815, I/A 74 ( 8.01.20).
26 de Diciembre de 2019Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 208, S 8, H V 22815, I/A 73 (18.12.19).
30 de Mayo de 2019Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 208, S 8, HV 22815, I/A 72 (24.05.19).
23 de Mayo de 2019Nombramientos. Apoderado: BARCELO TOMAR SALVADOR. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 207, S 8, H V 22815, I/A 71(16.05.19).
15 de Febrero de 2019Fusi贸n por uni贸n. Sociedades que se fusi贸nan: GRUPO 4 AUTOMOCION SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4358, L1670, F 207, S 8, H V 22815, I/A 70 ( 8.02.19).
23 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apoderado: DONAT ALIAGA EMILIO. Apo.Sol.: POYATOS GARCIA BARTOLOME. Apoderado: POYATOS GARCIABARTOLOME;PRATS GOMEZ ANTONIO JOSE. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 207, S 8, H V 22815, I/A 69 (16.11.18).
02 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: PRATS GOMEZ ANTONIO JOSE. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 205, S 8, H V 22815, I/A 67(25.09.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: MARTIN SAEZ ARACELI;OLTRA BENAVENT MARCOS ANTONIO;HERNANDEZ PEREZ EMILIA.Datos registrales. T 4358, L 1670, F 206, S 8, H V 22815, I/A 68 (25.09.18).
20 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: MONLLOR ROCA RAFAEL GENARO. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 204, S 8, H V 22815, I/A65 (10.08.18).
Nombramientos. Apoderado: MARTIN MACHO ALBERTO. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 204, S 8, H V 22815, I/A 66(10.08.18).
30 de Julio de 2018Revocaciones. Apoderado: ORTELLS GRANDAL JUAN. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 203, S 8, H V 22815, I/A 64(23.07.18).
02 de Julio de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 203, S 8, HV 22815, I/A 63 (25.06.18).
13 de Junio de 2017Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 203, S 8, HV 22815, I/A 62 ( 6.06.17).
04 de Noviembre de 2016Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 203, S 8, HV 22815, I/A 61 (27.10.16).
10 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: DONAT ALIAGA EMILIO;POYATOS GARCIA BARTOLOME. Nombramientos. Cons.Del.Sol:POYATOS GARCIA BARTOLOME;DONAT ALIAGA EMILIO. Reelecciones. Consejero: DURA CATALA JUAN ELOY. Secretario:DONAT ALIAGA EMILIO. Consejero: DONAT ALIAGA EMILIO;POYATOS GARCIA BARTOLOME. Presidente: DURA CATALA JUANELOY. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 202, S 8, H V 22815, I/A 60 ( 1.04.15).
22 de Octubre de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: PRATS GOMEZ ANTONIO JOSE;MARTIN SAEZ ARACELI CONCEPCION;OLTRA BENAVENTMARCOS ANTONIO. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 201, S 8, H V 22815, I/A 58 (15.10.14).
Nombramientos. Apoderado: PRATS GOMEZ ANTONIO JOSE. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 201, S 8, H V 22815, I/A 59(15.10.14).
13 de Octubre de 2014Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 187, S 8, H V 22815, I/A 57 ( 6.10.14).
01 de Julio de 2013Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 187, S 8, H V 22815, I/A 55 (24.06.13).
Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 187, S 8, H V 22815, I/A 56 (24.06.13).
26 de Agosto de 2011Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 187, S 8, H V 22815, I/A 54 (17.08.11).
26 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: DURA CATALA JUAN ELOY. Presidente: DURA CATALA JUAN ELOY. Cons.Del.Sol: DONATALIAGA EMILIO. Secretario: DONAT ALIAGA EMILIO. Consejero: DONAT ALIAGA EMILIO;POYATOS GARCIA BARTOLOME.Cons.Del.Sol: POYATOS GARCIA BARTOLOME. Vicesecret.: FITA TORTOSA FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: DURACATALA JUAN ELOY;DONAT ALIAGA EMILIO;POYATOS GARCIA BARTOLOME. Presidente: DURA CATALA JUAN ELOY.Secretario: DONAT ALIAGA EMILIO. Cons.Del.Sol: DONAT ALIAGA EMILIO;POYATOS GARCIA BARTOLOME. Datos registrales. T4358, L 1670, F 185, S 8, H V 22815, I/A 52 (15.04.10).
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 187, S 8, H V 22815, I/A 53 (15.04.10).
10 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: POYATOS GARCIA BARTOLOME;DONAT ALIAGA EMILIO. Nombramientos. Cons.Del.Sol:DONAT ALIAGA EMILIO;POYATOS GARCIA BARTOLOME. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 185, S 8, H V 22815, I/A 51 (1.03.10).
18 de Noviembre de 2009Nombramientos. Cons.Del.Sol: DONAT ALIAGA EMILIO;POYATOS GARCIA BARTOLOME. Datos registrales. T 4358, L 1670, F185, S 8, H V 22815, I/A 50 ( 6.11.09).
13 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: DURA CATALA JUAN ELOY. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 185, S 8, H V 22815, I/A 49 (3.11.09).
20 de Agosto de 2009Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 184, S 8, H V 22815, I/A 47 (11.08.09).
Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4358, L 1670, F 184, S 8, H V 22815, I/A 48 (11.08.09).
19 de Agosto de 2009Fe de erratas: El auditor nombrado fue la mercantil "ERNST & YOUNG SL". Datos registrales. T 4358, L 1670, F 183, S 8, H V22815, I/A 41 ( 1.04.06).