Actos BORME de Autovia De La Mancha Sociedad Anonima Concesionaria De La Junta De Comunidades De Castilla-la Mancha
16 de Agosto de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1638 , F 187, S 8, H TO 19397, I/A 64 ( 7.08.23).
08 de Junio de 2023Otros conceptos: Cambiado el representante persona física del consejero "DESARROLLO DE CONCESIONES FERROVIARIASSL", pasando a ser DON SALVADOR MYRO CUENCO, con D.N.I. 33525544-P. Datos registrales. T 1638 , F 187, S 8, H TO 19397,I/A 63 ( 1.06.23).
09 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: PABLO ALARCON ROJAS. Apo.Manc.: PABLO ALARCON ROJAS;PABLO ALARCON ROJAS. Apo.Sol.:JOSE ANGEL VALDEMORO GIL-FOURNIER. Nombramientos. Apo.Sol.: PABLO ALARCON ROJAS;JOSE ANGEL VALDEMOROGIL-FOURNIER. Apo.Manc.: JOSE ANGEL VALDEMORO GIL-FOURNIER;PABLO ALARCON ROJAS. Datos registrales. T 1638 , F
24 de Agosto de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1638 , F 184, S 8, H TO 19397, I/A 61 (17.08.22).
07 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: RODRIGUEZ-ESCUDERO VAZQUEZ ALMUDENA. Nombramientos. Vicesecret.: VILLARREJAS MONICA. Datos registrales. T 1638 , F 184, S 8, H TO 19397, I/A 60 (30.06.22).
16 de Diciembre de 2021Reelecciones. Consejero: DESARROLLO DE CONCESIONES VIARIAS UNO SL. Presidente: DESARROLLO DE CONCESIONESVIARIAS UNO SL. Consejero: DESARROLLO DE CONCESIONES FERROVIARIAS SL. Datos registrales. T 1638 , F 183, S 8, H TO19397, I/A 59 ( 9.12.21).
22 de Julio de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1638 , F 183, S 8, H TO 19397, I/A 58 (15.07.21).
05 de Julio de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: MERIDA ARIZA MARIA DEL CARMEN. Apoderado: MERIDA ARIZA MARIA DEL CARMEN;MERIDAARIZA MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Apo.Sol.: VALDEMORO GIL-FOURNIER JOSE ANGEL. Datos registrales. T 1638, F 182, S 8, H TO 19397, I/A 57 (24.06.21).
18 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1638 , F 182, S 8, H TO 19397, I/A 56 (10.12.20).
04 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: MUNGUIRA DE LA FUENTE CASADO MARIANO. Datos registrales. T 1638 , F 182, S 8, H TO19397, I/A 55 (27.07.20).
18 de Febrero de 2020Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1638 , F 181, S 8, H TO 19397, I/A 54 (11.02.20).
10 de Octubre de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1638 , F 181, S 8, H TO 19397, I/A 53 ( 1.10.18).
29 de Agosto de 2018Reelecciones. Consejero: IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA;ALCALA SANCHEZ CAMILO-JOSE. Datosregistrales. T 1638 , F 181, S 8, H TO 19397, I/A 52 (20.08.18).
04 de Octubre de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1638 , F 181, S 8, H TO 19397, I/A 51 (26.09.17).
26 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: MERIDA ARIZA MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 1638 , F 181, S 8, H TO 19397, I/A 50(18.05.17).
17 de Abril de 2017Otros conceptos: CAMBIADO EL REPRESENTANTE DE LA CONSEJERA DESARROLLO DE CONCESIONES FERROVIARIAS SLPASANDO A SER ROYO IBAÑEZ, CARLOS CON DNI 46344391N. Datos registrales. T 1613 , F 225, S 8, H TO 19397, I/A 49 (6.04.17).
04 de Noviembre de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1613 , F 225, S 8, H TO 19397, I/A 48 (27.10.16).
14 de Octubre de 2016Reelecciones. Consejero: DESARROLLO DE CONCESIONES FERROVIARIAS SL;DESARROLLO DE CONCESIONES VIARIASUNO SL. Presidente: DESARROLLO DE CONCESIONES VIARIAS UNO SL. Datos registrales. T 1613 , F 225, S 8, H TO 19397, I/A47 ( 6.10.16).
11 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: BLANCO CABALLERO DAVID. Apoderado: BLANCO CABALLERO DAVID. Apo.Manc.: BLANCOCABALLERO DAVID. Nombramientos. Apoderado: ALARCON ROJAS PABLO. Apo.Manc.: ALARCON ROJAS PABLO;ALARCONROJAS PABLO. Datos registrales. T 1568 , F 64, S 8, H TO 19397, I/A 46 ( 3.12.15).
05 de Noviembre de 2015Otros conceptos: Cambiada la persona física representante del consejero "IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA"cesando D.David Blanco Caballero y designando a D. PABLO ALARCON ROJAS. Datos registrales. T 1568 , F 64, S 8, H TO 19397,I/A 45 (29.10.15).
27 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Secretario: ALCARAZ CALVO ANTONIO. Nombramientos. Secretario: CYOPSA-SISOCIA SA. Datosregistrales. T 1568 , F 63, S 8, H TO 19397, I/A 44 (15.10.15).
14 de Agosto de 2015Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1568 , F 63, S 8, H TO 19397, I/A 43 ( 6.08.15).
27 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: DONOSO PARRADO JOSE LUIS. Nombramientos. VsecrNoConsj: RODRIGUEZ-ESCUDEROVAZQUEZ ALMUDENA. Datos registrales. T 1568 , F 63, S 8, H TO 19397, I/A 41 (19.02.15).
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1568 , F 63, S 8, H TO 19397, I/A 42 (19.02.15).
07 de Julio de 2014Otros conceptos: Cambiado el representante persona física del Consejero DESARROLLO DE CONCESIONES VIARIAS UNO SLsiendo el actual DON ANTONIO DE LA LLAMA CAMPILLO. Datos registrales. T 1568 , F 62, S 8, H TO 19397, I/A 40 (30.06.14).
21 de Abril de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1568 , F 62, S 8, H TO 19397, I/A 39 ( 8.04.14).
14 de Marzo de 2014Reelecciones. Consejero: IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA;ALCALA SANCHEZ CAMILO-JOSE. Datosregistrales. T 1568 , F 62, S 8, H TO 19397, I/A 38 ( 6.03.14).
20 de Agosto de 2013Nombramientos. Apoderado: BLANCO CABALLERO DAVID. Datos registrales. T 1568 , F 62, S 8, H TO 19397, I/A 37 (12.08.13).
13 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: ALVAREZ-CIENFUEGOS ROZAS LOURDES. Nombramientos. VsecrNoConsj: DONOSOPARRADO JOSE LUIS. Datos registrales. T 1512 , F 222, S 8, H TO 19397, I/A 36 ( 6.06.13).
29 de Abril de 2013Otros conceptos: Hecho constar el CAMBIO DE REPRESENTANTE PERSONA FISICA DELCONSJEERO, IRIDIUMCONCESIONES DE INFRAESTRCUTURAS SA, PASANDO A SER DON DAVID BLANCO CABALLERO, CON DNI 00839987G.Datos registrales. T 1512 , F 222, S 8, H TO 19397, I/A 35 (15.04.13).
17 de Abril de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ ROBLES JESUS. Apo.Manc.: RODRIGUEZ ROBLES JESUS;RODRIGUEZ ROBLES JESUS.Apo.Sol.: MUNGUIRA DE LA FUENTE CASADO MARIANO. Apo.Manc.: MUNGUIRA DE LA FUENTE CASADO MARIANO.Nombramientos. Apoderado: BLANCO CABALLERO DAVID. Apo.Manc.: BLANCO CABALLERO DAVID;BLANCO CABALLERODAVID. Apoderado: MUNGUIRA DE LA FUENTE CASADO MARIANO. Apo.Manc.: MUNGUIRA DE LA FUENTE CASADO MARIANO.Datos registrales. T 1512 , F 220, S 8, H TO 19397, I/A 34 (10.04.13).
30 de Agosto de 2012Otros conceptos: CAMBIADA LA PERSONA FISICA REPRESENTANTE DEL CONSEJERO Y PRESIDENTE, DESARROLLO DECONCESIONES VIARIAS UNO SL, SIENDO ACTUALMENTE DON CARLOS ROYO IBAÑEZ. Datos registrales. T 1512 , F 219, S 8,H TO 19397, I/A 33 (20.08.12).
19 de Julio de 2012Otros conceptos: Sustituido el representante persona física del consejero "DESARROLLO DE CONCESIONES FERROVIARIAS SL",D. Adolfo Valderas Martínez, designando en su lugar a D. Santiago García Salvador. Datos registrales. T 1512 , F 219, S 8, H TO19397, I/A 32 ( 9.07.12).
12 de Julio de 2011Reelecciones. Consejero: DESARROLLO DE CONCESIONES FERROVIARIAS SL;DESARROLLO DE CONCESIONES VIARIASUNO SL. Presidente: DESARROLLO DE CONCESIONES VIARIAS UNO SL. Datos registrales. T 1512 , F 219, S 8, H TO 19397, I/A31 (30.06.11).
20 de Mayo de 2011Otros conceptos: Cambiado el representante persona física de DESARROLLO DE CONCESIONES FERROVIARIAS SL. Datosregistrales. T 1512 , F 219, S 8, H TO 19397, I/A 30 ( 9.05.11).
19 de Abril de 2011Otros conceptos: Rectificado el D.N.I. del apoderado DON JESUS RODRIGUEZ ROBLES, siendo el correcto: 386.616-D. Datosregistrales. T 1512 , F 219, S 8, H TO 19397, I/A 29 ( 7.04.11).
24 de Febrero de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1512 , F 218, S 8, H TO 19397, I/A 28 (14.02.11).
08 de Febrero de 2011Revocaciones. Apoderado: MENDOZA GUILLE ANGEL. Apo.Manc.: MENDOZA GUILLE ANGEL;MENDOZA GUILLEANGEL;MENDOZA GUILLE ANGEL. Apo.Sol.: GONZALEZ GOMEZ NAVARRO JOSE-MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.:RODRIGUEZ ROBLES JESUS. Apo.Manc.: RODRIGUEZ ROBLES JESUS;RODRIGUEZ ROBLES JESUS. Apo.Sol.: MUNGUIRA DELA FUENTE CASADO MARIANO. Apo.Manc.: MUNGUIRA DE LA FUENTE CASADO MARIANO. Datos registrales. T 1440 , F 102,S 8, H TO 19397, I/A 27 (25.01.11).
24 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: DONOSO PARRADO JOSE LUIS. Revocaciones. Apo.Manc.: ARIÑO PEÑALVER MANUEL.Apo.Sol.: ARIÑO PEÑALVER MANUEL. Apo.Manc.: ARIÑO PEÑALVER MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ GOMEZNAVARRO JOSE-MIGUEL. Apo.Manc.: GONZALEZ GOMEZ NAVARRO JOSE-MIGUEL. VsecrNoConsj: ALVAREZ-CIENFUEGOSROZAS LOURDES. Reelecciones. Consejero: ALCALA SANCHEZ CAMILO-JOSE;IRIDIUM CONCESIONES DEINFRAESTRUCTURAS SA. Datos registrales. T 1440 , F 100, S 8, H TO 19397, I/A 24 (12.03.10).