Actos BORME de Autovia Del Arlanzon Sa
10 de Octubre de 2022Reelecciones. Consejero: GOMEZ COLLADO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 766, L 557, F 41, S 8, H BU 12385, I/A 71 (4.10.22).
14 de Julio de 2022Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 766, L 557, F 41, S 8, H BU 12385, I/A 70 ( 8.07.22).
16 de Marzo de 2022Modificaciones estatutarias. Art铆culos 17 y 32.- Se establece la posibilidad de que las reuniones de la Junta General y del Consejode Administraci贸n, se celebren de forma telem谩tica.. Datos registrales. T 766, L 557, F 40, S 8, H BU 12385, I/A 68 (10.03.22).
17 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: CORRAL FERNANDEZ FELIX;EGUIA DIAZ SANTIAGO;MARTINEZ MARTINEZ-CA脩AVATEANTONIO;CORRAL FERNANDEZ FELIX;JIMENEZ ORTEGA DOMINGO;MANRIQUE SABATEL FABIO. Nombramientos.Apo.Manc.: RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS;TOBOSO DIAGO JESUS;RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO;GOMEZ DEL RIOSANZ HERNANZ RAFAEL;PELLON REVUELTA LEOPOLDO;MOCHON LOPEZ PABLO. Datos registrales. T 766, L 557, F 37, S 8,H BU 12385, I/A 67 (11.02.22).
21 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 766, L 557, F 37, S 8, H BU 12385, I/A 64 (15.10.21).
29 de Octubre de 2020Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 766, L 557, F 36, S 8, H BU 12385, I/A 62 (23.10.20).
27 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ MARTINEZ-CA脩AVATE ANTONIO;TOBOSO DIAGO JESUS;GOMEZ DEL RIO SANZHERNANZ RAFAEL;CORRAL FERNANDEZ FELIX;MOCHON LOPEZ PABLO;JIMENEZ ORTEGA DOMINGO;MANRIQUE SABATELFABIO;RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS. Datos registrales. T 749, L 540, F 197, S 8, H BU 12385, I/A 61 (21.11.19).
21 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ GOMEZ-NAVARRO JOSE MIGUEL;GONZALEZ GOMEZ-NAVARRO JOSE MIGUEL. Datosregistrales. T 749, L 540, F 197, S 8, H BU 12385, I/A 60 (15.10.19).
05 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: DEDIEU MICHAEL. Nombramientos. Consejero: NALAZEK JAKUB. Datos registrales. T 749, L540, F 197, S 8, H BU 12385, I/A 59 (27.02.19).
30 de Octubre de 2018Reelecciones. Consejero: SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS I SL;SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL;SACYRCONCESIONES PARTICIPADAS IV SL. Presidente: SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS I SL. Datos registrales. T 721, L 512,F 61, S 8, H BU 12385, I/A 58 (24.10.18).
13 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: TOBOSO DIAGO JESUS. Datos registrales. T 721, L 512, F 61, S 8, H BU 12385, I/A 57 ( 7.03.18).
11 de Octubre de 2017Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 721, L 512, F 60, S 8, H BU 12385, I/A 55 ( 4.10.17).
27 de Julio de 2017Reelecciones. Consejero: DEDIEU MICHAEL;GOMEZ COLLADO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 721, L 512, F 60, S 8, HBU 12385, I/A 53 (21.07.17).
15 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: EGUIA DIAZ SANTIAGO;GONZALEZ GOMEZ-NAVARRO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 721, L512, F 59, S 8, H BU 12385, I/A 52 ( 8.03.17).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: TOBOSO DIAGO JESUS;ORDO脩EZ SANZ TOMAS ENRIQUE. Apo.Sol.: REINA GALLARDOANTONIO. Apo.Manc.: TOBOSO DIAGO JESUS;GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL;TOBOSO DIAGO JESUS;GOMEZ DELRIO SANZ HERNANZ RAFAEL;MOCHON LOPEZ PABLO. Apo.Man.Soli: CORRAL FERNANDEZ FELIX. Apo.D.Gral.: GONZALEZGOMEZ-NAVARRO JOSE MIGUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ GOMEZ-NAVARRO JOSE MIGUEL;TOBOSODIAGO JESUS;CORRAL FERNANDEZ FELIX;GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL;MOCHON LOPEZ PABLO. Apo.Sol.:NOTARIO NIETO MARIA;RANZ AZCUTIA ELISA;GARCIA DENCHE MARTA;LIMA FELIX NUNO;PINACHO LASTRES PABLO. Datosregistrales. T 721, L 512, F 56, S 8, H BU 12385, I/A 51 ( 8.03.17).
11 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apoderado: RUFO ACEMEL MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apo.D.Gral.: GONZALEZ GOMEZ-NAVARROJOSE MIGUEL. Datos registrales. T 700, L 491, F 103, S 8, H BU 12385, I/A 50 ( 3.11.16).
30 de Agosto de 2016Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 700, L 491, F 102, S 8, H BU 12385, I/A 49 (24.08.16).
13 de Abril de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTIN GOMEZ VICTOR JAVIER. Datos registrales. T 700, L 491, F 102, S 8, H BU 12385, I/A 47 (7.04.16).
18 de Febrero de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;MIJANGOS GOROZARRI CARLOS. Nombramientos.Apo.Man.Soli: MARTIN GOMEZ VICTOR JAVIER;CORRAL FERNANDEZ FELIX. Datos registrales. T 700, L 491, F 100, S 8, H BU12385, I/A 46 ( 9.02.16).
10 de Febrero de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA. Apo.Manc.: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA;ORIHUELA UZAL JOSEMARIA. Apo.Man.Soli: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA;LOUREDA LOPEZ SILVIA. Apo.Sol.: NAHARRO CASTRILLO JOSEMANUEL;DE SAN JOSE TORIJA JORGE;OSORIO ALONSO SANDRA;RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONSERRAT;BAENA JIMENEZMIGUEL ANGEL;RODRIGUEZ PUYOL MARIA;RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALVARO;GRANIZO PALOMEQUE MARIA. Datosregistrales. T 700, L 491, F 100, S 8, H BU 12385, I/A 45 ( 4.02.16).
13 de Octubre de 2015Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 667, L 458, F 23, S 8, H BU 12385, I/A 42 ( 6.10.15).
03 de Agosto de 2015Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 667, L 458, F 23, S 8, H BU 12385, I/A 41 (28.07.15).
04 de Marzo de 2015Revocaciones. Apoderado: CASTILLO ACU脩A LUIS. Nombramientos. Apoderado: RUFO ACEMEL MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 667, L 458, F 22, S 8, H BU 12385, I/A 39 (26.02.15).
18 de Diciembre de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALCOLADO PAJARON JUAN ANTONIO. Apo.Manc.: ALCOLADO PAJARON JUAN ANTONIO.Nombramientos. Apoderado: CASTILLO ACU脩A LUIS. Datos registrales. T 667, L 458, F 19, S 8, H BU 12385, I/A 38 (11.12.14).
10 de Septiembre de 2013Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 667, L 458, F 18, S 8, H BU 12385, I/A 36 ( 2.09.13).
22 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL;ALCOLADOPAJARON JUAN ANTONIO. Presidente: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS. Nombramientos. Consejero: SACYR CONCESIONESPARTICIPADAS I SL;SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL;SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS IV SL. Presidente:SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS I SL. Datos registrales. T 667, L 458, F 18, S 8, H BU 12385, I/A 35 (16.07.13).
23 de Agosto de 2012Reelecciones. Consejero: GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL. Datos registrales. T 636, L 427, F 152, S 8, H BU 12385,I/A 32 (14.08.12).
Revocaciones. Apo.Manc.: LOUREDA LOPEZ SILVIA;PUENTE ROZALEN JORGE. Nombramientos. Apo.Manc.: ALCOLADOPAJARON JUAN ANTONIO;TOBOSO DIAGO JESUS;MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZRAFAEL;MOCHON LOPEZ PABLO. Datos registrales. T 636, L 427, F 152, S 8, H BU 12385, I/A 33 (14.08.12).
Cambio de domicilio social. CTRA MADRID-IRUN Km 233 - AVDA.PEDERNALES S/N POLI (VILLAGONZALO PEDERNALES).Datos registrales. T 636, L 427, F 154, S 8, H BU 12385, I/A 34 (14.08.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA;GARCIA SAN MIGUEL RODRIGUEZ ALARCON GONZALO.Presidente: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA. Consejero: JALON GONZALEZ EVA;LOUREDA LOPEZ SILVIA. Secretario: RIELVESPILAS MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: DEDIEU MICHAEL;GOMEZ COLLADO MARIA DEL PILAR;ALCOLADOPAJARON JUAN ANTONIO. Presidente: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS. SecreNoConsj: OSMA JIMENEZ ALEJANDRO. Datosregistrales. T 636, L 427, F 151, S 8, H BU 12385, I/A 31 (14.08.12).
18 de Abril de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: OSORIO ALONSO SANDRA;RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONSERRAT;BAENA JIMENEZ MIGUELANGEL;RODRIGUEZ PUYOL MARIA;RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALVARO;GRANIZO PALOMEQUE MARIA. Datos registrales. T636, L 427, F 150, S 8, H BU 12385, I/A 30 ( 4.04.12).
31 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: RIVERO MARTINEZ LUIS. Nombramientos. Consejero: LOUREDA LOPEZ SILVIA. Datosregistrales. T 636, L 427, F 150, S 8, H BU 12385, I/A 29 (20.01.12).
08 de Agosto de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.007.800,00 Euros. Desembolsado: 5.007.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.722.717,00 Euros.Resultante Desembolsado: 23.722.717,00 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 77, S 8, H BU 12385, I/A 27 (28.07.11).
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 636, L 427, F 150, S 8, H BU 12385, I/A 28 (28.07.11).
06 de Junio de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: AYESTA FERNANDEZ-PACHECO FIDEL;ESTEVEZ ALAVEZ GERMAN. Apo.Man.Soli: ALCOLADOPAJARON JUAN ANTONIO. Nombramientos. Apo.Manc.: LOUREDA LOPEZ SILVIA;TOBOSO DIAGO JESUS;MIJANGOSGOROZARRI CARLOS;GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL;PUENTE ROZALEN JORGE. Datos registrales. T 596, L 387,F 76, S 8, H BU 12385, I/A 26 (26.05.11).
18 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO GOROSTIZAGA FERNANDO. Nombramientos. Consejero: JALON GONZALEZ EVA.Datos registrales. T 596, L 387, F 76, S 8, H BU 12385, I/A 25 ( 7.04.11).
10 de Febrero de 2011Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 596, L 387, F 75, S 8, H BU 12385, I/A 24 ( 2.02.11).
25 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: PINO GIRALDEZ MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: DE SAN JOSE TORIJA JORGE. Datosregistrales. T 596, L 387, F 75, S 8, H BU 12385, I/A 22 (16.11.10).
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 394.692,20 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 75, S 8, H BU 12385,I/A 23 (16.11.10).
05 de Agosto de 2010Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 882.105,00 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 74, S 8, H BU 12385,I/A 21 (27.07.10).
20 de Julio de 2010Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 500.000,00 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 74, S 8, H BU 12385,I/A 20 ( 9.07.10).
24 de Junio de 2010Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.505.000,00 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 74, S 8, H BU 12385,I/A 19 (15.06.10).
20 de Mayo de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: PUELLES GALLO JOSE;PUELLES GALLO JOSE. Apo.Man.Soli: PUELLES GALLO JOSE;DIAZ PE脩AJOSE ALBERTO;PEREZ GRACIA FRANCISCO JAVIER;LENCE MORENO RICARDO. Datos registrales. T 596, L 387, F 73, S 8, HBU 12385, I/A 16 (11.05.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: REINA GALLARDO ANTONIO;PINO GIRALDEZ MANUEL;AYESTA FERNANDEZ-PACHECOFIDEL;MARJON MARJON TERESA;ESTEVEZ ALAVEZ GERMAN. Datos registrales. T 596, L 387, F 73, S 8, H BU 12385, I/A 17(11.05.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: NAHARRO CASTRILLO JOSE MANUEL;GONZALEZ PEREZ DAVID;SANCHEZ ARGUDO ANAMARGARITA. Datos registrales. T 596, L 387, F 73, S 8, H BU 12385, I/A 18 (11.05.10).
11 de Marzo de 2010Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.260.000,00 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 72, S 8, H BU 12385,I/A 14 ( 1.03.10).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORDO脩EZ SANZ TOMAS ENRIQUE;LOUREDA LOPEZ SILVIA;ALCOLADO PAJARON JUANANTONIO;TOBOSO DIAGO JESUS. Datos registrales. T 596, L 387, F 73, S 8, H BU 12385, I/A 15 ( 1.03.10).
18 de Noviembre de 2009Cambio de domicilio social. CTRA N-122 Km 273 - POLIGONO INDUSTRIAL "ALLENDE D (ARANDA DE DUERO). Datosregistrales. T 596, L 387, F 71, S 8, H BU 12385, I/A 12 ( 6.11.09).
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 72, S 8, H BU 12385,I/A 13 ( 6.11.09).
04 de Septiembre de 2009Ceses/Dimisiones. Secretario: GONZALEZ CARAZO JOSE LUIS. Vicesecret.: PEREZ-MARSA VALLBONA JOAQUIN.Nombramientos. Secretario: RIELVES PILAS MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 596, L 387, F 71, S 8, H BU 12385, I/A 11(27.08.09).
04 de Agosto de 2009Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 5.000.003,83 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 70, S 8, H BU 12385,I/A 10 (24.07.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CANAL FERNANDEZ JOSE CESAR;PUELLES GALLO JOSE. Nombramientos. Consejero:MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;MORENO GOROSTIZAGA FERNANDO. Datos registrales. T 596, L 387, F 70, S 8, H BU12385, I/A 9 (24.07.09).
22 de Junio de 2009Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 2.994.386,72 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 70, S 8, H BU 12385,I/A 8 (11.06.09).