Buscador CIF Logo

Actos BORME Autovia Del Arlanzon Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Autovia Del Arlanzon Sa

Actos BORME Autovia Del Arlanzon Sa - A09482589

Tenemos registrados 53 Actos BORME del Registro Mercantil de Burgos para Autovia Del Arlanzon Sa con CIF A09482589

馃敊 Perfil de Autovia Del Arlanzon Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Burgos

Actos BORME de Autovia Del Arlanzon Sa

10 de Octubre de 2022
Reelecciones. Consejero: GOMEZ COLLADO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 766, L 557, F 41, S 8, H BU 12385, I/A 71 (4.10.22).

14 de Julio de 2022
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 766, L 557, F 41, S 8, H BU 12385, I/A 70 ( 8.07.22).

16 de Marzo de 2022
Modificaciones estatutarias. Art铆culos 17 y 32.- Se establece la posibilidad de que las reuniones de la Junta General y del Consejode Administraci贸n, se celebren de forma telem谩tica.. Datos registrales. T 766, L 557, F 40, S 8, H BU 12385, I/A 68 (10.03.22).

17 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: CORRAL FERNANDEZ FELIX;EGUIA DIAZ SANTIAGO;MARTINEZ MARTINEZ-CA脩AVATEANTONIO;CORRAL FERNANDEZ FELIX;JIMENEZ ORTEGA DOMINGO;MANRIQUE SABATEL FABIO. Nombramientos.Apo.Manc.: RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS;TOBOSO DIAGO JESUS;RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO;GOMEZ DEL RIOSANZ HERNANZ RAFAEL;PELLON REVUELTA LEOPOLDO;MOCHON LOPEZ PABLO. Datos registrales. T 766, L 557, F 37, S 8,H BU 12385, I/A 67 (11.02.22).

21 de Octubre de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 766, L 557, F 37, S 8, H BU 12385, I/A 64 (15.10.21).

29 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 766, L 557, F 36, S 8, H BU 12385, I/A 62 (23.10.20).

27 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ MARTINEZ-CA脩AVATE ANTONIO;TOBOSO DIAGO JESUS;GOMEZ DEL RIO SANZHERNANZ RAFAEL;CORRAL FERNANDEZ FELIX;MOCHON LOPEZ PABLO;JIMENEZ ORTEGA DOMINGO;MANRIQUE SABATELFABIO;RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS. Datos registrales. T 749, L 540, F 197, S 8, H BU 12385, I/A 61 (21.11.19).

21 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ GOMEZ-NAVARRO JOSE MIGUEL;GONZALEZ GOMEZ-NAVARRO JOSE MIGUEL. Datosregistrales. T 749, L 540, F 197, S 8, H BU 12385, I/A 60 (15.10.19).

05 de Marzo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: DEDIEU MICHAEL. Nombramientos. Consejero: NALAZEK JAKUB. Datos registrales. T 749, L540, F 197, S 8, H BU 12385, I/A 59 (27.02.19).

30 de Octubre de 2018
Reelecciones. Consejero: SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS I SL;SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL;SACYRCONCESIONES PARTICIPADAS IV SL. Presidente: SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS I SL. Datos registrales. T 721, L 512,F 61, S 8, H BU 12385, I/A 58 (24.10.18).

13 de Marzo de 2018
Nombramientos. Apoderado: TOBOSO DIAGO JESUS. Datos registrales. T 721, L 512, F 61, S 8, H BU 12385, I/A 57 ( 7.03.18).

11 de Octubre de 2017
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 721, L 512, F 60, S 8, H BU 12385, I/A 55 ( 4.10.17).

27 de Julio de 2017
Reelecciones. Consejero: DEDIEU MICHAEL;GOMEZ COLLADO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 721, L 512, F 60, S 8, HBU 12385, I/A 53 (21.07.17).

15 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: EGUIA DIAZ SANTIAGO;GONZALEZ GOMEZ-NAVARRO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 721, L512, F 59, S 8, H BU 12385, I/A 52 ( 8.03.17).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: TOBOSO DIAGO JESUS;ORDO脩EZ SANZ TOMAS ENRIQUE. Apo.Sol.: REINA GALLARDOANTONIO. Apo.Manc.: TOBOSO DIAGO JESUS;GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL;TOBOSO DIAGO JESUS;GOMEZ DELRIO SANZ HERNANZ RAFAEL;MOCHON LOPEZ PABLO. Apo.Man.Soli: CORRAL FERNANDEZ FELIX. Apo.D.Gral.: GONZALEZGOMEZ-NAVARRO JOSE MIGUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ GOMEZ-NAVARRO JOSE MIGUEL;TOBOSODIAGO JESUS;CORRAL FERNANDEZ FELIX;GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL;MOCHON LOPEZ PABLO. Apo.Sol.:NOTARIO NIETO MARIA;RANZ AZCUTIA ELISA;GARCIA DENCHE MARTA;LIMA FELIX NUNO;PINACHO LASTRES PABLO. Datosregistrales. T 721, L 512, F 56, S 8, H BU 12385, I/A 51 ( 8.03.17).

11 de Noviembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: RUFO ACEMEL MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apo.D.Gral.: GONZALEZ GOMEZ-NAVARROJOSE MIGUEL. Datos registrales. T 700, L 491, F 103, S 8, H BU 12385, I/A 50 ( 3.11.16).

30 de Agosto de 2016
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 700, L 491, F 102, S 8, H BU 12385, I/A 49 (24.08.16).

13 de Abril de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTIN GOMEZ VICTOR JAVIER. Datos registrales. T 700, L 491, F 102, S 8, H BU 12385, I/A 47 (7.04.16).

18 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;MIJANGOS GOROZARRI CARLOS. Nombramientos.Apo.Man.Soli: MARTIN GOMEZ VICTOR JAVIER;CORRAL FERNANDEZ FELIX. Datos registrales. T 700, L 491, F 100, S 8, H BU12385, I/A 46 ( 9.02.16).

10 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apo.Sol.: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA. Apo.Manc.: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA;ORIHUELA UZAL JOSEMARIA. Apo.Man.Soli: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA;LOUREDA LOPEZ SILVIA. Apo.Sol.: NAHARRO CASTRILLO JOSEMANUEL;DE SAN JOSE TORIJA JORGE;OSORIO ALONSO SANDRA;RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONSERRAT;BAENA JIMENEZMIGUEL ANGEL;RODRIGUEZ PUYOL MARIA;RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALVARO;GRANIZO PALOMEQUE MARIA. Datosregistrales. T 700, L 491, F 100, S 8, H BU 12385, I/A 45 ( 4.02.16).

13 de Octubre de 2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 667, L 458, F 23, S 8, H BU 12385, I/A 42 ( 6.10.15).

03 de Agosto de 2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 667, L 458, F 23, S 8, H BU 12385, I/A 41 (28.07.15).

04 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apoderado: CASTILLO ACU脩A LUIS. Nombramientos. Apoderado: RUFO ACEMEL MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 667, L 458, F 22, S 8, H BU 12385, I/A 39 (26.02.15).

18 de Diciembre de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALCOLADO PAJARON JUAN ANTONIO. Apo.Manc.: ALCOLADO PAJARON JUAN ANTONIO.Nombramientos. Apoderado: CASTILLO ACU脩A LUIS. Datos registrales. T 667, L 458, F 19, S 8, H BU 12385, I/A 38 (11.12.14).

10 de Septiembre de 2013
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 667, L 458, F 18, S 8, H BU 12385, I/A 36 ( 2.09.13).

22 de Julio de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL;ALCOLADOPAJARON JUAN ANTONIO. Presidente: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS. Nombramientos. Consejero: SACYR CONCESIONESPARTICIPADAS I SL;SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL;SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS IV SL. Presidente:SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS I SL. Datos registrales. T 667, L 458, F 18, S 8, H BU 12385, I/A 35 (16.07.13).

23 de Agosto de 2012
Reelecciones. Consejero: GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL. Datos registrales. T 636, L 427, F 152, S 8, H BU 12385,I/A 32 (14.08.12).

Revocaciones. Apo.Manc.: LOUREDA LOPEZ SILVIA;PUENTE ROZALEN JORGE. Nombramientos. Apo.Manc.: ALCOLADOPAJARON JUAN ANTONIO;TOBOSO DIAGO JESUS;MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZRAFAEL;MOCHON LOPEZ PABLO. Datos registrales. T 636, L 427, F 152, S 8, H BU 12385, I/A 33 (14.08.12).

Cambio de domicilio social. CTRA MADRID-IRUN Km 233 - AVDA.PEDERNALES S/N POLI (VILLAGONZALO PEDERNALES).Datos registrales. T 636, L 427, F 154, S 8, H BU 12385, I/A 34 (14.08.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA;GARCIA SAN MIGUEL RODRIGUEZ ALARCON GONZALO.Presidente: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA. Consejero: JALON GONZALEZ EVA;LOUREDA LOPEZ SILVIA. Secretario: RIELVESPILAS MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: DEDIEU MICHAEL;GOMEZ COLLADO MARIA DEL PILAR;ALCOLADOPAJARON JUAN ANTONIO. Presidente: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS. SecreNoConsj: OSMA JIMENEZ ALEJANDRO. Datosregistrales. T 636, L 427, F 151, S 8, H BU 12385, I/A 31 (14.08.12).

18 de Abril de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: OSORIO ALONSO SANDRA;RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONSERRAT;BAENA JIMENEZ MIGUELANGEL;RODRIGUEZ PUYOL MARIA;RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALVARO;GRANIZO PALOMEQUE MARIA. Datos registrales. T636, L 427, F 150, S 8, H BU 12385, I/A 30 ( 4.04.12).

31 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: RIVERO MARTINEZ LUIS. Nombramientos. Consejero: LOUREDA LOPEZ SILVIA. Datosregistrales. T 636, L 427, F 150, S 8, H BU 12385, I/A 29 (20.01.12).

08 de Agosto de 2011
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.007.800,00 Euros. Desembolsado: 5.007.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.722.717,00 Euros.Resultante Desembolsado: 23.722.717,00 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 77, S 8, H BU 12385, I/A 27 (28.07.11).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 636, L 427, F 150, S 8, H BU 12385, I/A 28 (28.07.11).

06 de Junio de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: AYESTA FERNANDEZ-PACHECO FIDEL;ESTEVEZ ALAVEZ GERMAN. Apo.Man.Soli: ALCOLADOPAJARON JUAN ANTONIO. Nombramientos. Apo.Manc.: LOUREDA LOPEZ SILVIA;TOBOSO DIAGO JESUS;MIJANGOSGOROZARRI CARLOS;GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL;PUENTE ROZALEN JORGE. Datos registrales. T 596, L 387,F 76, S 8, H BU 12385, I/A 26 (26.05.11).

18 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO GOROSTIZAGA FERNANDO. Nombramientos. Consejero: JALON GONZALEZ EVA.Datos registrales. T 596, L 387, F 76, S 8, H BU 12385, I/A 25 ( 7.04.11).

10 de Febrero de 2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 596, L 387, F 75, S 8, H BU 12385, I/A 24 ( 2.02.11).

25 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apo.Sol.: PINO GIRALDEZ MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: DE SAN JOSE TORIJA JORGE. Datosregistrales. T 596, L 387, F 75, S 8, H BU 12385, I/A 22 (16.11.10).

Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 394.692,20 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 75, S 8, H BU 12385,I/A 23 (16.11.10).

05 de Agosto de 2010
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 882.105,00 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 74, S 8, H BU 12385,I/A 21 (27.07.10).

20 de Julio de 2010
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 500.000,00 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 74, S 8, H BU 12385,I/A 20 ( 9.07.10).

24 de Junio de 2010
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.505.000,00 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 74, S 8, H BU 12385,I/A 19 (15.06.10).

20 de Mayo de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: PUELLES GALLO JOSE;PUELLES GALLO JOSE. Apo.Man.Soli: PUELLES GALLO JOSE;DIAZ PE脩AJOSE ALBERTO;PEREZ GRACIA FRANCISCO JAVIER;LENCE MORENO RICARDO. Datos registrales. T 596, L 387, F 73, S 8, HBU 12385, I/A 16 (11.05.10).

Nombramientos. Apo.Sol.: REINA GALLARDO ANTONIO;PINO GIRALDEZ MANUEL;AYESTA FERNANDEZ-PACHECOFIDEL;MARJON MARJON TERESA;ESTEVEZ ALAVEZ GERMAN. Datos registrales. T 596, L 387, F 73, S 8, H BU 12385, I/A 17(11.05.10).

Nombramientos. Apo.Sol.: NAHARRO CASTRILLO JOSE MANUEL;GONZALEZ PEREZ DAVID;SANCHEZ ARGUDO ANAMARGARITA. Datos registrales. T 596, L 387, F 73, S 8, H BU 12385, I/A 18 (11.05.10).

11 de Marzo de 2010
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.260.000,00 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 72, S 8, H BU 12385,I/A 14 ( 1.03.10).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORDO脩EZ SANZ TOMAS ENRIQUE;LOUREDA LOPEZ SILVIA;ALCOLADO PAJARON JUANANTONIO;TOBOSO DIAGO JESUS. Datos registrales. T 596, L 387, F 73, S 8, H BU 12385, I/A 15 ( 1.03.10).

18 de Noviembre de 2009
Cambio de domicilio social. CTRA N-122 Km 273 - POLIGONO INDUSTRIAL "ALLENDE D (ARANDA DE DUERO). Datosregistrales. T 596, L 387, F 71, S 8, H BU 12385, I/A 12 ( 6.11.09).

Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 72, S 8, H BU 12385,I/A 13 ( 6.11.09).

04 de Septiembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Secretario: GONZALEZ CARAZO JOSE LUIS. Vicesecret.: PEREZ-MARSA VALLBONA JOAQUIN.Nombramientos. Secretario: RIELVES PILAS MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 596, L 387, F 71, S 8, H BU 12385, I/A 11(27.08.09).

04 de Agosto de 2009
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 5.000.003,83 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 70, S 8, H BU 12385,I/A 10 (24.07.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CANAL FERNANDEZ JOSE CESAR;PUELLES GALLO JOSE. Nombramientos. Consejero:MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;MORENO GOROSTIZAGA FERNANDO. Datos registrales. T 596, L 387, F 70, S 8, H BU12385, I/A 9 (24.07.09).

22 de Junio de 2009
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 2.994.386,72 Euros. Datos registrales. T 596, L 387, F 70, S 8, H BU 12385,I/A 8 (11.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n