Buscador CIF Logo

Actos BORME Auxiliar De Servicios Y Asistencia Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Auxiliar De Servicios Y Asistencia Sl

Actos BORME Auxiliar De Servicios Y Asistencia Sl - B25426867

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Lleida para Auxiliar De Servicios Y Asistencia Sl con CIF B25426867

馃敊 Perfil de Auxiliar De Servicios Y Asistencia Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Lleida

Actos BORME de Auxiliar De Servicios Y Asistencia Sl

03 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: LLOPIS RAJA XAVIER. Datos registrales. T 1198 , F 79, S 8, H L 10672, I/A 43 (23.02.23).

Nombramientos. Apoderado: MARTIN FARRUS ALEJANDRO. Datos registrales. T 1198 , F 118, S 8, H L 10672, I/A 44 (23.02.23).

17 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: VELEZ MIRANDA MANUEL;MOLONS FERRE EDUARD. Datos registrales. T 1198 , F 77, S 8, H L10672, I/A 40 ( 9.02.23).

Nombramientos. Apoderado: ULLOD MARCOS FRANCISCO DE ASIS. Apo.Manc.: ULLOD MARCOS FRANCISCO DEASIS;VILLENA CONTRERAS LUIS;MONTULL BURILLO ALEJANDRO;GIL BALAGUERO JORDI. Datos registrales. T 1198 , F 77, S8, H L 10672, I/A 41 ( 9.02.23).

Nombramientos. Apoderado: LLOPIS RAJA XAVIER. Datos registrales. T 1198 , F 79, S 8, H L 10672, I/A 42 ( 9.02.23).

13 de Enero de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1198 , F 77, S 8, H L 10672, I/A 39( 4.01.23).

09 de Diciembre de 2022
Ampliacion del objeto social. a)la confecci贸n de proyectos y la ejecuci贸n de obras de instalaci贸n de conducciones y aparatos de gasy otros combustibles, electricidad -tanto alta como baja tensi贸n-, agua y vapor, climatizaci贸n, calefacci贸n, revestimiento, sonorizaci贸n ytelefon铆a en todo tipo de edificios, pisos y locales, tanto. Datos registrales. T 1198 , F 76, S 8, H L 10672, I/A 38 (28.11.22).

30 de Junio de 2022
Reelecciones. Adm. Mancom.: MONTULL BURILLO ALEJANDRO;VILLENA CONTRERAS LUIS. Datos registrales. T 1196 , F 108,S 8, H L 10672, I/A 36 (22.06.22).

08 de Febrero de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1196 , F 107, S 8, H L 10672, I/A35 (28.01.22).

24 de Febrero de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1196 , F 107, S 8, H L 10672, I/A34 (12.02.21).

24 de Febrero de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1196 , F 107, S 8, H L 10672, I/A33 (17.02.20).

17 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: VILLENA CONTRERAS LUIS. Apo.Sol.: VILLENA CONTRERAS LUIS. Apo.Manc.: MONTULL BURILLOALEJANDRO;MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Datos registrales. T 1196 , F 107, S 8, H L 10672, I/A 32 ( 9.10.17).

19 de Julio de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: VALLES BLASCO ANA MARIA;GARCIA GARCIA JOSE;VELEZ MIRANDA MANUEL;VILLENACONTRERAS LUIS. Apo.Sol.: VILLENA CONTRERAS LUIS. Apo.Manc.: GIL BALAGUERO JORDI;URBIOLA CORTASAOSCAR;GARCIA GARCIA JOSE;VELEZ MIRANDA MANUEL;VILLENA CONTRERAS LUIS;GIL BALAGUERO JORDI. Apo.Sol.: GILBALAGUERO JORDI. Apo.Manc.: URBIOLA CORTASA OSCAR;ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA. Apo.Sol.: URBIOLA CORTASAOSCAR. Apo.Manc.: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA. Apo.Sol.: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VELEZ MIRANDAMANUEL;GARCIA GARCIA JOSE. Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE;MONTULL BURILLO ALEJANDRO;GILBALAGUERO JORDI;VELEZ MIRANDA MANUEL;VILLENA CONTRERAS LUIS;URBIOLA CORTASA OSCAR. Datos registrales. T1196 , F 88, S 8, H L 10672, I/A 31 (11.07.17).

06 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENA CONTRERAS LUIS. Nombramientos. Adm.Mancom.: VILLENA CONTRERAS LUIS;MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Datos registrales. T 1196 , F 88, S 8, H L 10672, I/A 30(27.06.17).

30 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: VILLENA CONTRERAS LUIS;MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Apo.Sol.: VILLENA CONTRERASLUIS. Apo.Manc.: MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Datos registrales. T 1196 , F 68, S 8, H L 10672, I/A 29 ( 8.05.17).

10 de Febrero de 2017
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1196 , F 68, S 8, H L 10672, I/A28 ( 2.02.17).

09 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: MONTULL BURILLO ALEJANDRO;BARO DURICH ELOI;SORIANO SANCHEZ ENRIQUE;MONTULLBURILLO ALEJANDRO;BARO DURICH ELOI. Apoderado: MARTIN GONZALEZ ANGELES;LOPEZ VILLAR MANUEL. Datosregistrales. T 1190 , F 41, S 8, H L 10672, I/A 25 (28.04.16).

Revocaciones. Apo.Manc.: CARNER BARDAJI JUAN CARLOS;CARNER BARDAJI JUAN CARLOS. Apo.Sol.: CARNER BARDAJIJUAN CARLOS. Datos registrales. T 1196 , F 42, S 8, H L 10672, I/A 26 (28.04.16).

Nombramientos. Apoderado: MOLONS FERRE EDUARD. Datos registrales. T 1196 , F 42, S 8, H L 10672, I/A 27 (28.04.16).

10 de Junio de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENA CONTRERAS LUIS;BERNAT NIUBO JORDI;CARNERBARDAJI JUAN CARLOS;GARCIA GARCIA JOSE;URBIOLA CORTASA OSCAR;ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENACONTRERAS LUIS;VALLES BLASCO ANA MARIA;CARNER BARDAJI JUAN CARLOS;BERNAT NIUBO JORDI;GARCIA GARCIAJOSE;URBIOLA CORTASA OSCAR. Apo.Sol.: VILLENA CONTRERAS LUIS;CARNER BARDAJI JUAN CARLOS;ESPINETFERNANDEZ SEBASTIA;BERNAT NIUBO JORDI;GARCIA GARCIA JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: ESPINET FERNANDEZSEBASTIA. Apo.Manc.: CARNER BARDAJI JUAN CARLOS;VILLENA CONTRERAS LUIS;ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA.Apo.Sol.: URBIOLA CORTASA OSCAR;GARCIA GARCIA JOSE;GIL BALAGUERO JORDI;VELEZ MIRANDA MANUEL;CARNERBARDAJI JUAN CARLOS;VILLENA CONTRERAS LUIS. Apo.Manc.: VELEZ MIRANDA MANUEL;GIL BALAGUERO JORDI;GARCIAGARCIA JOSE;URBIOLA CORTASA OSCAR;ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENA CONTRERAS LUIS;VALLES BLASCOANA MARIA;CARNER BARDAJI JUAN CARLOS;VELEZ MIRANDA MANUEL;GIL BALAGUERO JORDI;GARCIA GARCIAJOSE;URBIOLA CORTASA OSCAR. Datos registrales. T 1180 , F 102, S 8, H L 10672, I/A 23 ( 1.06.15).

Revocaciones. Apo.Sol.: SAMPRIETO LECINA JAIME. Datos registrales. T 1188 , F 73, S 8, H L 10672, I/A 24 ( 2.06.15).

24 de Septiembre de 2014
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA. Datos registrales. T1180 , F 102, S 8, H L 10672, I/A 22 (17.09.14).

14 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apoderado: MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Datos registrales. T 1180 , F 101, S 8, H L 10672, I/A 21 (7.05.13).

31 de Enero de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CASTELLS FARRAS JOAN;NADAL CLARET EDUARDO. Nombramientos. Adm. Mancom.:ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENA CONTRERAS LUIS. Datos registrales. T 1170 , F 224, S 8, H L 10672, I/A 19(22.01.13).

Revocaciones. Apo.Sol.: CAMPANERA ALCAZAR RAMON. Apo.Manc.: GARCIA GARCIA JOSE;BERNAT NIUBO JORDI;NADALCLARET EDUARDO;CASTELLS FARRAS JOAN.Apo.Sol.: NADAL CLARET EDUARDO;CASTELLS FARRAS JOAN. Apo.Manc.:NADAL CLARET EDUARDO;CASTELLS FARRAS JOAN;VILLENA CONTRERAS LUIS;BERNAT NIUBO JORDI. Apoderado:CARNER BARDAJI JUAN CARLOS. Apo.Manc.: CASTELLS FARRAS JOAN;GARCIA GARCIA JOSE;VILLENA CONTRERAS LUIS.Apo.Sol.: NADAL CLARET EDUARDO. Apo.Manc.: NADAL CLARET EDUARDO. Apo.Sol.: BERNAT NIUBO JORDI;VILLENACONTRERAS LUIS;GARCIA GARCIA JOSE;CASTELLS FARRAS JOAN. Nombramientos. Apo.Sol.: VILLENA CONTRERASLUIS;CARNER BARDAJI JUAN CARLOS;ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;BERNAT NIUBO JORDI;GARCIA GARCIA JOSE.Apo.Manc.: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENA CONTRERAS LUIS;BERNAT NIUBO JORDI;CARNER BARDAJI JUANCARLOS;GARCIA GARCIA JOSE;URBIOLA CORTASA OSCAR;ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENA CONTRERASLUIS;VALLES BLASCO ANA MARIA;CARNER BARDAJI JUAN CARLOS;BERNAT NIUBO JORDI;GARCIA GARCIA JOSE;URBIOLACORTASA OSCAR. Datos registrales. T 1170 , F 224, S 8, H L 10672, I/A 20 (22.01.13).

09 de Febrero de 2012
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1170 , F 223, S 8, H L 10672, I/A18 (27.01.12).

29 de Marzo de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: RETAMAL GARCES JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 1170 , F 223, S 8, H L 10672, I/A 17(17.03.11).

01 de Febrero de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: SAMPRIETO LECINA JAIME;BARO DURICH ELOI. Datos registrales. T 1170 , F 222, S 8, H L 10672,I/A 16 (21.01.11).

23 de Noviembre de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: PALAU ARROYO ANDREU. Apo.Manc.: PALAU ARROYO ANDREU. Nombramientos. Apoderado:CARNER BARDAJI JUAN CARLOS. Datos registrales. T 1066 , F 48, S 8, H L 10672, I/A 15 (10.11.09).

17 de Junio de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: PALAU ARROYO ANDREU. Apo.Manc.: PALAU ARROYO ANDREU;CASTELLS FARRAS JOAN;NADALCLARET EDUARDO;BERNAT NIUBO JORDI;GARCIA GARCIA JOSE;VILLENA CONTRERAS LUIS. Datos registrales. T 1064 , F224, S 8, H L 10672, I/A 14 ( 5.06.09).

07 de Mayo de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: MAS CASTILLO VICTOR;MAS CASTILLO VICTOR;MAS CASTILLO VICTOR. Apo.Sol.: MAS CASTILLOVICTOR;MAS CASTILLO VICTOR;MAS CASTILLO VICTOR. Datos registrales. T 1064 , F 224, S 8, H L 10672, I/A 13 (27.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n