Actos BORME de Avalia Aragon Sociedad De Garantia Reciproca
16 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: LANASPA SANTOLARIA LUIS FERNANDO;SORIA CIRUGEDA CARLOS;PERAL CANTAREROJOSE. Miem.Com.Ej.: LANASPA SANTOLARIA LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 3311 , F 35, S 8, H Z 7547, I/A 112(10.11.23).
Otros conceptos: Se hace constar que se ha sustituido al representante persona física del consejero "Confederación de la Pequeña yMediana Empresa Aragonesa". Datos registrales. T 3311 , F 35, S 8, H Z 7547, I/A 113 (10.11.23).
20 de Junio de 2023Otros conceptos: Ratificado por la Junta General de la sociedad, celebrada el 16 de mayo de 2023, el nombramiento como consejerode Don Antonio Lacoma Sambia por plazo de cuatro años. El señor Lacoma fue designado como tal por cooptación en sesión delConsejo de Administración celebrada el 28 de diciembre de 2022. Datos registrales. T 3311 , F 34, S 8, H Z 7547, I/A 110 (13.06.23).
Nombramientos. Aud.Manc: CGM AUDITORES SL;VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 3311 , F 34, S 8, H Z 7547, I/A 111 (13.06.23).
08 de Febrero de 2023Nombramientos. Apoderado: MONTERDE SANJUAN MARIA LUISA. Datos registrales. T 3311 , F 34, S 8, H Z 7547, I/A 109(31.01.23).
26 de Octubre de 2022Otros conceptos: Cambiado el representante de la consejera "CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ARAGON". Datosregistrales. T 3311 , F 33, S 8, H Z 7547, I/A 107 (19.10.22).
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ BUN GEMMA. Nombramientos. Consejero: LACOMA SAMBIA ANTONIO. Datosregistrales. T 3311 , F 33, S 8, H Z 7547, I/A 108 (19.10.22).
29 de Julio de 2022Otros conceptos: La Consejera ARAGONESA DE MUJERES EMPRESARIAS, ARAME, ha cambiado de persona físicarepresentante. Datos registrales. T 3311 , F 33, S 8, H Z 7547, I/A 106 (21.07.22).
12 de Noviembre de 2021Modificaciones estatutarias. ARTICULO 25 BIS.- CELEBRACION DE REUNIONES POR MEDIOS TELEMATICOS. Las sesiones delos órganos de gobierno (Juntas Generales) y de los órganos de administración de la sociedad (Consejo de Administración y ComitéEjecutivo) podrán constituirse y celebrarse por medios telemáticos (videoconferencia o. Datos registrales. T 3311 , F 32, S 8, H Z7547, I/A 105 ( 5.11.21).
30 de Septiembre de 2021Reelecciones. Miem.Com.Ej.: LACASA MATEO MARIA. Pres.Com.Ej.: ESTEBAN SAIZ ASUNCION. Miem.Com.Ej.: ESTEBAN SAIZASUNCION. Datos registrales. T 3311 , F 32, S 8, H Z 7547, I/A 104 (23.09.21).
08 de Julio de 2021Reelecciones. Consejero: LACASA MATEO MARIA;CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ARAGON;ESTEBAN SAIZASUNCION;EREZA ARCEIZ JOAQUIN RAMON;CONFEDERACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ARAG;PERALCANTARERO JOSE. Presidente: ESTEBAN SAIZ ASUNCION. Consejero: SORIA CIRUGEDA CARLOS;ASOCIACION ARAGONESADE MUJERES EMPRESARIAS ARAME. Datos registrales. T 3311 , F 32, S 8, H Z 7547, I/A 103 ( 1.07.21).
26 de Febrero de 2021Cancelaciones de oficio de nombramientos. Miem.Com.Ej.: LANASPA SANTOLARIA LUIS FERNANDO. Nombramientos.Miem.Com.Ej.: LANASPA SANTOLARIA LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 3311 , F 31, S 8, H Z 7547, I/A 102 (19.02.21).
20 de Octubre de 2020Nombramientos. Consejero: LANASPA SANTOLARIA LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 3311 , F 31, S 8, H Z 7547, I/A 100 (8.10.20).
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3311 , F 31, S 8, H Z 7547, I/A 101 ( 8.10.20).
27 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: VICENTE SANTORUM FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3311 , F 31, S 8, H Z 7547, I/A 99(20.11.18).
09 de Octubre de 2018Nombramientos. Consejero: SANCHEZ BUN GEMMA. Datos registrales. T 3311 , F 30, S 8, H Z 7547, I/A 98 ( 3.10.18).
18 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: MUÑOZ EDO MARIA-PILAR;HERNANDEZ CAVERO JORGE. Datos registrales. T 3311 , F 30, S 8, H Z7547, I/A 97 (11.05.18).
17 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: MALLOR GORMEDINO DANIEL. Datos registrales. T 3311 , F 29, S 8, H Z 7547, I/A 96 ( 9.05.18).
31 de Enero de 2018Cambio de domicilio social. PLAZA ARAGON 1 (ZARAGOZA). Datos registrales. T 3311 , F 29, S 8, H Z 7547, I/A 95 (24.01.18).
02 de Enero de 2018Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3311 , F 29, S 8, H Z 7547, I/A 94 (22.12.17).
03 de Agosto de 2017Nombramientos. Consejero: ASOCIACION ARAGONESA DE MUJERES EMPRESARIAS ARAME. Datos registrales. T 3311 , F29, S 8, H Z 7547, I/A 93 (27.07.17).
11 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Dir. General: BUEN AYUDA ANTONIO. Datos registrales. T 3311 , F 29, S 8, H Z 7547, I/A 92 ( 4.05.17).
10 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: CALVO BERTOLIN CARLOS;CUEVAS GOMEZ RAUL;PEREZ BUENO MARIA JOSE. Datosregistrales. T 3311 , F 28, S 8, H Z 7547, I/A 91 ( 3.05.17).
03 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Presidente: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO.Miem.Com.Ej.: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Pres.Com.Ej.: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Consejero:FORNALS ENGUIDANOS MARIA DOLORES;GALOCHINO MORENO MANUEL;TEJEDOR SANZ RAMON;LEAL MARCOS ANDRES.Miem.Com.Ej.: LEAL MARCOS ANDRES. Consejero: FERNANDEZ CUELLO FERNANDO. Pres.Com.Ej.: LANASPA SANTOLARIALUIS FERNANDO. Presidente: LANASPA SANTOLARIA LUIS FERNANDO. Nombramientos. Miem.Com.Ej.: LACASA MATEOMARIA. Presidente: LANASPA SANTOLARIA LUIS FERNANDO. Pres.Com.Ej.: LANASPA SANTOLARIA LUIS FERNANDO.Consejero: CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ARAGON;ESTEBAN SAIZ ASUNCION;EREZA ARCEIZ JOAQUINRAMON;CONFEDERACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ARAG;PERAL CANTARERO JOSE;SORIA CIRUGEDACARLOS. Pres.Com.Ej.: ESTEBAN SAIZ ASUNCION. Presidente: ESTEBAN SAIZ ASUNCION. Miem.Com.Ej.: ESTEBAN SAIZ
27 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: SOLANS GARCIA BLANCA;GARCIA LOPEZ JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero:GALOCHINO MORENO MANUEL. Datos registrales. T 3311 , F 26, S 8, H Z 7547, I/A 88 (19.10.16).
Nombramientos. Consejero: LACASA MATEO MARIA. Datos registrales. T 3311 , F 26, S 8, H Z 7547, I/A 89 (19.10.16).
12 de Septiembre de 2016Fe de erratas: El nombramiento fue por cooptación. Datos registrales. T 3311 , F 25, S 8, H Z 7547, I/A 85 (28.04.16).
06 de Julio de 2016Reelecciones. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 3311 , F 25, S 8, H Z 7547, I/A 86 (28.06.16).
06 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: BARBERO LAHOZ ENRIQUE;GARCIA LOPEZ JOSE MARIA;ESCARIO MARTINEZJORGE;MORENO CASADO LAURA. Miem.Com.Ej.: ESCARIO MARTINEZ JORGE;GARCIA LOPEZ JOSE MARIA. Consejero:GASION AGUILAR ANTONIO;CERVERA RUIZ PEDRO. Miem.Com.Ej.: GASION AGUILAR ANTONIO. Presidente: GARCIA LOPEZJOSE MARIA. Miem.Com.Ej.: BARBERO LAHOZ ENRIQUE. Consejero: LACASA MATEO MARIA. Pres.Com.Ej.: GARCIA LOPEZJOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO;LEAL MARCOS ANDRES;LANASPASANTOLARIA LUIS FERNANDO;FERNANDEZ CUELLO FERNANDO;TEJEDOR SANZ RAMON;FORNALS ENGUIDANOS MARIADOLORES;SOLANS GARCIA BLANCA. Presidente: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Miem.Com.Ej.: MARTIN-RETORTILLOLEGUINA PABLO;LEAL MARCOS ANDRES;LANASPA SANTOLARIA LUIS FERNANDO. Pres.Com.Ej.: MARTIN-RETORTILLOLEGUINA PABLO. Sec.Com.Eje.: MONTERDE SANJUAN MARIA LUISA. Otros conceptos: MODIFICAR el apoderamientoconcedido al Comité Técnico que motivó la inscripción 81&, en el sentido de limitar cuantitativamente la facultad de aprobaroperaciones de aval solicitadas por los socios, quedando limitada dicha facultad a operaciones por importe de hasta 100.000,00 euros.Datos registrales. T 3311 , F 25, S 8, H Z 7547, I/A 84 (25.04.16).
Ceses/Dimisiones. Consejero: PARDOS MARTINEZ EVA. Nombramientos. Consejero: GARCIA LOPEZ JOSE MARIA. Datosregistrales. T 3311 , F 25, S 8, H Z 7547, I/A 85 (28.04.16).
14 de Marzo de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: VICENTE SANTORUM FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3311 , F 24, S 8, H Z 7547, I/A 83 (
02 de Febrero de 2016Otros conceptos: Se cambia la denominación del domicilio social de la sociedad, que se encontraba en Avenida Pablo Ruiz Picasso,63, planta 3& oficina A, al actual de Avenida Ranillas, 3, Bloque A, planta 3&, oficina A. Datos registrales. T 3311 , F 24, S 8, H Z7547, I/A 82 (25.01.16).
29 de Septiembre de 2015Otros conceptos: Se cesa el Comité Técnico, formado por los siguientes miembros: PRESIDENTE: Don Antonio Buen Ayuda;VOCALES: Doña Cristina Carrera Vallespín y SECRETARIO: Don José Carlos Montes Uriol. Se constituye el Comité Técnico, formadopor los siguientes miembros: PRESIDENTE: Don José Carlos Montes Uriol; VOCAL: Doña Cristina Carrera Vallespín y SECRETARIA:María Luisa Monterde Sanjuan. Datos registrales. T 3311 , F 25, S 8, H Z 7547, I/A 81 (21.09.15).
27 de Agosto de 2015Reelecciones. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 3311 , F 24, S 8, H Z 7547, I/A 80 (19.08.15).
25 de Junio de 2015Nombramientos. Pres.Com.Ej.: GARCIA LOPEZ JOSE MARIA. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 25º.- CONVOCATORIA,REGIMEN DE ACUERDOS, SISTEMA RETRIBUTIVO, REGIMEN DISCIPLINARIO Y RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS.-El Consejo de Administración se reunirá cuantas veces lo estime conveniente el Presidente o quien haga sus veces medianteconvocatoria escrita, indicando el lugar. Datos registrales. T 3311 , F 23, S 8, H Z 7547, I/A 78 (18.06.15).
Otros conceptos: Ratificado el nombramiento por cooptación del consejero Doña María Lacasa Mateo. Datos registrales. T 3311 , F24, S 8, H Z 7547, I/A 79 (18.06.15).
22 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: CASAO IBAÑEZ ANTONIO. Miem.Com.Ej.: CASAO IBAÑEZ ANTONIO. Presidente: CASAO IBAÑEZANTONIO. Pres.Com.Ej.: CASAO IBAÑEZ ANTONIO. Nombramientos. Consejero: LACASA MATEO MARIA. Presidente: GARCIALOPEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 3311 , F 23, S 8, H Z 7547, I/A 77 (13.05.15).
27 de Febrero de 2015Otros conceptos: MODIFICADOS LOS ARTICULOS números 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 32 y 34,y REFUNDIDOS TOTALMENTE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3311 , F 19, S 8, H Z 7547, I/A 76 (19.02.15).
17 de Noviembre de 2014Nombramientos. Miem.Com.Ej.: GASION AGUILAR ANTONIO. Datos registrales. T 3311 , F 19, S 8, H Z 7547, I/A 75 (10.11.14).
21 de Agosto de 2014Reelecciones. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 3311 , F 19, S 8, H Z 7547, I/A 74 (13.08.14).
27 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: ARILLA LEZA JAVIER;CARNICER BERGA MARIA ROSARIO. Nombramientos. Consejero:GASION AGUILAR ANTONIO;CERVERA RUIZ PEDRO. Otros conceptos: Ratificado el nombramiento por cooptación de DonEnrique Barbero Lahoz efectuado por el Consejo de Administración de 8 de julio de 2013. Datos registrales. T 3311 , F 19, S 8, H Z7547, I/A 73 (19.06.14).
21 de Noviembre de 2013Revocaciones. Apoderado: VIDAL RAFALES BEATRIZ. Apo.Man.Soli: VIDAL RAFALES BEATRIZ. Apoderado: LANZUELA GRACIAJOAQUIN;LANUZA CALVO ALFREDO;MARCO GIMENEZ LUIS. Datos registrales. T 3311 , F 18, S 8, H Z 7547, I/A 72 (12.11.13).
09 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Pres.Com.Ej.: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Miem.Com.Ej.: MARTIN-RETORTILLO LEGUINAPABLO. Consejero: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Presidente: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO.Nombramientos. Consejero: BARBERO LAHOZ ENRIQUE. Presidente: CASAO IBAÑEZ ANTONIO. Pres.Com.Ej.: CASAO IBAÑEZANTONIO. Miem.Com.Ej.: GARCIA LOPEZ JOSE MARIA;BARBERO LAHOZ ENRIQUE. Cambio de domicilio social. AVDA PABLORUIZ PICASSO 63 A 3& - OFICINA A (ZARAGOZA). Datos registrales. T 3311 , F 18, S 8, H Z 7547, I/A 71 ( 1.10.13).
20 de Febrero de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ CAVERO JORGE;MUÑOZ EDO MARIA-PILAR. Datos registrales. T 3311 , F 18, S 8, H Z7547, I/A 70 (11.02.13).
12 de Febrero de 2013Nombramientos. Apoderado: MONTES URIOL JOSE CARLOS. Datos registrales. T 3311 , F 18, S 8, H Z 7547, I/A 69 (31.01.13).
02 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MONTES URIOL JOSE CARLOS. Nombramientos. Secretario: MONTERDE SANJUAN MARIALUISA. Apo.Sol.: MONTES URIOL JOSE CARLOS. Dir. General: MONTES URIOL JOSE CARLOS. Datos registrales. T 3311 , F 17,S 8, H Z 7547, I/A 68 (21.12.12).
31 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apoderado: BUEN AYUDA ANTONIO. Datos registrales. T 3311 , F 17, S 8, H Z 7547, I/A 67 (19.12.12).
21 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: BESCOS RAMON JOSE MARIA. Presidente: BESCOS RAMON JOSE MARIA. Consejero:BESCOS RAMON JOSE MARIA;GARETA NAVARRO GEMA. Nombramientos. Consejero: CASAO IBAÑEZ ANTONIO;CARNICERBERGA MARIA ROSARIO. Presidente: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Miem.Com.Ej.: CASAO IBAÑEZ ANTONIO. Datosregistrales. T 3311 , F 17, S 8, H Z 7547, I/A 66 ( 8.08.12).
12 de Julio de 2012Nombramientos. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 3311 , F 17, S 8, H Z 7547, I/A 65 (27.06.12).
15 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON;INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO;DIPUTACIONGENERAL DE ARAGON;MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO;BAYONA RICO ENRIQUE MIGUEL. Presidente: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Miem.Com.Ej.: CONDOR LOPEZ VICENTE. Consejero: CONDOR LOPEZ VICENTE. Miem.Com.Ej.:MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Nombramientos. Consejero: BESCOS RAMON JOSE MARIA;MARTIN-RETORTILLOLEGUINA PABLO;ARILLA LEZA JAVIER;GARCIA LOPEZ JOSE MARIA;ESCARIO MARTINEZ JORGE;GARETA NAVARROGEMA;MORENO CASADO LAURA;PARDOS MARTINEZ EVA. Presidente: BESCOS RAMON JOSE MARIA. Miem.Com.Ej.: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO;BESCOS RAMON JOSE MARIA;ESCARIO MARTINEZ JORGE. Pres.Com.Ej.: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. SECR.NO.MIEN: MONTES URIOL JOSE CARLOS. Otros conceptos: Se acuerda la asistencia alComité Ejecutivo de la Sociedad, con voz, pero sin voto, del Director General y del Secretario del Consejo de Administración, actuandoéste último comoSecretariode dicho órgano. Datos registrales. T 3311 , F 16, S 8, H Z 7547, I/A 64 ( 1.03.12).
30 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: VIDAL RAFALES BEATRIZ. Datos registrales. T 3311 , F 16, S 8, H Z 7547, I/A 63 (21.06.10).
29 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: VIDAL RAFALES BEATRIZ. Datos registrales. T 3311 , F 16, S 8, H Z 7547, I/A 62 (17.03.10).
04 de Septiembre de 2009Ampliación de capital. Capital: 5.299.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.280.000,00 Euros. Otros conceptos: Ratificado elnombramiento por cooptación a favor de DON VICENTE CONDOR LOPEZ como miembro del Consejo de Administración. Datosregistrales. T 3311 , F 15, S 8, H Z 7547, I/A 61 (25.08.09).
30 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON. Consejero: BRIZ SANCHEZ JOSE ANTONIO.Revocaciones. Con.Delegado: DIPUTACION GENERAL DE ARAGON. Nombramientos. Miem.Com.Ej.: CONDOR LOPEZVICENTE. Consejero: CONDOR LOPEZ VICENTE. Otros conceptos: D.Santiago Coello Martín CESA como representante de unpuesto del Consejero la Diputación General de Aragón y DESIGNAa D.José Luis Murillo Collado. Y D.Alfonso Vicente Barra CESAcomo representante de un puesto del Consejero DiputaciónGeneral de Aragón y DESIGNA a D.Francisco Querol Fernández. Datosregistrales. T 3311 , F 15, S 8, H Z 7547, I/A 60 (19.06.09).