Buscador CIF Logo

Actos BORME Avanzo Learning Progress Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Avanzo Learning Progress Sa

Actos BORME Avanzo Learning Progress Sa - A81944720

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Avanzo Learning Progress Sa con CIF A81944720

馃敊 Perfil de Avanzo Learning Progress Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Avanzo Learning Progress Sa

23 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: ECHEVARRIA MENDIGUREN JESUS. Presidente: ECHEVARRIA MENDIGUREN JESUS. Consejero:NABICO VAZQUEZ JORGE MIGUEL. Revocaciones. Apoderado: ECHEVARRIA MENDIGUREN JESUS;NABICO VAZQUEZJORGE MIGUEL. Nombramientos. Consejero: ZUBILLAGA UGARTEMENDIA AINHOA;NIJNS HERMAN-PAUL J. Presidente:REQUENA FLORES ANA MARIA. Apoderado: ZUBILLAGA UGARTEMENDIA AINHOA;NIJNS HERMAN-PAUL J. Datos registrales.T 44335 , F 90, S 8, H M 207938, I/A 54 (16.06.23).

05 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ VELAYOS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 44335 , F 89, S 8, H M 207938, I/A 53(26.04.23).

04 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apoderado: CABEZAS GUELL CARLOS;VELEZ DE GUEVARA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales.T 44335 , F 87, S 8, H M 207938, I/A 52 (25.04.23).

18 de Abril de 2023
Nombramientos. Apoderado: ARIZA FERNANDEZ-DELGADO LUIS JAVIER. Datos registrales. T 44335 , F 77, S 8, H M 207938,I/A 48 (11.04.23).

Nombramientos. Apoderado: CANTABRANA IBARGUREN NAIARA;MARTIN MANJON JAVIER;CAMPANARIO ALONSOOLGA;CARPINTERO ARTIAGA MARIA JOSE;DELAS ORTEGA NOEMI;FREIJO CAMPILLO CRISTINA;MU脩OZ GUTIERREZFRANCISCA. Datos registrales. T 44335 , F 79, S 8, H M 207938, I/A 49 (11.04.23).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ OLIVERAS JOSE-MANUEL. Datos registrales. T 44335 , F 82, S 8, H M 207938, I/A 50(11.04.23).

Nombramientos. Apoderado: FERREIRO RODRIGUEZ MARTA. Datos registrales. T 44335 , F 84, S 8, H M 207938, I/A 51(11.04.23).

16 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: VALER MUNILLA MARTA. Datos registrales. T 44335 , F 77, S 8, H M 207938, I/A 47 ( 9.02.23).

15 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Auditor: AUDALIA NEXIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datosregistrales. T 44335 , F 76, S 8, H M 207938, I/A 46 ( 8.02.23).

13 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: SCHIRMER HENRY RICHARD;VAN'T NOORDENDE ALEXANDER MARIA. Revocaciones.Apoderado: SCHIRMER HENRY RICHARD;VAN'T NOORDENDE ALEXANDER MARIA. Nombramientos. Consejero: REQUENAFLORES ANA MARIA;NABICO VAZQUEZ JORGE MIGUEL. Apoderado: REQUENA FLORES ANA MARIA;NABICO VAZQUEZJORGE MIGUEL. Datos registrales. T 42689 , F 34, S 8, H M 207938, I/A 45 ( 6.02.23).

17 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apoderado: MENENDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: POLO CARPINTEROMARIA-ROCIO. Datos registrales. T 42689 , F 33, S 8, H M 207938, I/A 44 ( 7.10.22).

03 de Agosto de 2022
Nombramientos. SecreNoConsj: SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DE LA O. Presidente: ECHEVARRIA MENDIGUREN JESUS.Datos registrales. T 42689 , F 33, S 8, H M 207938, I/A 43 (27.07.22).

15 de Julio de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BAUTISTA LOPEZ JUAN CARLOS. Nombramientos. Consejero: ECHEVARRIA MENDIGURENJESUS;SCHIRMER HENRY RICHARD;VAN'T NOORDENDE ALEXANDER MARIA. Modificaciones estatutarias. 19. Organo deadministraci贸n. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 42689 , F 32, S 8, H M 207938, I/A 42 ( 8.07.22).

09 de Mayo de 2022
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RANDSTAD ESPA脩A SL. Datos registrales. T 42689 , F 31, S 8, H M 207938, I/A41 (29.04.22).

05 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apoderado: ECHEVARRIA MENDIGUREN JESUS;SCHIRMER HENRY RICHARD;VAN'T NOORDENDEALEXANDER MARIA;REQUENA FLORES ANA MARIA;LARENA JIMENEZ RAQUEL;LEON HERRANZ ELIZABETH;RUIZHERNANDEZ ANTONIO LUIS;MENENDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS;YANES RIFATERRA GRACIELA MARIA;MIRANDA GARCIADIEGO;MOYA HERREROS IVAN;GUERRERO ALCORLO PEDRO;BRAVO ALARCOS MARIA-ESTHER;DIEZ RAIMUNDEZCONCEPCION;PORCEL ESTEBAN PEDRO;SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DE LA O;MOLINA RUA CARLOS;GUTIERREZGASCON ROSA-MARIA;VIYA DIEZ MARIA-PILAR;CARO MARTINEZ GLORIA;TERESA LOPEZ LUIS;DIAZ ESTRINGANADIANA;VIOTA LOPEZ LINARES RAFAEL;GALAN MARTIN JOSE FERNANDO;GASTON FERRANDEZ IGNACIO JUAN;HERREROSANZ MARIA DEL PILAR;MAS SAURI JOSE ORIOL;VALER MUNILLA MARTA;CARPINTERO ARTIAGA MARIA JOSE. Datosregistrales. T 15810 , F 32, S 8, H M 207938, I/A 40 (27.04.22).

29 de Abril de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA DE SOLA RUBIO FRANCISCO;GARCIA ALVAREZ CRISTINA. Datos registrales. T 15810 ,F 32, S 8, H M 207938, I/A 39 (22.04.22).

11 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: GREDILLA BARBERO GUILLERMO. Datos registrales. T 15810 , F 31, S 8, H M 207938, I/A 38 (4.02.22).

11 de Marzo de 2021
Reelecciones. Auditor: AUDALIA NEXIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 15810 , F 31, S 8, H M 207938,I/A 37 ( 4.03.21).

14 de Junio de 2018
Reelecciones. Auditor: AUDALIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 15810 , F 31, S 8, H M 207938, I/A 36 ( 7.06.18).

23 de Junio de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: BELLO FERNANDEZ MARIA DEL PILAR. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA DE SOLA RUBIOFRANCISCO. Datos registrales. T 15810 , F 30, S 8, H M 207938, I/A 34 (14.06.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA ALVAREZ CRISTINA. Datos registrales. T 15810 , F 30, S 8, H M 207938, I/A 35(14.06.17).

21 de Junio de 2017
Reelecciones. Adm. Unico: BAUTISTA LOPEZ JUAN CARLOS. Otros conceptos: Ampliaci贸n del periodo de tiempo por el que el

19 de Junio de 2017
Nombramientos. Auditor: AUDALIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 15810 , F 29, S 8, H M 207938, I/A 32 ( 8.06.17).

09 de Septiembre de 2015
Reelecciones. Auditor: AUDALIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 15810 , F 28, S 8, H M 207938, I/A 30 (28.08.15).

Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 12.921,76 Euros. Resultante Suscrito: 47.179,45 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:12.921,76 Euros. Desembolsado: 12.921,76 Euros. Resultante Suscrito: 60.101,21 Euros. Resultante Desembolsado: 60.101,21 Euros.Datos registrales. T 15810 , F 29, S 8, H M 207938, I/A 31 (28.08.15).

18 de Julio de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DIAZ RODRIGUEZ TXOMIN. Apoderado: DIAZ RODRIGUEZ TXOMIN. Datos registrales. T 15810 , F28, S 8, H M 207938, I/A 28 (10.07.13).

Nombramientos. Apo.Sol.: BELLO FERNANDEZ MARIA DEL PILAR;GREDILLA BARBERO GUILLERMO. Datos registrales. T15810 , F 28, S 8, H M 207938, I/A 29 (10.07.13).

05 de Marzo de 2013
Reelecciones. Auditor: AUDALIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 15810 , F 28, S 8, H M 207938, I/A 27 (26.02.13).

28 de Mayo de 2012
Reelecciones. Adm. Unico: BAUTISTA LOPEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 15810 , F 27, S 8, H M 207938, I/A 26(16.05.12).

24 de Junio de 2010
Nombramientos. Auditor: AUDALIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 15810 , F 27, S 8, H M 207938, I/A 24 (14.06.10).

Cambio de domicilio social. AVDA DE EUROPA, 21, PARQUE EMPRESARIAL LA MORALEJA (ALCOBENDAS). Datosregistrales. T 15810 , F 27, S 8, H M 207938, I/A 25 (14.06.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n