Actos BORME de Avanzo Learning Progress Sa
23 de Junio de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: ECHEVARRIA MENDIGUREN JESUS. Presidente: ECHEVARRIA MENDIGUREN JESUS. Consejero:NABICO VAZQUEZ JORGE MIGUEL. Revocaciones. Apoderado: ECHEVARRIA MENDIGUREN JESUS;NABICO VAZQUEZJORGE MIGUEL. Nombramientos. Consejero: ZUBILLAGA UGARTEMENDIA AINHOA;NIJNS HERMAN-PAUL J. Presidente:REQUENA FLORES ANA MARIA. Apoderado: ZUBILLAGA UGARTEMENDIA AINHOA;NIJNS HERMAN-PAUL J. Datos registrales.T 44335 , F 90, S 8, H M 207938, I/A 54 (16.06.23).
05 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: LOPEZ VELAYOS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 44335 , F 89, S 8, H M 207938, I/A 53(26.04.23).
04 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: CABEZAS GUELL CARLOS;VELEZ DE GUEVARA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales.T 44335 , F 87, S 8, H M 207938, I/A 52 (25.04.23).
18 de Abril de 2023Nombramientos. Apoderado: ARIZA FERNANDEZ-DELGADO LUIS JAVIER. Datos registrales. T 44335 , F 77, S 8, H M 207938,I/A 48 (11.04.23).
Nombramientos. Apoderado: CANTABRANA IBARGUREN NAIARA;MARTIN MANJON JAVIER;CAMPANARIO ALONSOOLGA;CARPINTERO ARTIAGA MARIA JOSE;DELAS ORTEGA NOEMI;FREIJO CAMPILLO CRISTINA;MU脩OZ GUTIERREZFRANCISCA. Datos registrales. T 44335 , F 79, S 8, H M 207938, I/A 49 (11.04.23).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ OLIVERAS JOSE-MANUEL. Datos registrales. T 44335 , F 82, S 8, H M 207938, I/A 50(11.04.23).
Nombramientos. Apoderado: FERREIRO RODRIGUEZ MARTA. Datos registrales. T 44335 , F 84, S 8, H M 207938, I/A 51(11.04.23).
16 de Febrero de 2023Revocaciones. Apoderado: VALER MUNILLA MARTA. Datos registrales. T 44335 , F 77, S 8, H M 207938, I/A 47 ( 9.02.23).
15 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Auditor: AUDALIA NEXIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datosregistrales. T 44335 , F 76, S 8, H M 207938, I/A 46 ( 8.02.23).
13 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: SCHIRMER HENRY RICHARD;VAN'T NOORDENDE ALEXANDER MARIA. Revocaciones.Apoderado: SCHIRMER HENRY RICHARD;VAN'T NOORDENDE ALEXANDER MARIA. Nombramientos. Consejero: REQUENAFLORES ANA MARIA;NABICO VAZQUEZ JORGE MIGUEL. Apoderado: REQUENA FLORES ANA MARIA;NABICO VAZQUEZJORGE MIGUEL. Datos registrales. T 42689 , F 34, S 8, H M 207938, I/A 45 ( 6.02.23).
17 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: MENENDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: POLO CARPINTEROMARIA-ROCIO. Datos registrales. T 42689 , F 33, S 8, H M 207938, I/A 44 ( 7.10.22).
03 de Agosto de 2022Nombramientos. SecreNoConsj: SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DE LA O. Presidente: ECHEVARRIA MENDIGUREN JESUS.Datos registrales. T 42689 , F 33, S 8, H M 207938, I/A 43 (27.07.22).
15 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BAUTISTA LOPEZ JUAN CARLOS. Nombramientos. Consejero: ECHEVARRIA MENDIGURENJESUS;SCHIRMER HENRY RICHARD;VAN'T NOORDENDE ALEXANDER MARIA. Modificaciones estatutarias. 19. Organo deadministraci贸n. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 42689 , F 32, S 8, H M 207938, I/A 42 ( 8.07.22).
09 de Mayo de 2022Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RANDSTAD ESPA脩A SL. Datos registrales. T 42689 , F 31, S 8, H M 207938, I/A41 (29.04.22).
05 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: ECHEVARRIA MENDIGUREN JESUS;SCHIRMER HENRY RICHARD;VAN'T NOORDENDEALEXANDER MARIA;REQUENA FLORES ANA MARIA;LARENA JIMENEZ RAQUEL;LEON HERRANZ ELIZABETH;RUIZHERNANDEZ ANTONIO LUIS;MENENDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS;YANES RIFATERRA GRACIELA MARIA;MIRANDA GARCIADIEGO;MOYA HERREROS IVAN;GUERRERO ALCORLO PEDRO;BRAVO ALARCOS MARIA-ESTHER;DIEZ RAIMUNDEZCONCEPCION;PORCEL ESTEBAN PEDRO;SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DE LA O;MOLINA RUA CARLOS;GUTIERREZGASCON ROSA-MARIA;VIYA DIEZ MARIA-PILAR;CARO MARTINEZ GLORIA;TERESA LOPEZ LUIS;DIAZ ESTRINGANADIANA;VIOTA LOPEZ LINARES RAFAEL;GALAN MARTIN JOSE FERNANDO;GASTON FERRANDEZ IGNACIO JUAN;HERREROSANZ MARIA DEL PILAR;MAS SAURI JOSE ORIOL;VALER MUNILLA MARTA;CARPINTERO ARTIAGA MARIA JOSE. Datosregistrales. T 15810 , F 32, S 8, H M 207938, I/A 40 (27.04.22).
29 de Abril de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA DE SOLA RUBIO FRANCISCO;GARCIA ALVAREZ CRISTINA. Datos registrales. T 15810 ,F 32, S 8, H M 207938, I/A 39 (22.04.22).
11 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: GREDILLA BARBERO GUILLERMO. Datos registrales. T 15810 , F 31, S 8, H M 207938, I/A 38 (4.02.22).
11 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: AUDALIA NEXIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 15810 , F 31, S 8, H M 207938,I/A 37 ( 4.03.21).
14 de Junio de 2018Reelecciones. Auditor: AUDALIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 15810 , F 31, S 8, H M 207938, I/A 36 ( 7.06.18).
23 de Junio de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: BELLO FERNANDEZ MARIA DEL PILAR. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA DE SOLA RUBIOFRANCISCO. Datos registrales. T 15810 , F 30, S 8, H M 207938, I/A 34 (14.06.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA ALVAREZ CRISTINA. Datos registrales. T 15810 , F 30, S 8, H M 207938, I/A 35(14.06.17).
21 de Junio de 2017Reelecciones. Adm. Unico: BAUTISTA LOPEZ JUAN CARLOS. Otros conceptos: Ampliaci贸n del periodo de tiempo por el que el
19 de Junio de 2017Nombramientos. Auditor: AUDALIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 15810 , F 29, S 8, H M 207938, I/A 32 ( 8.06.17).
09 de Septiembre de 2015Reelecciones. Auditor: AUDALIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 15810 , F 28, S 8, H M 207938, I/A 30 (28.08.15).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 12.921,76 Euros. Resultante Suscrito: 47.179,45 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:12.921,76 Euros. Desembolsado: 12.921,76 Euros. Resultante Suscrito: 60.101,21 Euros. Resultante Desembolsado: 60.101,21 Euros.Datos registrales. T 15810 , F 29, S 8, H M 207938, I/A 31 (28.08.15).
18 de Julio de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: DIAZ RODRIGUEZ TXOMIN. Apoderado: DIAZ RODRIGUEZ TXOMIN. Datos registrales. T 15810 , F28, S 8, H M 207938, I/A 28 (10.07.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: BELLO FERNANDEZ MARIA DEL PILAR;GREDILLA BARBERO GUILLERMO. Datos registrales. T15810 , F 28, S 8, H M 207938, I/A 29 (10.07.13).
05 de Marzo de 2013Reelecciones. Auditor: AUDALIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 15810 , F 28, S 8, H M 207938, I/A 27 (26.02.13).
28 de Mayo de 2012Reelecciones. Adm. Unico: BAUTISTA LOPEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 15810 , F 27, S 8, H M 207938, I/A 26(16.05.12).
24 de Junio de 2010Nombramientos. Auditor: AUDALIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 15810 , F 27, S 8, H M 207938, I/A 24 (14.06.10).
Cambio de domicilio social. AVDA DE EUROPA, 21, PARQUE EMPRESARIAL LA MORALEJA (ALCOBENDAS). Datosregistrales. T 15810 , F 27, S 8, H M 207938, I/A 25 (14.06.10).