Actos BORME de Averroes Sl
09 de Septiembre de 2019Cierre provisional hoja registral por baja en el 铆ndice de Entidades Jur铆dicas. Datos registrales. T 792 , F 72, S 8, H CO 5905,I/A 1 H (27.08.19).
09 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ GOMEZ GONZALO. Secretario: GARCIA MARIN ALBERTO. Consejero: GARCIA MARINALBERTO. Nombramientos. Adm. Mancom.: MARTINEZ GOMEZ GONZALO;GARCIA MARIN ALBERTO. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. 10.Administraci贸n y Representacion.-. Cambio de domicilio social. C/ MARQUES DEL BOIL 2 1 IZ (CORDOBA). Datos registrales. T1222 , F 63, S 8, H CO 5905, I/A 8 (30.01.12).
05 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MARQUEZ SERRANO JOSE MIGUEL. Presidente: MARQUEZ SERRANO JOSE MIGUEL.Con.Delegado: MARQUEZ SERRANO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 1222 , F 62, S 8, H CO 5905, I/A 7 (27.07.10).
12 de Enero de 2010Reelecciones. Consejero: MARQUEZ SERRANO JOSE MIGUEL. Presidente: MARQUEZ SERRANO JOSE MIGUEL. Consejero:MARTINEZ GOMEZ GONZALO. Secretario: GARCIA MARIN ALBERTO. Con.Delegado: MARQUEZ SERRANO JOSE MIGUEL.Consejero: GARCIA MARIN ALBERTO. Datos registrales. T 1222 , F 62, S 8, H CO 5905, I/A 6 (30.12.09).