Actos BORME de Aviapartner Spain Sa
29 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: IGLESIAS ARAUZO LAURA TAIS;FRAILE RODRIGUEZ CARLOS;ENCINAS CARPIZO OSCAR. Datosregistrales. T 5924, L 4831, F 89, S 8, H MA134604, I/A 19 (20.12.21).
05 de Noviembre de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: AVIATION GROUND HANDLING SERVICES NV. Datosregistrales. T 5924, L 4831, F 89, S 8, H MA134604, I/A 18 (25.10.21).
29 de Marzo de 2021Cambio de objeto social. 1. Todos los servicios directa o indirectamente relacionados con la asistencia a aeronaves, tripulaciones,pasajeros y carga, a la gesti贸n del aeropuerto y el transporte en general incluyendo aviaci贸n ejecutiva, el cumplimiento de todas lasformalidades y todas las actividades que est谩n asociadas di. Datos registrales. T 5924, L 4831, F 89, S 8, H MA134604, I/A 17(18.03.21).
15 de Febrero de 2021Nombramientos. Aud.C.Con.: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos registrales. T 5924, L 4831, F 89, S 8, HMA134604, I/A 16 ( 4.02.21).
17 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: BEAUFORT SEBASTIEN JEAN JACQUES M. DE LIEDEKERKE;ROY KATLEEN VAN;CHAMPEYROLJEAN MARC FRANCOIS;BALLET MICHAEL HERMAN J. Nombramientos. Apo.Manc.: BEAUFORT SEBASTIEN JEAN JACQUESM. DE LIEDEKERKE;BALLET MICHAEL HERMAN J.;DE VOGELAERE GERTJAN. Datos registrales. T 5924, L 4831, F 88, S 8, HMA134604, I/A 15 ( 9.11.20).
06 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: SALIDO ROMERO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 5525, L 4432, F 194, S 8, H MA134604, I/A14 (21.02.20).
05 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SOHO ASSOCIATES SPRL;BEEREPOOT MAURITS DITMAR. Nombramientos. Adm. Unico:BEEREPOOT MAURITS DITMAR. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 5525, L 4432, F 194, S 8, H MA134604, I/A 13 (27.01.20).
08 de Enero de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: AZEVEDO TAVERNEY STEVE;AZEVEDO TAVERNEY STEVE. Apoderado: AZEVEDO STEVE.Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS ARAUZO LAURA TAIS. Datos registrales. T 5525, L 4432, F 193, S 8, H MA134604, I/A 12(20.12.19).
12 de Marzo de 2019Modificaciones estatutarias. Del 贸rgano de administraci贸n de la Sociedad.. Datos registrales. T 5525, L 4432, F 193, S 8, HMA134604, I/A 11 ( 4.03.19).
19 de Febrero de 2019Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 45.000,00 Euros. Datos registrales. T 5525, L 4432, F 193, S 8, HMA134604, I/A 10 (11.02.19).
09 de Octubre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO;GALLEANI DESIREE MACARENA;GONZALO PASCUAL LAURA.Datos registrales. T 5525, L 4432, F 192, S 8, H MA134604, I/A 8 (27.09.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: PAREJO PRIETO MARIA;BEEREPOOT MAURITS DITMAR. Datos registrales. T 5525, L 4432, F 193, S8, H MA134604, I/A 9 (27.09.18).
06 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: BEAUFORT SEBASTIEN JEAN JACQUES M. DE LIEDEKERKE;ROY KATLEEN VAN;CHAMPEYROLJEAN MARC FRANCOIS;BALLET MICHAEL HERMAN J. Datos registrales. T 5525, L 4432, F 191, S 8, H MA134604, I/A 6(29.08.18).
Nombramientos. Aud.C.Con.: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos registrales. T 5525, L 4432, F 191, S 8, HMA134604, I/A 7 (29.08.18).
10 de Agosto de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: BALLET MICHAEL HERMAN J.;LETENNEUR ELSE;MARTENS TOON KRIS;VAN ROYKATLEEN;LAFOREST ERIC CLAUDE MICHEL. Datos registrales. T 5525, L 4432, F 191, S 8, H MA134604, I/A 4 (26.07.17).
Fe de erratas: MODIFICADO EL PODER OTORGADO EN FECHA 9-2-2016 ANTE NOTARIO DE TORRELODONES DON JUANLUIS HERNANDEZ GIL MANCHA N潞 240, EN EL SENTIDO DE EXTENDER LAS FACULTADES DE APODERAMIENTO A LASDECISONES DE CUALQUIERA ORGANOS DE LAS SOCIEDADES SEAN COLEGIADOS O NO Y SUSTANCIALMENTE A LAS DELORGANO ADMTVO. Datos registrales. T 5525, L 4432, F 191, S 8, H MA134604, I/A 5 (26.07.17).
22 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LYS CONSEIL SPRL. Nombramientos. Adm. Solid.: SOHO ASSOCIATES SPRL. Datos
22 de Junio de 2016Cambio de domicilio social. CTRA DEL AEROCLUB S/N - TERMINAL AVIACION GENERAL, (MALAGA). Datos registrales. T5525, L 4432, F 190, S 8, H MA134604, I/A 2 (14.06.16).
20 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: BALLET MICHAEL HERMAN J.;VAN ROY KATLEEN. Datos registrales. T 32693 , F 220, S 8, H M588546, I/A 17 (11.05.16).
27 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS ARAUZO LAURA TAIS;AZEVEDO STEVE;GALLEANI DESIREE;GOMEZ FRUCTUOSOFRANCISCO. Datos registrales. T 32693 , F 219, S 8, H M 588546, I/A 16 (19.04.16).
26 de Abril de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: AZEVEDO TAVERNEY STEVE. Datos registrales. T 32693 , F 219, S 8, H M 588546, I/A 15 (15.04.16).
22 de Abril de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: AZEVEDO TAVERNEY STEVE. Datos registrales. T 32693 , F 219, S 8, H M 588546, I/A 14 (15.04.16).
04 de Abril de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: IGLESIAS ARAUZO LAURA TAIS. Datos registrales. T 32693 , F 218, S 8, H M 588546, I/A 12(23.03.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: IGLESIAS ARAUZO LAURA TAIS. Datos registrales. T 32693 , F 218, S 8, H M 588546, I/A 13(23.03.16).
31 de Marzo de 2016Revocaciones. Apoderado: PAREJO PRIETO MARIA. Datos registrales. T 32693 , F 218, S 8, H M 588546, I/A 10 (22.03.16).
Revocaciones. Apoderado: PAREJO PRIETO MARIA. Datos registrales. T 32693 , F 218, S 8, H M 588546, I/A 11 (22.03.16).
18 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS ARAUZO LAURA TAIS. Datos registrales. T 32693 , F 217, S 8, H M 588546, I/A 9 (9.03.16).
04 de Marzo de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: GALLEANI DESIREE MACARENA;GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO. Datos registrales. T 32693 , F216, S 8, H M 588546, I/A 7 (25.02.16).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DIRECTORSHIP CIBELES SL. Representan: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO.Nombramientos. Representan: LEVAUX LAURENT MARIE JEAN PIERRE. Adm. Solid.: DITMAR BEEREPOOT MAURITS;LYSCONSEIL SPRL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Datosregistrales. T 32693 , F 216, S 8, H M 588546, I/A 8 (25.02.16).
07 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: PAREJO PRIETO MARIA;DITMAR BEEREPOOT MAURITS. Datos registrales. T 32693 , F 215, S 8, HM 588546, I/A 6 (30.11.15).
13 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apoderado: PAREJO PRIETO MARIA. Datos registrales. T 32693 , F 215, S 8, H M 588546, I/A 5 ( 4.11.15).
26 de Octubre de 2015Nombramientos. Apoderado: PAREJO PRIETO MARIA. Datos registrales. T 32693 , F 214, S 8, H M 588546, I/A 3 (16.10.15).
Nombramientos. Apo.Manc.: BALLET MICHAEL HERMAN J.;LETENNEUR ELSE;MARTENS TOON KRIS;VAN ROYKATLEEN;LAFOREST ERIC CLAUDE MICHEL. Datos registrales. T 32693 , F 215, S 8, H M 588546, I/A 4 (16.10.15).