Buscador CIF Logo

Actos BORME Avid Technology Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Avid Technology Sl

Actos BORME Avid Technology Sl - B83689760

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Avid Technology Sl con CIF B83689760

馃敊 Perfil de Avid Technology Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Avid Technology Sl

02 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apoderado: BURGON GAVIN NEELY;PERI SHANI;BROVAK MARINA. Datos registrales. T 19046 , F 219, S 8, HM 332975, I/A 33 (23.02.22).

Revocaciones. Apoderado: PIERRE DESBOIS BENJAMIN. Apo.Sol.: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA;DIAZ CRESPOROSALIA;RODRIGUEZ TORRES IRIA;RUIZ PE脩A SUSANA SONIA. Apo.Man.Soli: ORJI EMEKA PETER;HORTON DAVID;CORKMARIA BELMIRA FERNANDES. Datos registrales. T 19046 , F 220, S 8, H M 332975, I/A 34 (23.02.22).

22 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RENTERO ADRIAN VICENTE. Consejero: CORDINER TOM JAMES ANDREW;MELLONIALESSANDRA. Cons.Del.Sol: MELLONI ALESSANDRA;CORDINER TOM JAMES ANDREW. Consejero: MURRAY RYAN HEALEY.Presidente: MURRAY RYAN HEALEY. Cons.Del.Sol: MURRAY RYAN HEALEY. Nombramientos. Adm. Solid.: CORDINER TOMJAMES ANDREW;MELLONI ALESSANDRA CACILIA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 19046 , F 219, S 8, H M 332975, I/A 32 (15.11.19).

27 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL VAL HERNANDEZ GONZALO GUILLERMO. Datos registrales. T 19046 , F 217, S 8, H M332975, I/A 30 (19.12.18).

26 de Diciembre de 2018
Otros conceptos: Subsanaci贸n del n煤mero de identificaci贸n extranjero de Don Ryan Healey Murray siendo el correcto: Y6720632T.Datos registrales. T 19046 , F 217, S 8, H M 332975, I/A 29 (17.12.18).

22 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: AGLE BRIAN ELMER. Presidente: AGLE BRIAN ELMER. Cons.Del.Sol: AGLE BRIAN ELMER.Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ SERRANO ISABEL;PEREZ MANSILLA DELGADO PATRICIA. Nombramientos. Consejero:MURRAY RYAN HEALEY. Presidente: MURRAY RYAN HEALEY. Cons.Del.Sol: MURRAY RYAN HEALEY. Datos registrales. T19046 , F 216, S 8, H M 332975, I/A 28 (14.11.18).

27 de Junio de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORJI EMEKA PETER;HORTON DAVID;WILSON JANE ELIZABETH;SAPPAK ERKAN;MCKENZIEANDREA ODETH;CORK MARIA BELMIRA FERNANDES. Datos registrales. T 19046 , F 216, S 8, H M 332975, I/A 27 (20.06.18).

29 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: WITHEROW BROWN ADAM JOHN;SPOHER NICOLA ANN;PANCHAL PANKAJ;BARTOLAVALENTINA;O'REILLY MARIE;CUVA LAILA. Nombramientos. Cons.Del.Sol: MELLONI ALESSANDRA;AGLE BRIANELMER;CORDINER TOM JAMES ANDREW. Apo.Sol.: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA;DIAZ CRESPO ROSALIA;RODRIGUEZTORRES IRIA;PEREZ SERRANO ISABEL;PEREZ MANSILLA DELGADO PATRICIA;RUIZ PE脩A SUSANA SONIA. Modificacionesestatutarias. Creacion del articulo 10 Bis en los estatutos sociales . Datos registrales. T 19046 , F 214, S 8, H M 332975, I/A 26(22.11.17).

28 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: DUVA JASON ADAM;FREDERICK JOHN WILBERT. Presidente: FREDERICK JOHN WILBERT.Nombramientos. Consejero: MELLONI ALESSANDRA;AGLE BRIAN ELMER. Presidente: AGLE BRIAN ELMER. Datos registrales.T 19046 , F 214, S 8, H M 332975, I/A 25 (17.11.17).

21 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: SPOHRER NICOLA ANN. Nombramientos. Consejero: CORDINER TOM JAMES ANDREW. Datosregistrales. T 19046 , F 213, S 8, H M 332975, I/A 23 (13.11.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SEXTON KENNETH-ALLEN. Cons.Del.Sol: SEXTON KENNETH-ALLEN. Presidente: SEXTONKENNETH-ALLEN. Nombramientos. Consejero: FREDERICK JOHN WILBERT. Presidente: FREDERICK JOHN WILBERT. Datosregistrales. T 19046 , F 214, S 8, H M 332975, I/A 24 (14.11.17).

10 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: PARISI PAIGE. Cons.Del.Sol: PARISI PAIGE. Nombramientos. Consejero: DUVA JASON ADAM.Datos registrales. T 19046 , F 213, S 8, H M 332975, I/A 21 (29.12.11).

14 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Presidente: HENNESSY PAUL PATRICK. Cons.Del.Sol: HENNESSY PAUL PATRICK. Consejero: HENNESSYPAUL PATRICK. Nombramientos. Presidente: SEXTON KENNETH-ALLEN. Consejero: SPOHRER NICOLA ANN. Datosregistrales. T 19046 , F 212, S 8, H M 332975, I/A 20 ( 2.09.11).

14 de Julio de 2011
Revocaciones. Apoderado: SEMIN FRANCOISE MARIE HUGUETTE. Nombramientos. Apoderado: PIERRE DESBOISBENJAMIN. Datos registrales. T 19046 , F 54, S 8, H M 332975, I/A 19 ( 4.07.11).

30 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: DARRAS CRISTOPHE FAIDHERBE;DARRAS CHRISTOPHE FAIDHERBE. Nombramientos.Apoderado: SEMIN FRANCOISE MARIE HUGUETTE. Datos registrales. T 19046 , F 53, S 8, H M 332975, I/A 18 (18.11.10).

29 de Marzo de 2010
Revocaciones. Apoderado: CLEMENTE GALERA MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apoderado: DARRAS CHRISTOPHEFAIDHERBE. Datos registrales. T 19046 , F 52, S 8, H M 332975, I/A 17 (16.03.10).

24 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOCELYN PATRICK. Presidente: JOCELYN PATRICK. Cons.Del.Sol: JOCELYN PATRICK.Nombramientos. Consejero: HENNESSY PAUL PATRICK. Presidente: HENNESSY PAUL PATRICK. Cons.Del.Sol: HENNESSYPAUL PATRICK. Datos registrales. T 19046 , F 51, S 8, H M 332975, I/A 16 (12.02.10).

27 de Enero de 2010
Cambio de domicilio social. AVDA DE LA ZARZUELA, NUMERO 21, 3潞 A-B (MADRID). Datos registrales. T 19046 , F 51, S 8, HM 332975, I/A 15 (15.01.10).

04 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: DARRAS CRISTOPHE FAIDHERBE. Datos registrales. T 19046 , F 50, S 8, H M 332975, I/A 14(24.11.09).

03 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Cons.Del.Sol: JOCELYN PATRICK;SEXTON KENNETH-ALLEN;PARISI PAIGE. Datos registrales. T 19046 , F 50,S 8, H M 332975, I/A 12 (24.11.09).

Revocaciones. Apoderado: O'KELLY EMER MICHAEL;SHARP GRAHAM;JACKS ETHAN EDWARDS;KAZMER CAROLELIZABETH;O'KELLY EMER MICHAEL;STREET ARTHUR GOTTFRIED GEORGE;SMITH ANN ELIZABETH;VILLAR TEJEROAMERICA;BEITH ANJA MARIANNE;STEINKE-TIEPOLD BRIGITTE ERIKA EDITH. Datos registrales. T 19046 , F 50, S 8, H M332975, I/A 13 (24.11.09).

10 de Septiembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: KAZMER CAROL ELIZABETH;JACKS ETHAN EDWARDS. Nombramientos. Consejero: PARISIPAIGE. Datos registrales. T 19046 , F 48, S 8, H M 332975, I/A 10 (31.08.09).

Nombramientos. Apoderado: CLEMENTE GALERA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 19046 , F 49, S 8, H M 332975, I/A 11(31.08.09).

22 de Mayo de 2009
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ MU脩OZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 19046 , F 48, S 8, H M 332975, I/A 9(11.05.09).

21 de Mayo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: O'KELLY EMER MICHAEL. Presidente: O'KELLY EMER MICHAEL. Nombramientos. Consejero:JOCELYN PATRICK;SEXTON KENNETH-ALLEN. Presidente: JOCELYN PATRICK. Datos registrales. T 19046 , F 48, S 8, H M332975, I/A 8 (11.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n