Actos BORME de Avifood Sociedad Limitada
14 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: MEJIAS UNGRIA LIDIA. Datos registrales. T 3219 , F 53, S 8, H T 33797, I/A 28 ( 7.03.23).
07 de Enero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHIS MAS FRANCISCO IGNACIO;ARISA SANCHEZ ANNA;PEREZ HOLGADO DAVID;CORTESGONZALEZ LIDIA. Datos registrales. T 3219 , F 52, S 8, H T 33797, I/A 25 (30.12.21).
07 de Diciembre de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.997.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Datos registrales. T 3219 , F51, S 8, H T 33797, I/A 24 (29.11.21).
15 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: RIOS ALONSO BUENAPOSADA JOSE RAMON;CORTES GONZALEZ LIDIA;ARISA SANCHEZANNA;PEREZ HOLGADO DAVID;ORIVE ISERN ROSER;MEJIAS UNGRIA LIDIA. Datos registrales. T 3219 , F 50, S 8, H T 33797,I/A 23 ( 5.11.21).
16 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: VILA BORRELL JOAN;SALVADO MARTI JOAN;DIT CHICOY EMMANUEL LAYOUS;GALVETEIBA脩EZ JOSE;FERRE MAS JOSE LUIS. Apo.Sol.: ESCALE AREGAY MONTSERRAT;MU脩OZ RUIZ CRISTINA;LOPEZ CONGOSTANNA. Apoderado: SANCHIS MAS FRANCISCO IGNACIO;CORTES GONZALEZ LIDIA;NAVARRETE FOMBELLA SONIA MARIA.Datos registrales. T 3219 , F 50, S 8, H T 33797, I/A 22 ( 4.12.20).
14 de Octubre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: SALVADO MARTI JOAN;GALVETE IBA脩EZ JOSE;DIT CHICOY EMMANUEL LAYOUS;VAZQUEZA脩ON PEREZ JUAN JOSE;FERRE MAS JOSE LUIS;RIPOLLES RODRIGUEZ FAUSTINO;ESCALE AREGAYMONTSERRAT;MU脩OZ RUIZ MARIA CRISTINA;LOPEZ CONGOST ANA MARIA. Apo.Sol.: SANCHIS MAS FRANCISCOIGNACIO;ESCALE AREGAY MONTSERRAT;MU脩OZ RUIZ MARIA CRISTINA;ARISA SANCHEZ ANNA;PEREZ HOLGADODAVID;NAVARRETE FOMBELLA SONIA MARIA;GALVETE IBA脩EZ JOSE;DIT CHICOY EMMANUEL LAYOUS;ESCALE AREGAYMONTSERRAT;MU脩OZ RUIZ MARIA CRISTINA;PEREZ LOIS ROBERTO;CORTES GONZALEZ LIDIA. Otros conceptos:Modificado el art铆culo 21潞 de los Estatutos sociales.- Retribuci贸n del cargo.- Datos registrales. T 2985 , F 128, S 8, H T 33797, I/A 21( 5.10.20).
19 de Agosto de 2020Otros conceptos: CAMBIADO EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRADORA MANCOMUNADA SARIA BIO-INDUSTRIESESPA脩A, SL POR LA PERSONA FISICA DE DON EMMANUEL LAYOUS DIT CHICOY.- Datos registrales. T 2985 , F 128, S 8, H T33797, I/A 20 (12.08.20).
20 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: VILA BORRELL JOAN;SALVADOR MARTI JOAN. Nombramientos. Adm. Mancom.: SARIA BIO-INDUSTRIES ESPA脩A SL;PAVO Y DERIVADOS SA. Otros conceptos: Refundidos la totalidad de los Estatutos Sociales.- Cambiodel Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 2985 , F 118, S 8,H T 33797, I/A 17 (12.08.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILA BORRELL JOAN;SALVADO MARTI JOAN;DIT CHICOY EMMANUEL LAYOUS;GALVETEIBA脩EZ JOSE;FERRE MAS JOSE LUIS. Apo.Sol.: ESCALE AREGAY MONTSERRAT;MU脩OZ RUIZ CRISTINA;LOPEZ CONGOSTANNA. Apoderado: SANCHIS MAS FRANCISCO IGNACIO;CORTES GONZALEZ LIDIA;NAVARRETE FOMBELLA SONIA MARIA.Datos registrales. T 2985 , F 123, S 8, H T 33797, I/A 18 (12.08.19).
Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHIS MAS FRANCISCO IGNACIO. Apo.Man.Soli: ESCALE AREGAY MONTSERRAT;LOPEZCONGOST ANA MARIA;GALVETE IBA脩EZ JOSE. Datos registrales. T 2985 , F 127, S 8, H T 33797, I/A 19 (12.08.19).
30 de Julio de 2019Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: PONT MESTRES AUDITORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA.Nombramientos. Auditor: PONT MESTRES AUDITORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 2985 , F 118, S8, H T 33797, I/A 16 (23.07.19).
23 de Enero de 2019Otros conceptos: Modificado el art铆culo 19潞 de los estatutos sociales en cuanto al sistema de retribuci贸n.- Datos registrales. T 2985, F 118, S 8, H T 33797, I/A 15 (16.01.19).
20 de Diciembre de 2016Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: PONT MESTRES AUDITORES ASOCIADOS SA. Nombramientos. Auditor:PONT MESTRES AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 2596 , F 129, S 8, H T 33797, I/A 12 (13.12.16).
Revocaciones. Apo.Manc.: VILA BORRELL JOAN;MAS ASAMARA VICENS;VILA BORRELL JOAN. Apo.Man.Soli: LEA脩OHERRERA VICTOR. Apo.Manc.: MAS ASAMARA VICENS;LOPEZ CONGOST ANA;ESCALE AREGAY MONTSERRAT.Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESCALE AREGAY MONTSERRAT;LOPEZ CONGOST ANA MARIA;GALVETE IBA脩EZ JOSE.Datos registrales. T 2596 , F 129, S 8, H T 33797, I/A 13 (13.12.16).
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: PONT MESTRES AUDITORES ASOCIADOS SA. Nombramientos. Auditor:PONT MESTRES AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 2985 , F 118, S 8, H T 33797, I/A 14 (13.12.16).
03 de Diciembre de 2015Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL BARRANC DE LLEDO - PARCELA 1 (SANTA BARBARA). Datos registrales. T2596 , F 126, S 8, H T 33797, I/A 10 (24.11.15).
Revocaciones. Apoderado: GARCIA DALMAU ENRIQUE. Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHIS MAS FRANCISCO IGNACIO.Datos registrales. T 2596 , F 126, S 8, H T 33797, I/A 11 (24.11.15).
22 de Enero de 2013Nombramientos. Auditor: PONT MESTRES AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 2596 , F 126, S 8, H T 33797, I/A 9( 9.01.13).
12 de Marzo de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: SAGNIER RIVIERE ROQUE. Datos registrales. T 2596 , F 126, S 8, H T 33797, I/A 8 (24.02.12).
17 de Mayo de 2011Nombramientos. Apo.Manc.: LOPEZ CONGOST ANA;ESCALE AREGAY MONTSERRAT. Datos registrales. T 2596 , F 123, S 8, HT 33797, I/A 6 ( 6.05.11).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA DALMAU ENRIQUE. Datos registrales. T 2596 , F 124, S 8, H T 33797, I/A 7 ( 6.05.11).
16 de Febrero de 2011Nombramientos. Apo.Manc.: VILA BORRELL JOAN. Apo.Man.Soli: SAGNIER RIVIERE ROQUE. Apo.Manc.: MAS ASAMARAVICENS. Datos registrales. T 2197 , F 173, S 8, H T 33797, I/A 4 ( 7.02.11).
Nombramientos. Apo.Manc.: VILA BORRELL JOAN. Apo.Man.Soli: LEA脩O HERRERA VICTOR. Apo.Manc.: MAS ASAMARAVICENS. Datos registrales. T 2596 , F 119, S 8, H T 33797, I/A 5 ( 7.02.11).
02 de Marzo de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 2197 , F 172, S8, H T 33797, I/A 3 (17.02.10).