Actos BORME de Axion Infraestructuras De Telecomunicaciones Sociedad Anonima
25 de Abril de 2023Otros conceptos: De conformidad con el articulo 122.3 del RRM se procede a la constancia de haberse impreso y entregado 1 TituloMultiple, representativo del total capital a su accionista 煤nico. Datos registrales. T 7309 , F 37, S 8, H SE 37970, I/A 116 2 (18.04.23).
07 de Febrero de 2023Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: MARQUES TOPCO SL. Datos registrales. T 7309 , F 37, S 8, H SE37970, I/A 115 (27.01.23).
Nombramientos. Apoderado: LUCENA SOLDEVILLA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 7309 , F 37, S 8, H SE 37970, I/A 116(27.01.23).
20 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO CASTRO JUAN;DORADO LOBERA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 6542 , F 143, S8, H SE 37970, I/A 114 (12.12.22).
19 de Diciembre de 2022Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ATALAYA SPANISH GROUP SL. ATALAYA SPANISH BIDCO SL. Datosregistrales. T 6542 , F 143, S 8, H SE 37970, I/A 113 (12.12.22).
31 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: JIMENEZ PEREZ JORGE ALBERTO. Apo.Man.Soli: MORALES CAMPRUBI CARLOSFRANCISCO;MOLINA ORTEGA ISABEL;BENITEZ CLAVIJO CARMEN. Datos registrales. T 6542 , F 141, S 8, H SE 37970, I/A 111(23.05.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO;MOLINA ORTEGA ISABEL;BENITEZ CLAVIJOCARMEN. Apo.Manc.: GARCIA CUARTANGO MARIA ARACELI;GARATE PEREZ JUAN MARIA. Datos registrales. T 6542 , F 141,S 8, H SE 37970, I/A 112 (23.05.22).
24 de Marzo de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.042.628,61 Euros. Resultante Suscrito: 38.788.810,45 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 6542 , F 140, S 8, H SE 37970, I/A 110 (17.03.22).
07 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: JIMENEZ PEREZ JORGE ALBERTO. Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA CUARTANGOMARIA ARACELI. Datos registrales. T 6542 , F 140, S 8, H SE 37970, I/A 109 (23.02.22).
01 de Marzo de 2022Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 6542 , F 140, S 8, H SE 37970,I/A 108 (21.02.22).
29 de Octubre de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.400.001,24 Euros. Resultante Suscrito: 41.831.439,06 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: Articulo 5潞 - Capital social. Datos registrales. T 6542 , F 139, S 8, H SE 37970, I/A 107(21.10.21).
13 de Abril de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: PANSARD MARTIN GONZALO. Apoderado: ECHEVERRIA ARNAIZ PABLO. Datos registrales. T6542 , F 139, S 8, H SE 37970, I/A 106 ( 5.04.21).
22 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: MITRANI GUIDO LUCIO;URBAN MU脩OZ SEBASTIAN;ALVAREZ FERNANDEZ JORGE JUAN;CECILEPERROTTE JULIE DIANA LEGIAN;COLLAR OLASO EDUARDO;GONZALEZ ARIAS MANUELA;HERNANDEZ GONZALEZFELIX;BERJON DE LA VEGA JOSE;ECHEVARRIA GONZALEZ RICARDO. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9. Datosregistrales. T 6542 , F 138, S 8, H SE 37970, I/A 105 (11.03.21).
26 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST &YOUNG SL. Datos registrales. T 6542 , F 138, S 8, H SE 37970, I/A 104 (16.02.21).
24 de Febrero de 2021Revocaciones. Apoderado: ARMERO MONTES MARIO. Datos registrales. T 6542 , F 137, S 8, H SE 37970, I/A 103 (15.02.21).
10 de Noviembre de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.249.070,00 Euros. Resultante Suscrito: 45.231.440,30 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 6542 , F 137, S 8, H SE 37970, I/A 102 (30.10.20).
29 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: PE脩AS DE BUSTILLO CRISTINA. Datos registrales. T 6542 , F 135, S 8, H SE 37970, I/A 100(24.04.20).
11 de Mayo de 2020Nombramientos. Apoderado: ARMERO MONTES MARIO. Datos registrales. T 6542 , F 136, S 8, H SE 37970, I/A 101 (24.04.20).
14 de Abril de 2020Revocaciones. Apoderado: PRIETO JANO ALBERTO. Datos registrales. T 6542 , F 135, S 8, H SE 37970, I/A 99 (18.03.20).
24 de Enero de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.699.994,61 Euros. Resultante Suscrito: 49.480.510,30 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 6542 , F 135, S 8, H SE 37970, I/A 98 (14.01.20).
11 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: ECHEVERRIA ARNAIZ PABLO. Datos registrales. T 6542 , F 134, S 8, H SE 37970, I/A 97(27.11.19).
07 de Agosto de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.864.997,05 Euros. Resultante Suscrito: 51.180.504,91 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 6542 , F 133, S 8, H SE 37970, I/A 96 (31.07.19).
22 de Marzo de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.780.997,39 Euros. Resultante Suscrito: 54.045.501,96 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5潞. Capital social.-. Datos registrales. T 6542 , F 133, S 8, H SE 37970, I/A 95 (13.03.19).
20 de Febrero de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ PEREZ JORGE ALBERTO. Apo.Man.Soli: MORALES CAMPRUBI CARLOSFRANCISCO;MOLINA ORTEGA ISABEL;BENITEZ CLAVIJO CARMEN;PANSARD MARTIN GONZALO. Datos registrales. T 6542 ,F 130, S 8, H SE 37970, I/A 93 (13.02.19).
Revocaciones. Apo.Manc.: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO;MOLINA ORTEGA ISABEL;BENITEZ CLAVIJOCARMEN;PANSARD MARTIN GONZALO;JIMENEZ PEREZ JORGE ALBERTO. Apo.Sol.: PANSARD MARTIN GONZALO;MORALESCAMPRUBI CARLOS FRANCISCO;MOLINA ORTEGA ISABEL;BENITEZ CLAVIJO CARMEN. Datos registrales. T 6542 , F 133, S 8,H SE 37970, I/A 94 (13.02.19).
31 de Mayo de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.851.001,87 Euros. Resultante Suscrito: 55.826.499,35 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 5548 , F 170, S 8, H SE 37970, I/A 92 (21.05.18).
22 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: GARATE PEREZ JUAN MARIA. Datos registrales. T 5548 , F 170, S 8, H SE 37970, I/A 90(11.05.18).
Revocaciones. Apoderado: PANSARD MARTIN GONZALO. Datos registrales. T 5548 , F 170, S 8, H SE 37970, I/A 91 (11.05.18).
01 de Febrero de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.592.607,93 Euros. Resultante Suscrito: 57.677.501,22 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 5548 , F 169, S 8, H SE 37970, I/A 89 (24.01.18).
27 de Diciembre de 2017Nombramientos. Auditor: ERNST &YOUNG SL. Datos registrales. T 5548 , F 169, S 8, H SE 37970, I/A 88 (19.12.17).
16 de Noviembre de 2017Reelecciones. Adm. Unico: JIMENEZ PEREZ JORGE ALBERTO. Datos registrales. T 5548 , F 138, S 8, H SE 37970, I/A 87 (6.11.17).
22 de Mayo de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.999.997,57 Euros. Resultante Suscrito: 59.270.109,15 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 5潞.- Capital social.-. Datos registrales. T 5548 , F 138, S 8, H SE 37970, I/A 86 (9.05.17).
22 de Marzo de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5548 , F 137, S 8, H SE 37970, I/A 85 (13.03.17).
21 de Febrero de 2017Modificaciones estatutarias. 28. Nombramiento, retribuci贸n.-. Datos registrales. T 5548 , F 137, S 8, H SE 37970, I/A 84 ( 9.02.17).
23 de Enero de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: JIMENEZ PEREZ JORGE ALBERTO;PANSARD MARTIN GONZALO. Apoderado: PANSARD MARTINGONZALO. Apo.Manc.: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO. Apoderado: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO.Apo.Manc.: MOLINA ORTEGA ISABEL. Apoderado: MOLINA ORTEGA ISABEL. Apo.Manc.: BENITEZ CLAVIJO CARMEN.Apoderado: BENITEZ CLAVIJO CARMEN. Datos registrales. T 5548 , F 134, S 8, H SE 37970, I/A 82 (10.01.17).
Nombramientos. Apo.Manc.: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO;MOLINA ORTEGA ISABEL;BENITEZ CLAVIJO
30 de Mayo de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.900.001,08 Euros. Resultante Suscrito: 63.270.106,72 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 5潞.- Capital social.-. Datos registrales. T 5548 , F 133, S 8, H SE 37970, I/A 81(23.05.16).
04 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: BENITEZ CLAVIJO CARMEN;PANSARD MARTIN GONZALO. Datos registrales. T 5548 , F 133, S 8, HSE 37970, I/A 80 (28.03.16).
15 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5548 , F 133, S 8, H SE 37970, I/A 79 ( 4.01.16).
17 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: MOLINA ORTEGA ISABEL. Apoderado: PRIETO JANO ALBERTO. Apo.Sol.: MU脩OZ SANTANAALVARO;HURTADO DUE脩AS FRANCISCO;ESCRICHE MONSALVE CARLOS;BURGOS CABALLERO ANA;HURTADO DUE脩ASFRANCISCO;ESCRICHE MONSALVE CARLOS. Apoderado: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO;PANSARD MARTINGONZALO. Otros conceptos: Se revoca el poder conferido a DON MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, con D.N.I. n煤mero43.361.239-Y, en escritura autorizada por el notario de Madrid, Don Pablo de la Esperanza Rodr铆guez, el d铆a 4 de diciembre de 2007,n煤mero 5.188 de protocolo, el cual no consta inscrito en este Registro.- DON JORGE ALBERTO JIMENEZ PEREZ, REVOCA lasfacultades que le fueron delegadas -en su anterior cargo de consejero delegado de la sociedad-, en escritura autorizada por notario de
25 de Junio de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ PEREZ JORGE ALBERTO;PANSARD MARTIN GONZALO. Apoderado: PANSARD MARTINGONZALO. Apo.Manc.: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO. Apoderado: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO.Apo.Manc.: MOLINA ORTEGA ISABEL. Apoderado: MOLINA ORTEGA ISABEL. Apo.Manc.: BENITEZ CLAVIJO CARMEN.Apoderado: BENITEZ CLAVIJO CARMEN. Datos registrales. T 5548 , F 127, S 8, H SE 37970, I/A 74 (17.06.15).
Nombramientos. Apoderado: ESCRICHE MONSALVE CARLOS. Datos registrales. T 5548 , F 130, S 8, H SE 37970, I/A 75(18.06.15).
Nombramientos. Apoderado: HURTADO DUE脩AS FRANCISCO. Datos registrales. T 5548 , F 131, S 8, H SE 37970, I/A 76(18.06.15).
Nombramientos. Apoderado: PRIETO JANO ALBERTO. Datos registrales. T 5548 , F 131, S 8, H SE 37970, I/A 77 (18.06.15).
05 de Junio de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: MU脩OZ SANTANA ALVARO. Datos registrales. T 5548 , F 126, S 8, H SE 37970, I/A 71 (27.05.15).
Nombramientos. Apoderado: BURGOS CABALLERO ANA. Datos registrales. T 5548 , F 126, S 8, H SE 37970, I/A 72 (27.05.15).
Nombramientos. Apoderado: PANSARD MARTIN GONZALO. Datos registrales. T 5548 , F 127, S 8, H SE 37970, I/A 73(27.05.15).
17 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apoderado: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO. Datos registrales. T 5548 , F 124, S 8, H SE 37970,I/A 69 ( 1.09.14).
Nombramientos. Apoderado: PANSARD MARTIN GONZALO. Datos registrales. T 5548 , F 125, S 8, H SE 37970, I/A 70 ( 1.09.14).
10 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apoderado: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO. Datos registrales. T 5548 , F 123, S 8, H SE 37970, I/A67 ( 1.09.14).
Revocaciones. Apoderado: PANSARD MARTIN GONZALO. Apo.Sol.: PANSARD MARTIN GONZALO. Datos registrales. T 5548 ,F 124, S 8, H SE 37970, I/A 68 ( 1.09.14).
23 de Octubre de 2013Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5548 , F 123, S 8, H SE 37970, I/A 66 (16.10.13).