Buscador CIF Logo

Actos BORME Axion Infraestructuras De Telecomunicaciones Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Axion Infraestructuras De Telecomunicaciones Sociedad Anonima

Actos BORME Axion Infraestructuras De Telecomunicaciones Sociedad Anonima - A41999913

Tenemos registrados 52 Actos BORME del Registro Mercantil de Sevilla para Axion Infraestructuras De Telecomunicaciones Sociedad Anonima con CIF A41999913

馃敊 Perfil de Axion Infraestructuras De Telecomunicaciones Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Sevilla

Actos BORME de Axion Infraestructuras De Telecomunicaciones Sociedad Anonima

25 de Abril de 2023
Otros conceptos: De conformidad con el articulo 122.3 del RRM se procede a la constancia de haberse impreso y entregado 1 TituloMultiple, representativo del total capital a su accionista 煤nico. Datos registrales. T 7309 , F 37, S 8, H SE 37970, I/A 116 2 (18.04.23).

07 de Febrero de 2023
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: MARQUES TOPCO SL. Datos registrales. T 7309 , F 37, S 8, H SE37970, I/A 115 (27.01.23).

Nombramientos. Apoderado: LUCENA SOLDEVILLA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 7309 , F 37, S 8, H SE 37970, I/A 116(27.01.23).

20 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO CASTRO JUAN;DORADO LOBERA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 6542 , F 143, S8, H SE 37970, I/A 114 (12.12.22).

19 de Diciembre de 2022
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ATALAYA SPANISH GROUP SL. ATALAYA SPANISH BIDCO SL. Datosregistrales. T 6542 , F 143, S 8, H SE 37970, I/A 113 (12.12.22).

31 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: JIMENEZ PEREZ JORGE ALBERTO. Apo.Man.Soli: MORALES CAMPRUBI CARLOSFRANCISCO;MOLINA ORTEGA ISABEL;BENITEZ CLAVIJO CARMEN. Datos registrales. T 6542 , F 141, S 8, H SE 37970, I/A 111(23.05.22).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO;MOLINA ORTEGA ISABEL;BENITEZ CLAVIJOCARMEN. Apo.Manc.: GARCIA CUARTANGO MARIA ARACELI;GARATE PEREZ JUAN MARIA. Datos registrales. T 6542 , F 141,S 8, H SE 37970, I/A 112 (23.05.22).

24 de Marzo de 2022
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.042.628,61 Euros. Resultante Suscrito: 38.788.810,45 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 6542 , F 140, S 8, H SE 37970, I/A 110 (17.03.22).

07 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: JIMENEZ PEREZ JORGE ALBERTO. Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA CUARTANGOMARIA ARACELI. Datos registrales. T 6542 , F 140, S 8, H SE 37970, I/A 109 (23.02.22).

01 de Marzo de 2022
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 6542 , F 140, S 8, H SE 37970,I/A 108 (21.02.22).

29 de Octubre de 2021
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.400.001,24 Euros. Resultante Suscrito: 41.831.439,06 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: Articulo 5潞 - Capital social. Datos registrales. T 6542 , F 139, S 8, H SE 37970, I/A 107(21.10.21).

13 de Abril de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PANSARD MARTIN GONZALO. Apoderado: ECHEVERRIA ARNAIZ PABLO. Datos registrales. T6542 , F 139, S 8, H SE 37970, I/A 106 ( 5.04.21).

22 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: MITRANI GUIDO LUCIO;URBAN MU脩OZ SEBASTIAN;ALVAREZ FERNANDEZ JORGE JUAN;CECILEPERROTTE JULIE DIANA LEGIAN;COLLAR OLASO EDUARDO;GONZALEZ ARIAS MANUELA;HERNANDEZ GONZALEZFELIX;BERJON DE LA VEGA JOSE;ECHEVARRIA GONZALEZ RICARDO. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9. Datosregistrales. T 6542 , F 138, S 8, H SE 37970, I/A 105 (11.03.21).

26 de Febrero de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST &YOUNG SL. Datos registrales. T 6542 , F 138, S 8, H SE 37970, I/A 104 (16.02.21).

24 de Febrero de 2021
Revocaciones. Apoderado: ARMERO MONTES MARIO. Datos registrales. T 6542 , F 137, S 8, H SE 37970, I/A 103 (15.02.21).

10 de Noviembre de 2020
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.249.070,00 Euros. Resultante Suscrito: 45.231.440,30 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 6542 , F 137, S 8, H SE 37970, I/A 102 (30.10.20).

29 de Junio de 2020
Nombramientos. Apoderado: PE脩AS DE BUSTILLO CRISTINA. Datos registrales. T 6542 , F 135, S 8, H SE 37970, I/A 100(24.04.20).

11 de Mayo de 2020
Nombramientos. Apoderado: ARMERO MONTES MARIO. Datos registrales. T 6542 , F 136, S 8, H SE 37970, I/A 101 (24.04.20).

14 de Abril de 2020
Revocaciones. Apoderado: PRIETO JANO ALBERTO. Datos registrales. T 6542 , F 135, S 8, H SE 37970, I/A 99 (18.03.20).

24 de Enero de 2020
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.699.994,61 Euros. Resultante Suscrito: 49.480.510,30 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 6542 , F 135, S 8, H SE 37970, I/A 98 (14.01.20).

11 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: ECHEVERRIA ARNAIZ PABLO. Datos registrales. T 6542 , F 134, S 8, H SE 37970, I/A 97(27.11.19).

07 de Agosto de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.864.997,05 Euros. Resultante Suscrito: 51.180.504,91 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 6542 , F 133, S 8, H SE 37970, I/A 96 (31.07.19).

22 de Marzo de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.780.997,39 Euros. Resultante Suscrito: 54.045.501,96 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5潞. Capital social.-. Datos registrales. T 6542 , F 133, S 8, H SE 37970, I/A 95 (13.03.19).

20 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ PEREZ JORGE ALBERTO. Apo.Man.Soli: MORALES CAMPRUBI CARLOSFRANCISCO;MOLINA ORTEGA ISABEL;BENITEZ CLAVIJO CARMEN;PANSARD MARTIN GONZALO. Datos registrales. T 6542 ,F 130, S 8, H SE 37970, I/A 93 (13.02.19).

Revocaciones. Apo.Manc.: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO;MOLINA ORTEGA ISABEL;BENITEZ CLAVIJOCARMEN;PANSARD MARTIN GONZALO;JIMENEZ PEREZ JORGE ALBERTO. Apo.Sol.: PANSARD MARTIN GONZALO;MORALESCAMPRUBI CARLOS FRANCISCO;MOLINA ORTEGA ISABEL;BENITEZ CLAVIJO CARMEN. Datos registrales. T 6542 , F 133, S 8,H SE 37970, I/A 94 (13.02.19).

31 de Mayo de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.851.001,87 Euros. Resultante Suscrito: 55.826.499,35 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 5548 , F 170, S 8, H SE 37970, I/A 92 (21.05.18).

22 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apoderado: GARATE PEREZ JUAN MARIA. Datos registrales. T 5548 , F 170, S 8, H SE 37970, I/A 90(11.05.18).

Revocaciones. Apoderado: PANSARD MARTIN GONZALO. Datos registrales. T 5548 , F 170, S 8, H SE 37970, I/A 91 (11.05.18).

01 de Febrero de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.592.607,93 Euros. Resultante Suscrito: 57.677.501,22 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 5548 , F 169, S 8, H SE 37970, I/A 89 (24.01.18).

27 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Auditor: ERNST &YOUNG SL. Datos registrales. T 5548 , F 169, S 8, H SE 37970, I/A 88 (19.12.17).

16 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Adm. Unico: JIMENEZ PEREZ JORGE ALBERTO. Datos registrales. T 5548 , F 138, S 8, H SE 37970, I/A 87 (6.11.17).

22 de Mayo de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.999.997,57 Euros. Resultante Suscrito: 59.270.109,15 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 5潞.- Capital social.-. Datos registrales. T 5548 , F 138, S 8, H SE 37970, I/A 86 (9.05.17).

22 de Marzo de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5548 , F 137, S 8, H SE 37970, I/A 85 (13.03.17).

21 de Febrero de 2017
Modificaciones estatutarias. 28. Nombramiento, retribuci贸n.-. Datos registrales. T 5548 , F 137, S 8, H SE 37970, I/A 84 ( 9.02.17).

23 de Enero de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: JIMENEZ PEREZ JORGE ALBERTO;PANSARD MARTIN GONZALO. Apoderado: PANSARD MARTINGONZALO. Apo.Manc.: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO. Apoderado: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO.Apo.Manc.: MOLINA ORTEGA ISABEL. Apoderado: MOLINA ORTEGA ISABEL. Apo.Manc.: BENITEZ CLAVIJO CARMEN.Apoderado: BENITEZ CLAVIJO CARMEN. Datos registrales. T 5548 , F 134, S 8, H SE 37970, I/A 82 (10.01.17).

Nombramientos. Apo.Manc.: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO;MOLINA ORTEGA ISABEL;BENITEZ CLAVIJO

30 de Mayo de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.900.001,08 Euros. Resultante Suscrito: 63.270.106,72 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 5潞.- Capital social.-. Datos registrales. T 5548 , F 133, S 8, H SE 37970, I/A 81(23.05.16).

04 de Abril de 2016
Revocaciones. Apoderado: BENITEZ CLAVIJO CARMEN;PANSARD MARTIN GONZALO. Datos registrales. T 5548 , F 133, S 8, HSE 37970, I/A 80 (28.03.16).

15 de Enero de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5548 , F 133, S 8, H SE 37970, I/A 79 ( 4.01.16).

17 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: MOLINA ORTEGA ISABEL. Apoderado: PRIETO JANO ALBERTO. Apo.Sol.: MU脩OZ SANTANAALVARO;HURTADO DUE脩AS FRANCISCO;ESCRICHE MONSALVE CARLOS;BURGOS CABALLERO ANA;HURTADO DUE脩ASFRANCISCO;ESCRICHE MONSALVE CARLOS. Apoderado: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO;PANSARD MARTINGONZALO. Otros conceptos: Se revoca el poder conferido a DON MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, con D.N.I. n煤mero43.361.239-Y, en escritura autorizada por el notario de Madrid, Don Pablo de la Esperanza Rodr铆guez, el d铆a 4 de diciembre de 2007,n煤mero 5.188 de protocolo, el cual no consta inscrito en este Registro.- DON JORGE ALBERTO JIMENEZ PEREZ, REVOCA lasfacultades que le fueron delegadas -en su anterior cargo de consejero delegado de la sociedad-, en escritura autorizada por notario de

25 de Junio de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ PEREZ JORGE ALBERTO;PANSARD MARTIN GONZALO. Apoderado: PANSARD MARTINGONZALO. Apo.Manc.: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO. Apoderado: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO.Apo.Manc.: MOLINA ORTEGA ISABEL. Apoderado: MOLINA ORTEGA ISABEL. Apo.Manc.: BENITEZ CLAVIJO CARMEN.Apoderado: BENITEZ CLAVIJO CARMEN. Datos registrales. T 5548 , F 127, S 8, H SE 37970, I/A 74 (17.06.15).

Nombramientos. Apoderado: ESCRICHE MONSALVE CARLOS. Datos registrales. T 5548 , F 130, S 8, H SE 37970, I/A 75(18.06.15).

Nombramientos. Apoderado: HURTADO DUE脩AS FRANCISCO. Datos registrales. T 5548 , F 131, S 8, H SE 37970, I/A 76(18.06.15).

Nombramientos. Apoderado: PRIETO JANO ALBERTO. Datos registrales. T 5548 , F 131, S 8, H SE 37970, I/A 77 (18.06.15).

05 de Junio de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: MU脩OZ SANTANA ALVARO. Datos registrales. T 5548 , F 126, S 8, H SE 37970, I/A 71 (27.05.15).

Nombramientos. Apoderado: BURGOS CABALLERO ANA. Datos registrales. T 5548 , F 126, S 8, H SE 37970, I/A 72 (27.05.15).

Nombramientos. Apoderado: PANSARD MARTIN GONZALO. Datos registrales. T 5548 , F 127, S 8, H SE 37970, I/A 73(27.05.15).

17 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO. Datos registrales. T 5548 , F 124, S 8, H SE 37970,I/A 69 ( 1.09.14).

Nombramientos. Apoderado: PANSARD MARTIN GONZALO. Datos registrales. T 5548 , F 125, S 8, H SE 37970, I/A 70 ( 1.09.14).

10 de Septiembre de 2014
Revocaciones. Apoderado: MORALES CAMPRUBI CARLOS FRANCISCO. Datos registrales. T 5548 , F 123, S 8, H SE 37970, I/A67 ( 1.09.14).

Revocaciones. Apoderado: PANSARD MARTIN GONZALO. Apo.Sol.: PANSARD MARTIN GONZALO. Datos registrales. T 5548 ,F 124, S 8, H SE 37970, I/A 68 ( 1.09.14).

23 de Octubre de 2013
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5548 , F 123, S 8, H SE 37970, I/A 66 (16.10.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n