Actos BORME de Ayesa Administracion Y Gestion Sociedad Limitada
02 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MANZANARES ABASOLO JOSE LUIS;MANZANARES ABASOLO MARIA ARANZAZU. Cons.Del.Sol:MANZANARES ABASOLO JOSE LUIS. Presidente: MANZANARES ABASOLO MARIA ARANZAZU. Secretario: MANZANARESABASOLO JOSE LUIS. Cons.Del.Sol: MANZANARES ABASOLO MARIA ARANZAZU. Consejero: FERNANDEZ CANTILLANARAFAEL. Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL EDUARDO;FERNANDEZ CANTILLANA RAFAELEDUARDO;FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL EDUARDO;ORTEGA RODRIGUEZ DOMINGO;DEL REAL URBANO GERMAN.Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 5806 , F 146, S 8, H SE 83942, I/A 14 (21.12.17).
18 de Febrero de 2016Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ IZQUIERDO PABLO. Datos registrales. T 5806 , F 146, S 8, H SE 83942, I/A 13 (4.02.16).
07 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apoderado: DEL REAL URBANO GERMAN. Datos registrales. T 5806 , F 143, S 8, H SE 83942, I/A 12(29.10.14).
05 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: ORTEGA RODRIGUEZ DOMINGO. Datos registrales. T 5806 , F 142, S 8, H SE 83942, I/A 11(25.02.14).
28 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ IZQUIERDO PABLO. Datos registrales. T 5136 , F 154, S 8, H SE 83942, I/A 10(21.02.14).
07 de Enero de 2014Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL EDUARDO. Datos registrales. T 5136 , F 154, S 8, H SE83942, I/A 9 (26.12.13).
25 de Marzo de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 194,48 Euros. Resultante Suscrito: 29.063,58 Euros. Modificaciones estatutarias. 10.Transmisi贸n de Acciones/Participaciones.- Tambi茅n se elimina el Art铆culo 34潞 de los Estatutos Sociales.- .Art铆culo de los estatutos: 5.Capital.-. Datos registrales. T 5136 , F 152, S 8, H SE 83942, I/A 8 (13.03.13).
16 de Enero de 2013Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL EDUARDO. Datos registrales. T 5136 , F 149, S 8, H SE83942, I/A 7 ( 2.01.13).
28 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL EDUARDO. Datos registrales. T 5136 , F 146, S 8, H SE83942, I/A 6 (16.02.12).
03 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: FINARPISA SA. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL. Datosregistrales. T 5136 , F 146, S 8, H SE 83942, I/A 5 (24.01.12).
08 de Septiembre de 2011Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5136 , F 145, S 8, H SE 83942, I/A 4 (25.08.11).
24 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: MANZANARES JAPON JOSE LUIS. Secretario: GOMEZ LLEDO FRANCISCO. Cons.Del.Sol:
16 de Octubre de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 3.09.09. Objeto social: :1.- La gesti贸n, desarrollo, prestaci贸n y ejecuci贸n integral deservicios,obras y empresas, medios materiales y auxiliares, en bloque, unitarios o descompuestos con o sin organizaci贸n y encualquier grado de definici贸n, desarrollo o ejecuci贸n, a cualesquiera personas f铆sicas o jur铆dicas. Domicilio: C/ MARIE CURIE 2 - ISLADE LA CARTUJA -EDIFICIO A (SEVILLA). Capital: 29.258,06 Euros. Nombramientos. Consejero: MANZANARES JAPON JOSELUIS;GOMEZ LLEDO FRANCISCO;MANZANARES ABASOLO JOSE LUIS;MANZANARES ABASOLO MARIAARANZAZU;FINARPISA SA. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 1. Denominaci贸n.-. Datos registrales. T 5136 ,F 140, S 8, H SE 83942, I/A 1 ( 2.10.09).
Nombramientos. VsecrNoConsj: FERNANDEZ ROMERO FRANCISCO JOSE. Presidente: MANZANARES JAPON JOSE LUIS.Secretario: GOMEZ LLEDO FRANCISCO. Cons.Del.Sol: MANZANARES ABASOLO JOSE LUIS;GOMEZ LLEDO FRANCISCO. Datos