Actos BORME de Aynova Sociedad Anonima
23 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: ORTIZ-REPISO ROMERO MANUEL. Datos registrales. T 5979 , F 141, S 8, H SE 13399, I/A 84(13.10.23).
Nombramientos. Apoderado: TATO JIMENEZ GUILLERMO. Datos registrales. T 5979 , F 142, S 8, H SE 13399, I/A 85 (13.10.23).
Nombramientos. Apoderado: BORES BORRERO JOSE. Datos registrales. T 5979 , F 143, S 8, H SE 13399, I/A 86 (13.10.23).
14 de Septiembre de 2023Otros conceptos: DON NICOLAS RAUL COSTABILE ha renovado su pasaporte italiano, siendo el nuevo pasaporte el númeroYC1604685.- Datos registrales. T 5979 , F 141, S 8, H SE 13399, I/A 83 1 (25.08.23).
23 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apoderado: LOPEZ DIAZ CARLOS;MANZANARES ABASOLO JOSE LUIS. Apo.Sol.: CASTILLO CANO-CORTESLUIS. Apoderado: RODRIGUEZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: RODRIGUEZ GUTIERREZ FRANCISCOJAVIER;MANZANARES ABASOLO JOSE LUIS;REAL URBANO GERMAN. Apoderado: GIMENEZ MORCILLO VICTOR. Datosregistrales. T 5979 , F 141, S 8, H SE 13399, I/A 83 (15.12.21).
29 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: IGLESIAS ALONSO MERCEDES. Datos registrales. T 5979 , F 140, S 8, H SE 13399, I/A 82(22.10.21).
01 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: MUELA MORILLO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5979 , F 140, S 8, H SE 13399, I/A 81(23.11.20).
13 de Febrero de 2020Revocaciones. Apoderado: MINGUILLON CEBRIAN FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5979 , F 139, S 8, H SE 13399, I/A80 ( 6.02.20).
15 de Enero de 2020Modificaciones estatutarias. 29. Cierre del Ejercicio.-. 29. Cierre del Ejercicio.-. Otros conceptos: En la misma Junta se modificados veces el artículo 29º de los Estatutos Sociales.- Datos registrales. T 5979 , F 139, S 8, H SE 13399, I/A 79 ( 3.01.20).
19 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALIA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SOCIEDAD LIMITA. Nombramientos. Adm. Mancom.:FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL EDUARDO;DEL REAL URBANO GERMAN. Modificaciones estatutarias. Artículo 20º. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados. Datos registrales. T5979 , F 138, S 8, H SE 13399, I/A 78 (11.11.19).
19 de Septiembre de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5979 , F 138, S 8, H SE 13399, I/A 77 (11.09.19).
02 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apoderado: COSTABILE NICOLAS RAUL. Datos registrales. T 5979 , F 135, S 8, H SE 13399, I/A 76 (26.08.19).
24 de Julio de 2019Reelecciones. Adm. Unico: ALIA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 5979 , F 135, S 8,H SE 13399, I/A 75 (17.07.19).
05 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ MORCILLO VICTOR. Datos registrales. T 5979 , F 132, S 8, H SE 13399, I/A 74(29.05.19).
05 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5979 , F 132, S 8, H SE 13399, I/A 73 (25.10.18).
01 de Octubre de 2018Revocaciones. Apoderado: CHEHAB COUTYA EL EMIR NAGI CHEHAB COUTYA. Datos registrales. T 5979 , F 131, S 8, H SE13399, I/A 72 (21.09.18).
28 de Febrero de 2018Revocaciones. Apoderado: APARICIO SOTO GINES. Datos registrales. T 5979 , F 131, S 8, H SE 13399, I/A 71 (21.02.18).
24 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5979 , F 131, S 8, H SE 13399, I/A 70 (17.08.17).
02 de Enero de 2017Revocaciones. Apoderado: ORTEGA RODRIGUEZ DOMINGO;ORTEGA RODRIGUEZ DOMINGO. Nombramientos. Apoderado:ORTEGA RODRIGUEZ DOMINGO. Datos registrales. T 5979 , F 130, S 8, H SE 13399, I/A 69 (19.12.16).
22 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: DEL REAL URBANO GERMAN. Datos registrales. T 5979 , F 129, S 8, H SE 13399, I/A 68(12.12.16).
11 de Octubre de 2016Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5979 , F 129, S 8, H SE 13399, I/A 67 ( 3.10.16).
18 de Febrero de 2016Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ IZQUIERDO PABLO. Datos registrales. T 5979 , F 128, S 8, H SE 13399, I/A 66 (4.02.16).
20 de Enero de 2016Nombramientos. Apoderado: ORTEGA RODRIGUEZ DOMINGO. Datos registrales. T 5979 , F 128, S 8, H SE 13399, I/A 65(11.01.16).
24 de Septiembre de 2015Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5979 , F 128, S 8, H SE 13399, I/A 64 (14.09.15).
12 de Junio de 2015Revocaciones. Apoderado: SAURA DIAZ JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 5979 , F 128, S 8, H SE 13399, I/A 63 ( 5.06.15).
26 de Marzo de 2015Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: RODRIGUEZ GUTIERREZ FRANCISCOJAVIER;MANZANARES ABASOLO JOSE LUIS;REAL URBANO GERMAN. Datos registrales. T 5979 , F 126, S 8, H SE 13399, I/A62 (11.03.15).
03 de Marzo de 2015Nombramientos. Apoderado: DEL REAL URBANO GERMAN. Datos registrales. T 5510 , F 210, S 8, H SE 13399, I/A 61(18.02.15).
10 de Septiembre de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5510 , F 210, S 8, H SE 13399, I/A 60 (26.08.14).
28 de Agosto de 2014Reelecciones. Adm. Unico: ALIA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 5510 , F 210, S 8,H SE 13399, I/A 59 (19.08.14).
05 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: ORTEGA RODRIGUEZ DOMINGO. Datos registrales. T 5510 , F 209, S 8, H SE 13399, I/A 58(25.02.14).
28 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ IZQUIERDO PABLO. Datos registrales. T 5510 , F 208, S 8, H SE 13399, I/A 57(21.02.14).
05 de Febrero de 2014Revocaciones. Apoderado: PARDO DE VERA CRISTINA. Otros conceptos: REVOCADO el poder no inscrito en éste Registro, afavor de DOÑA CRISTINA PARDO DE VERA POSADA, otorgado ante el Notario Don Manuel García del Olmo y Santos, el día
Nombramientos. Apoderado: SAURA DIAZ JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 5510 , F 207, S 8, H SE 13399, I/A 56 (21.01.14).
23 de Octubre de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5510 , F 206, S 8, H SE 13399, I/A 54 (15.10.13).
02 de Agosto de 2013Revocaciones. Apoderado: BAENA ROMERO ELENA. Datos registrales. T 5510 , F 206, S 8, H SE 13399, I/A 53 (25.07.13).
01 de Agosto de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: CASTILLO CANO-CORTES LUIS. Datos registrales. T 5424 , F 147, S 8, H SE 13399, I/A 52 (19.07.13).
25 de Julio de 2013Revocaciones. Apoderado: MANZANARES JAPON JOSE LUIS. Otros conceptos: REVOCACION DE PODER NO INSCRITOconferido en Sevilla, ante el notario Don Manuel García Del Olmo y Santos, el día 31 de Julio de 1.998, bajo el número 2.506 deprotocolo, a favor de DOÑA ANA MARIA ABASOLO GALDOS.- Datos registrales. T 5424 , F 146, S 8, H SE 13399, I/A 49(17.07.13).
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ LLEDO FRANCISCO. Datos registrales. T 5424 , F 147, S 8, H SE 13399, I/A 50 (18.07.13).
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ ROMERO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 5424 , F 147, S 8, H SE 13399, I/A 51(18.07.13).
16 de Enero de 2013Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL EDUARDO. Datos registrales. T 5424 , F 144, S 8, H SE13399, I/A 48 (28.12.12).
17 de Octubre de 2012Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5424 , F 143, S 8, H SE 13399, I/A 47 ( 2.10.12).
18 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apoderado: PARDO DE VERA CRISTINA. Datos registrales. T 2716 , F 141, S 8, H SE 13399, I/A 46 ( 7.09.12).
10 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CANTILLANA RAFAEL EDUARDO. Datos registrales. T 2716 , F 83, S 8, H SE 13399,I/A 45 (21.10.11).
14 de Septiembre de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2716 , F 83, S 8, H SE 13399, I/A 44 ( 1.09.11).
21 de Junio de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ ESTELA JESUS;MERIDA CANDIL MACARENA. Datos registrales. T 2716 , F 82, S 8, HSE 13399, I/A 43 ( 6.06.11).
11 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: MANZANARES ABASOLO JOSE LUIS. Secretario: GOMEZ LLEDO FRANCISCO. Cons.Del.Sol:GOMEZ LLEDO FRANCISCO. Presidente: MANZANARES JAPON JOSE LUIS. Consejero: MANZANARES JAPON JOSELUIS;MANZANARES ABASOLO JOSE LUIS;MANZANARES ABASOLO MARIA ARANZAZU;GOMEZ LLEDO FRANCISCO.Nombramientos. Adm. Unico: ALIA GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS SOCIEDAD LIMITA. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. ; MODIFICA los artículos 3, 5, 7, 10, 12, 16,18, 19, 20, 23, y 30 de los Estatutos Sociales y suprime los artículos 21º, 22º, 24º, 25º, 26º, 27º y 28º de los Estatutos Sociales,quedando derogado su anterior texto y vacíos de contenido.-. Datos registrales. T 2716 , F 82, S 8, H SE 13399, I/A 42 (16.07.09).
03 de Febrero de 2009Revocaciones. Auditor: DAL AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2716 , F 81, S 8, HSE 13399, I/A 40 (20.01.09).
Nombramientos. VsecrNoConsj: FERNANDEZ ROMERO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 2716 , F 81, S 8, H SE 13399,I/A 41 (20.01.09).