Actos BORME de Azul Centros Residenciales Sa
01 de Marzo de 2021Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 38994 , F 23, S 8, H M 199165, I/A 131 (22.02.21).
24 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: NU脩EZ GRANADOS BLANCA. Datos registrales. T 38994 , F 22, S 8, H M 199165, I/A 130(17.02.21).
05 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 38994 , F 22, S 8, H M 199165,I/A 129 (29.07.20).
04 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 38994 , F 22, S 8, H M 199165, I/A 128 (28.07.20).
22 de Julio de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 38994 , F 21, S 8, H M 199165, I/A 127 (15.07.20).
04 de Febrero de 2020Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 38994 , F 21, S 8, H M 199165, I/A 126 (28.01.20).
13 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apoderado: PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 38994 , F 21, S 8, H M 199165, I/A 125 ( 6.11.19).
06 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MC COLLUM RAQUEL. Datos registrales. T 38994 , F 21, S 8, H M 199165, I/A 124(29.10.19).
11 de Octubre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL. Datos registrales. T 38994 , F 20, S 8, H M 199165, I/A 123 (4.10.19).
17 de Junio de 2019Revocaciones. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 38994 , F 20, S 8, H M 199165, I/A 122 (10.06.19).
30 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 18760 , F 225, S 8, H M 199165, I/A 121(23.04.19).
01 de Febrero de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 18760 , F 225, S 8, H M 199165, I/A 120 (25.01.19).
23 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 18760 , F 225, S 8, H M 199165, I/A 119 (13.07.18).
02 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ MARTIN ALVARO. Datos registrales. T 18760 , F 224, S 8, H M 199165, I/A 118(22.06.18).
30 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 18760 , F 222, S 8, H M 199165, I/A 114 (23.04.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: VAN-DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 18760 , F 223, S 8, H M 199165, I/A 115 (23.04.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 18760 , F 224, S 8, H M 199165, I/A 116 (23.04.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 18760 , F 224, S 8, H M 199165, I/A 117(23.04.18).
19 de Abril de 2018Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 7 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 18760 , F 222, S 8, H M199165, I/A 113 (11.04.18).
06 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 18760 , F 221, S 8, H M 199165, I/A112 (26.02.18).
13 de Febrero de 2018Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 18760 , F 221, S 8, H M 199165, I/A 111 ( 6.02.18).
06 de Febrero de 2018Revocaciones. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 18760 , F 221, S 8, H M 199165, I/A 110(30.01.18).
01 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 18760 , F 220, S 8, H M 199165, I/A 109 (24.01.18).
26 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL. Datos registrales. T 18760 , F 220, S 8, H M 199165, I/A 108(15.12.17).
18 de Diciembre de 2017Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-. Cambio de domicilio social. AVDAGENERAL PERON 36 4潞 A (MADRID). Datos registrales. T 18760 , F 220, S 8, H M 199165, I/A 107 ( 5.12.17).
13 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ ORDOVAS JAVIER. Datos registrales. T 18760 , F 220, S 8, H M 199165, I/A 106 ( 4.12.17).
10 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI;CALVO DIEGUEZ MONICA;SOLER VICENSANTONI;VELASCO JIMENEZ MARIA-ANTONIA. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI.Apo.Man.Soli: SOLER VICENS ANTONI. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI.Datos registrales. T 18760 , F 219, S 8, H M 199165, I/A 105 (31.10.17).
03 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 18760 , F 218, S 8, H M 199165, I/A 103 (26.09.17).
Nombramientos. Apoderado: RUBIO VALOR PABLO. Datos registrales. T 18760 , F 219, S 8, H M 199165, I/A 104 (26.09.17).
29 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 18760 , F 218, S 8, H M 199165, I/A 102(21.09.17).
26 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 18760 , F 214, S 8, H M 199165, I/A 100 (19.09.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN MARI脩O MARIA;DEL CAMPO REDONDO LUCIA;MELON CASTRO MARIA JOSE. Datosregistrales. T 18760 , F 218, S 8, H M 199165, I/A 101 (19.09.17).
28 de Abril de 2017Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 99 el nombramiento de QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SA comoconsejero siendo lo correcto administrador 煤nico. Datos registrales. T 18760 , F 213, S 8, H M 199165, I/A 99 (27.03.17).
04 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: QUAVITAE RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SL. Representan: CARRERAS JIMENEZ JULIAN.Nombramientos. Consejero: QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SA. Representan: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFAISABEL. Datos registrales. T 18760 , F 213, S 8, H M 199165, I/A 99 (27.03.17).
10 de Noviembre de 2016Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 18760 , F 213, S 8, H M 199165, I/A 98 (27.10.16).
14 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 18760 , F 213, S 8, H M 199165, I/A 97 ( 4.10.16).
13 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 18760 , F 211, S 8, H M 199165, I/A 95 ( 5.09.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 18760 , F 212, S 8, H M 199165, I/A 96 ( 5.09.16).
01 de Agosto de 2016Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ALONSO LUIS MANUEL. Datos registrales. T 18760 , F 211, S 8, H M 199165, I/A 94(21.07.16).
29 de Julio de 2016Nombramientos. Apoderado: RUBIO VALOR PABLO. Datos registrales. T 18760 , F 210, S 8, H M 199165, I/A 93 (20.07.16).
27 de Julio de 2016Nombramientos. Apoderado: CANO CRUZ SUSANA. Datos registrales. T 18760 , F 210, S 8, H M 199165, I/A 92 (15.07.16).
14 de Julio de 2016Reelecciones. Adm. Unico: QUAVITAE RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SL. Representan: CARRERAS JIMENEZ JULIAN. Datosregistrales. T 18760 , F 210, S 8, H M 199165, I/A 90 ( 7.07.16).
Revocaciones. Apoderado: TORRES DIEZ NUBIA LILIANA. Datos registrales. T 18760 , F 210, S 8, H M 199165, I/A 91 ( 7.07.16).
06 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 18760 , F 209, S 8, H M 199165, I/A 88 (27.04.16).
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 18760 , F 209, S 8, H M 199165, I/A 89 (27.04.16).
27 de Octubre de 2015Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 18760 , F 208, S 8, H M 199165, I/A 87 (16.10.15).
22 de Septiembre de 2015Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 18760 , F 208, S 8, H M 199165, I/A 86 (15.09.15).
20 de Abril de 2015Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 18760 , F 207, S 8, H M 199165, I/A 85 ( 9.04.15).
16 de Abril de 2015Revocaciones. Apoderado: RAVENTOS NEGRA HIGINIO;GUARNER MU脩OZ JORGE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SOLERVICENS ANTONI. Datos registrales. T 18760 , F 205, S 8, H M 199165, I/A 84 ( 7.04.15).
10 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Representan: GUARNER MU脩OZ JORGE. Nombramientos. Representan: CARRERAS JIMENEZ JULIAN.Datos registrales. T 18760 , F 205, S 8, H M 199165, I/A 83 ( 2.03.15).
02 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 18760 , F 204, S 8, H M 199165, I/A 82 (25.11.14).
16 de Octubre de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 18760 , F 204, S 8, H M 199165, I/A 81 ( 9.10.14).
09 de Octubre de 2014Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 18760 , F 204, S 8, H M 199165, I/A 80 ( 1.10.14).
05 de Mayo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 18760 , F 203, S 8, H M 199165, I/A 79 (23.04.14).
23 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL. Datos registrales. T 18760 , F 202, S 8, H M 199165, I/A 75 (7.05.12).
Nombramientos. Apoderado: PITEL MENDEZ MARIA-EUGENIA. Datos registrales. T 18760 , F 202, S 8, H M 199165, I/A 76 (7.05.12).
Nombramientos. Apoderado: VELASCO JIMENEZ MARIA-ANTONIA. Datos registrales. T 18760 , F 202, S 8, H M 199165, I/A 77 (7.05.12).
Revocaciones. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Nombramientos. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 18760 ,F 203, S 8, H M 199165, I/A 78 ( 7.05.12).
09 de Abril de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Apoderado: BELTRAN MENDEZ JESUS. Datosregistrales. T 18760 , F 201, S 8, H M 199165, I/A 74 (26.03.12).
04 de Abril de 2012Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 18760 , F 200, S 8, H M 199165, I/A 71(26.03.12).
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 18760 , F 201, S 8, H M 199165, I/A 72 (26.03.12).
Revocaciones. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN;GAYOSO PARDO JOSE LUIS. Datos registrales. T 18760 , F 201, S 8, HM 199165, I/A 73 (26.03.12).
07 de Febrero de 2012Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 18760 , F 200, S 8, H M 199165, I/A 70 (27.01.12).
03 de Febrero de 2012Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 52 5& (MADRID). Datos registrales. T 18760 , F 200, S 8, H M 199165,I/A 69 (20.01.12).
23 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN;GAYOSO PARDO JOSE LUIS. Datos registrales. T 18760 , F 199, S 8, HM 199165, I/A 68 (11.11.11).
22 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ VILLA JESUS MANUEL. Apoderado: FERNANDEZ BUITRON BEGO脩A. Datos registrales. T18760 , F 199, S 8, H M 199165, I/A 66 (10.11.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 18760 , F 199, S 8, H M 199165, I/A 67 (10.11.11).
26 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPESINO SOUSA AGUSTIN;LOPEZ RUIZ ROBERTO. Presidente: LOPEZ RUIZ ROBERTO.Consejero: CID SANCHEZ ENRIQUE. Secretario: JOSE LUIS CARASA RODRIGUEZ. Nombramientos. Adm. Unico: QUAVITAERESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SL. Representan: GUARNER MU脩OZ JORGE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organode Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. 8. Administraci贸n y Representacion.-. 15. Administraci贸n yRepresentacion.-. 17. Administraci贸n y Representacion.-.19. Administraci贸n y Representacion.-. 20. Administraci贸n y Representacion.-.
Nombramientos. Apoderado: RAVENTOS NEGRA HIGINIO;GUARNER MU脩OZ JORGE;SOLER VICENS ANTONI;LOPESINOSOUSA AGUSTIN;JIMENEZ CALAVIA JAVIER;CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 18760 , F 197, S 8, H M 199165, I/A63 (14.09.11).
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 18760 , F 198, S 8, H M 199165, I/A 64 (14.09.11).
Nombramientos. Apoderado: BRAVO ARAGON PEDRO. Datos registrales. T 18760 , F 198, S 8, H M 199165, I/A 65 (14.09.11).
15 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 18760 , F 158, S 8, HM 199165, I/A 57 (29.08.11).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ORDOVAS JAVIER. Datos registrales. T 18760 , F 159, S 8, H M 199165, I/A 58(29.08.11).
Nombramientos. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 18760 , F 159, S 8, H M 199165, I/A 59(29.08.11).
Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 18760 , F 195, S 8, H M 199165, I/A 60(29.08.11).
Nombramientos. Apoderado: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER. Datos registrales. T 18760 , F 195, S 8, H M 199165, I/A 61(29.08.11).
13 de Septiembre de 2011Revocaciones. Apoderado: CARASA RODRIGUEZ JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: PANCORBO AGUILERA FERNANDO. Apoderado:LOPEZ RUIZ ROBERTO. Nombramientos. Apoderado: TORRES DIEZ NUBIA LILIANA. Datos registrales. T 18760 , F 157, S 8, HM 199165, I/A 56 (26.08.11).
26 de Mayo de 2011Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MAPFRE QUAVITAE SA. Datos registrales. T 18760 , F 157, S 8, H M 199165, I/A55 (13.05.11).
09 de Mayo de 2011Reelecciones. Consejero: CID SANCHEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 18760 , F 154, S 8, H M 199165, I/A 53 (26.04.11).
Nombramientos. Apoderado: BELTRAN MENDEZ JESUS. Datos registrales. T 18760 , F 154, S 8, H M 199165, I/A 54 (26.04.11).
09 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: OLMEDILLA HERRERO ANA. Revocaciones. Apo.Man.Soli: OLMEDILLA HERREROANA;CAMPOS DOMPEDRO JOSE RAMON. Datos registrales. T 18760 , F 154, S 8, H M 199165, I/A 52 (25.02.11).
07 de Octubre de 2010Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 18760 , F 154, S 8, H M 199165, I/A 51 (27.09.10).
14 de Junio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ BASCONES JOSE LUIS. Vicepresid.: SANCHEZ BASCONES JOSE LUIS. Presidente:SANCHEZ BASCONES JOSE LUIS. Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ BASCONES JOSE LUIS. Nombramientos.Consejero: LOPEZ RUIZ ROBERTO;OLMEDILLA HERRERO ANA. Presidente: LOPEZ RUIZ ROBERTO. Apoderado: LOPEZ RUIZROBERTO. Datos registrales. T 18760 , F 153, S 8, H M 199165, I/A 50 ( 1.06.10).
27 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 18760 , F 153, S 8, H M 199165, I/A 49 (17.11.09).
09 de Octubre de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 701.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:70.000,00 Euros. Desembolsado: 70.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 70.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 70.000,00 Euros.Datos registrales. T 18760 , F 153, S 8, H M 199165, I/A 48 (29.09.09).
16 de Julio de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ BASCONES JOSE LUIS;OLMEDILLA HERRERO ANA;LOPESINO SOUSA AGUSTINMODESTO;PANCORBO AGUILERA FERNANDO;CAMPOS DOMPEDRO JOSE RAMON. Datos registrales. T 18760 , F 151, S 8, HM 199165, I/A 46 ( 6.07.09).
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Cons.Del.Man: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Cons.Del.Sol:SANCHEZ BASCONES JOSE LUIS;CID SANCHEZ ENRIQUE. Cons.Del.Man: SANCHEZ BASCONES JOSE LUIS;CID SANCHEZENRIQUE;OLMEDILLA HERRERO ANA. Revocaciones. Apoderado: SAN MARTIN GUTIERREZ LUCIA;ARMENGOD DE RODAI脩IGO. Datos registrales. T 18760 , F 152, S 8, H M 199165, I/A 47 ( 6.07.09).
01 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: JOSE LUIS CARASA RODRIGUEZ. Cons.Del.Man: MONTORO ZULUETA MARIA;MONTOROZULUETA ANA;MONTORO ZULUETA SANTOS. Cons.Del.Sol: MONTORO ZULUETA MARIA;MONTORO ZULUETAANA;MONTORO ZULUETA SANTOS. Consejero: MONTORO ZULUETA MARIA;MONTORO ZULUETA ANA;MONTORO ZULUETASANTOS. Co.De.Ma.So: MONTORO ZULUETA ANA. Consejero: ANCHUSTEGUI MELGAREJO MIGUEL. Secretario: MONTOROZULUETA MARIA. Nombramientos. SecreNoConsj: JOSE LUIS CARASA RODRIGUEZ. Datos registrales. T 18760 , F 151, S 8, HM 199165, I/A 45 (22.06.09).