Actos BORME de B. Braun Avitum Galicia Sl
17 de Diciembre de 2015Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 469 , F 136, S 8, H LU 4895,1 , I/ 51 .( 4.12.15).
26 de Mayo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: PUERTO MANOVEL IVAN. Datos registrales. T 469 , F 136, S 8, H LU 4895,1 , I/ 50 .(18.05.15).
27 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apoderado: MIRA MARTIN DANIEL. Datos registrales. T 469 , F 135, S 8, H LU 4895,1 , I/ 49 .(21.11.14).
15 de Octubre de 2014Fe de erratas: RECTIFICADA LA INSCRIPCION 45潞 en el sentido, de que por error en la escritura que motiv贸 dicho Asiento, se hizoconstar un D.N.I./N.I.F .err贸neo del apoderado nombrado, don Christian Navarro Obiols, siendo el n煤mero correcto el siguiente:46.132.922M. Datos registrales. T 469 , F 135, S 8, H LU 4895,1 , I/ 48 .( 7.10.14).
27 de Agosto de 2014Revocaciones. Apoderado: ANTONIO GARAY BAETA. Apo.Man.Soli: JOSE IGNACIO RODRIGUEZ SOLER;MORILLA ORTEGAMARIANO;JOSE IGNACIO RODRIGUEZ SOLER Datos registrales. T 400 , F 152, S 8, H LU 4895,1 , I/ 46 .(20.08.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE IGNACIO RODRIGUEZ SOLER. Nombramientos. Consejero: AGUIRRE CASTELLTORTROSA. Datos registrales. T 400 , F 152, S 8, H LU 4895,1 , I/ 47 .(20.08.14).
07 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: MATIAS VEGA VERONICA. Datos registrales. T 400 , F 151, S 8, H LU 4895,1 , I/ 43 .(24.06.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: NIETO ROMERO JOSE LUIS. Datos registrales. T 400 , F 151, S 8, H LU 4895,1 , I/ 44 .(24.06.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: NAVARRO OBIOLS CHRISTIAN. Datos registrales. T 400 , F 151, S 8, H LU 4895,1 , I/ 45 .(24.06.14).
12 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: DONADO-MAZARRON MARTINEZ JESUS;JOSE IGNACIO RODRIGUEZ SOLER;AGUIRRECASTELLTORT ROSA;JODAR MASANES ANTONIO;JOSE BELLES BULTA;PALAO RUIZ SERGIO;RAMOS SANROMAN JOSELUIS. Datos registrales. T 400 , F 150, S 8, H LU 4895,1 , I/ 42 .(29.11.13).
14 de Enero de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: RAMOS SANROMAN JOSE LUIS. Datos registrales. T 400 , F 149, S 8, H LU 4895,1 , I/ 40.(31.12.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORILLA ORTEGA MARIANO. Datos registrales. T 400 , F 150, S 8, H LU 4895,1 , I/ 41.(31.12.12).
05 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: SUBIRA HIDALGO JOSE. Datos registrales. T 400 , F 148, S 8, H LU 4895,1 , I/ 38 .(18.02.12).
Revocaciones. Apoderado: WERNER HERBERT HOTHUM. Datos registrales. T 400 , F 149, S 8, H LU 4895,1 , I/ 39 .(18.02.12).
26 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: HERMANN FELLER WOLFGANG ROBERT. Presidente: HERMANN FELLER WOLFGANG ROBERT.Secretario: MANUEL JIMENEZ MU脩OZ. Nombramientos. Consejero: DONADO-MAZARRON MARTINEZ JESUS. Presidente:MANUEL JIMENEZ MU脩OZ. Secretario: DONADO-MAZARRON MARTINEZ JESUS. Con.Delegado: MANUEL JIMENEZ MU脩OZ.Datos registrales. T 400 , F 147, S 8, H LU 4895,1 , I/ 36 .(13.09.11).
Nombramientos. Apoderado: JODAR MASANES ANTONIO. Apo.Manc.: AGUIRRE CASTELLTORT ROSA;JOSE IGNACIORODRIGUEZ SOLER;DONADO-MAZARRON MARTINEZ JESUS;MANUEL JIMENEZ MU脩OZ. Datos registrales. T 400 , F 148, S 8,H LU 4895,1 , I/ 37 .(13.09.11).
06 de Septiembre de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: ROSA MARIA JIMENO CALVO. Datos registrales. T 400 , F 147, S 8, H LU 4895,1 , I/ 34 .(19.08.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ GASCON JULIA. Datos registrales. T 400 , F 147, S 8, H LU 4895,1 , I/ 35 .(19.08.10).
05 de Noviembre de 2009Cambio de domicilio social. C/ VIRXE DA ESPERANZA 15 19 (LUGO). Datos registrales. T 400 , F 146, S 8, H LU 4895,1 , I/ 33.(23.10.09).
12 de Febrero de 2009Revocaciones. Apoderado: JOSE IGNACIO RODRIGUEZ SOLER;JOSE BELLES BULTA. Apo.Man.Soli: MANUEL JIMENEZMU脩OZ;DONADO-MAZARRON MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 400 , F 146, S 8, H LU 4895,1 , I/ 32 .(28.01.09).