Actos BORME de Balcon De Europa Sa
31 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: BARRANCO MARTINEZ MANUEL. Datos registrales. T 4135, L 3046, F 30, S 8, H MA 86697, I/A 20(17.03.22).
10 de Marzo de 2021Nombramientos. Auditor: PLANCONTROL AUDITORES Y CONSULTORES SAP. Datos registrales. T 4135, L 3046, F 30, S 8, HMA 86697, I/A 19 (25.02.21).
26 de Junio de 2020Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MONCLUS FRAGA JUAN CARLOS. Consejero: COLAS MARTINEZ ANA MARIA. Presidente:COLAS MARTINEZ ANA MARIA. Consejero: COLAS PEREZ DIEGO;COLAS PEREZ MIGUEL;COLAS PEREZ ANA. Con.Delegado:COLAS MARTINEZ ANA MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: COLAS MARTINEZ ANA MARIA. Modificaciones estatutarias.Modos de organizaci贸n de la administraci贸n. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 4135, L 3046, F 29, S 8, H MA 86697, I/A 18 (18.06.20).
26 de Julio de 2019Reelecciones. Consejero: COLAS MARTINEZ ANA MARIA. Presidente: COLAS MARTINEZ ANA MARIA. Consejero: COLAS PEREZDIEGO;COLAS PEREZ MIGUEL;COLAS PEREZ ANA. Con.Delegado: COLAS MARTINEZ ANA MARIA. SecreNoConsj: MONCLUSFRAGA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4135, L 3046, F 29, S 8, H MA 86697, I/A 17 (18.07.19).
02 de Febrero de 2018Nombramientos. Auditor: PLANCONTROL AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 4135, L 3046, F 29, S 8, H MA86697, I/A 16 (25.01.18).
20 de Agosto de 2015Nombramientos. Auditor: PLANCONTROL AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 4135, L 3046, F 28, S 8, H MA86697, I/A 15 (12.08.15).
11 de Junio de 2015Nombramientos. Con.Delegado: COLAS MARTINEZ ANA MARIA. Datos registrales. T 4135, L 3046, F 28, S 8, H MA 86697, I/A 13(29.05.15).
Nombramientos. Apoderado: COLAS PEREZ MIGUEL. Datos registrales. T 4135, L 3046, F 28, S 8, H MA 86697, I/A 14(29.05.15).
09 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MENA ARAZOLA ANDRES;COLAS PEREZ ANA MARIA DEL PILAR. Vicepresid.: COLAS PEREZANA MARIA DEL PILAR. Con.Delegado: COLAS MARTINEZ ANA MARIA. Nombramientos. Vicepresid.: COLAS PEREZ ANA.Reelecciones. SecreNoConsj: MONCLUS FRAGA JUAN CARLOS. Consejero: COLAS MARTINEZ ANA MARIA. Presidente: COLASMARTINEZ ANA MARIA. Consejero: COLAS PEREZ DIEGO;COLAS PEREZ MIGUEL;COLAS PEREZ ANA. Datos registrales. T4135, L 3046, F 28, S 8, H MA 86697, I/A 12 (26.02.15).
06 de Febrero de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 444.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 933.400,00 Euros. Otros conceptos: Renumerarlas acciones, que pasan a ser de la n煤mero 1 a la 71.800, todas inclusives. Datos registrales. T 4135, L 3046, F 27, S 8, H MA86697, I/A 11 (28.01.14).
30 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ PRIETO JAVIER LOPEZ. Datos registrales. T 4135, L 3046, F 27, S 8, H MA 86697, I/A 10(22.10.13).
26 de Julio de 2013Revocaciones. Apoderado: MENA ARAZOLA ANDRES;MENA ARAZOLA ANDRES. Datos registrales. T 4135, L 3046, F 27, S 8, HMA 86697, I/A 9 (17.07.13).
10 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MENA ARAZOLA ANDRES;COLAS MARTINEZ ANA MARIA;COLAS PEREZ ANA MARIA DELPILAR;COLAS PEREZ DIEGO. Vicesecret.: COLAS PEREZ ANA MARIA DEL PILAR. Con.Delegado: COLAS MARTINEZ ANAMARIA. Presidente: COLAS MARTINEZ ANA MARIA. Vicepresid.: COLAS PEREZ ANA MARIA DEL PILAR. SecreNoConsj:MONCLUS FRAGA JUAN CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: MONCLUS FRAGA JUAN CARLOS. Consejero: COLASMARTINEZ ANA MARIA. Presidente: COLAS MARTINEZ ANA MARIA. Con.Delegado: COLAS MARTINEZ ANA MARIA. Consejero:COLAS PEREZ ANA MARIA DEL PILAR. Vicepresid.: COLAS PEREZ ANA MARIA DEL PILAR. Consejero: MENA ARAZOLAANDRES;COLAS PEREZ DIEGO;COLAS PEREZ MIGUEL. Datos registrales. T 4135, L 3046, F 26, S 8, H MA 86697, I/A 8(21.01.10).
23 de Enero de 2009Nombramientos. Auditor: PLANCONTROL AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 4135, L 3046, F 26, S 8, H MA86697, I/A 7 (12.01.09).