Buscador CIF Logo

Actos BORME Bankinter Consultoria Asesoramiento Y Atencion Telefonica Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Bankinter Consultoria Asesoramiento Y Atencion Telefonica Sa

Actos BORME Bankinter Consultoria Asesoramiento Y Atencion Telefonica Sa - A78757143

Tenemos registrados 43 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Bankinter Consultoria Asesoramiento Y Atencion Telefonica Sa con CIF A78757143

🔙 Perfil de Bankinter Consultoria Asesoramiento Y Atencion Telefonica Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Bankinter Consultoria Asesoramiento Y Atencion Telefonica Sa

28 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apoderado: MELERO BERMEJO NATALIA LUCIA. Datos registrales. T 15599 , F 217, S 8, H M 64434, I/A 113(21.10.22).

27 de Octubre de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 15599 , F 217, S 8, H M 64434, I/A112 (20.10.22).

09 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PEREZ ROLDAN MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: RODRIGUEZ CAMARA ISABEL. Datosregistrales. T 15599 , F 217, S 8, H M 64434, I/A 111 (29.04.22).

20 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 15599 , F 216, S 8, H M 64434, I/A110 (13.12.21).

13 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LEJO TURIEL CARLOS. Datos registrales. T 15599 , F 216, S 8, H M 64434, I/A 109 ( 6.05.21).

06 de Abril de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SHEPARD GOODREE LAURIE;REVIRIEGO AGUDO LUIS. Datos registrales. T 15599 , F 215, S8, H M 64434, I/A 107 (27.03.21).

Revocaciones. Apo.Manc.: ALEJO SERRANO JESUS. Apo.Man.Soli: SAEZ ALONSO MUÑUMER ALFONSO MARIA. Apoderado:MARTINEZ GARCIA FRANCISCO;MATIACCI CALERO MIGUEL ANGEL;TAPIA RAMIRO MARCELO JESUS;GARCIA PASTORRAQUEL. Apo.Man.Soli: SAGIVELA LOPEZ SUSANA. Datos registrales. T 15599 , F 215, S 8, H M 64434, I/A 108 (27.03.21).

30 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: CARAMES AGUDO MARIA DEL PILAR;BRIME MENENDEZ PELAYO. Datos registrales. T 15599 , F214, S 8, H M 64434, I/A 106 (23.11.20).

06 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 15599 , F 214, S 8, H M 64434, I/A105 (29.10.20).

16 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 15599 , F 214, S 8, H M 64434, I/A104 ( 5.12.19).

03 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ROSAS RODRIGO JUAN-BAUTISTA. Nombramientos. Adm. Unico: PEREZ ROLDAN MARIA.Datos registrales. T 15599 , F 213, S 8, H M 64434, I/A 103 (26.11.19).

26 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apoderado: PRESA AGUERO CARMEN. Datos registrales. T 15599 , F 213, S 8, H M 64434, I/A 102 (19.05.17).

12 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAGIVELA LOPEZ SUSANA. Datos registrales. T 15599 , F 212, S 8, H M 64434, I/A 100 (5.05.17).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ CAMARA ISABEL. Datos registrales. T 15599 , F 212, S 8, H M 64434, I/A 101 (5.05.17).

14 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ PEREDA CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: ROSAS RODRIGO JUAN-BAUTISTA. Datos registrales. T 15599 , F 212, S 8, H M 64434, I/A 99 ( 6.02.17).

20 de Octubre de 2016
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 15599 , F 211, S 8, H M 64434,I/A 98 (10.10.16).

03 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOZANO EGEA IGNACIO. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ PEREDA CARLOS. Datosregistrales. T 15599 , F 210, S 8, H M 64434, I/A 96 (19.02.16).

Nombramientos. Apoderado: PEÑA AZPILICUETA DOMINGO;ORTEGA SALAZAR JESUS. Datos registrales. T 15599 , F 211, S8, H M 64434, I/A 97 (19.02.16).

30 de Noviembre de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 15599 , F 210, S 8, H M 64434, I/A 95 (20.11.15).

28 de Abril de 2015
Revocaciones. Apoderado: MATEU DE ROS CEREZO RAFAEL;GUERRA AZCONA IÑIGO;LOPEZ-MONIS GALLEGOMONICA;HERNANDEZ GARCIA RAFAEL. Datos registrales. T 15599 , F 209, S 8, H M 64434, I/A 92 (20.04.15).

Nombramientos. Apoderado: TAPIA RAMIRO MARCELO JESUS. Datos registrales. T 15599 , F 209, S 8, H M 64434, I/A 93(20.04.15).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA PASTOR RAQUEL. Datos registrales. T 15599 , F 210, S 8, H M 64434, I/A 94 (20.04.15).

18 de Diciembre de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 15599 , F 208, S 8, H M 64434, I/A 87 (11.12.14).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ-MONIS GALLEGO MONICA. Datos registrales. T 15599 , F 208, S 8, H M 64434, I/A 88(11.12.14).

Nombramientos. Apoderado: MATIACCI CALERO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 15599 , F 208, S 8, H M 64434, I/A 89(11.12.14).

Revocaciones. Apo.Sol.: GUERRA AZCONA IÑIGO. Datos registrales. T 15599 , F 209, S 8, H M 64434, I/A 90 (11.12.14).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ UGARTE CARLOS. Datos registrales. T 15599 , F 209, S 8, H M 64434, I/A 91(11.12.14).

14 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 15599 , F 208, S 8, H M 64434, I/A 86 ( 6.11.13).

13 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: MANCEBO ALONSO ENRIQUE JESUS. Datos registrales. T 15599 , F 207, S 8, H M 64434, I/A 85 (6.11.13).

31 de Octubre de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 15599 , F 207, S 8, H M 64434, I/A 84 (22.10.12).

12 de Junio de 2012
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA FRANCISCO. Datos registrales. T 15599 , F 207, S 8, H M 64434, I/A 83(31.05.12).

28 de Julio de 2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAEZ ALONSO MUÑUMER ALFONSO MARIA. Datos registrales. T 15599 , F 204, S 8, H M64434, I/A 78 (15.07.11).

Nombramientos. Apoderado: HERRERO ESCANDON EDUARDO JOSE. Datos registrales. T 15599 , F 205, S 8, H M 64434, I/A79 (15.07.11).

Nombramientos. Apoderado: PARAMES GARCIA-ASTIGARRAGA MARIA. Datos registrales. T 15599 , F 205, S 8, H M 64434, I/A80 (15.07.11).

Revocaciones. Apoderado: EGEA MARCOS RICARDO LUIS;EGEA MARCOS RICARDO LUIS;ALFARO LLOVERA ALFONSO;DIAZGARCIA JACOBO. Apo.Sol.: RODRIGUEZ ARROJO RITA MARIA. Apoderado: MARTIN-PEÑASCO CIUDAD ANSELMO. Apo.Sol.:MARTIN CASADO JAVIER. Apoderado: REY TOBALINA MONICA. Apo.Sol.: CORRAL HERRANZ CARMEN. Apoderado: MARTIN-PEÑASCO CIUDAD ANSELMO. Datos registrales. T 15599 , F 206, S 8, H M 64434, I/A 81 (15.07.11).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 15599 , F 206, S 8, H M 64434, I/A 82 (15.07.11).

07 de Abril de 2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ UGARTE CARLOS. Apo.Manc.: SAINZ DOMINGUEZ MONICA;PASAMONTES DIAZANGEL;OSMA CANTERO JOSE ANDRES;ALEJO SERRANO JESUS;CARMONA ALONSO ALBERTO. Datos registrales. T 15599 ,F 204, S 8, H M 64434, I/A 77 (25.03.11).

25 de Marzo de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: PELAEZ GARCIA ISABEL. Nombramientos. Apoderado: MIRON GOMEZ AMELIA MARIA. Datosregistrales. T 15599 , F 203, S 8, H M 64434, I/A 76 (15.03.11).

17 de Febrero de 2011
Revocaciones. Apoderado: HERRERA ARMAS MAURO-MIGUEL. Nombramientos. Apoderado: MARTIN-PEÑASCO CIUDADANSELMO. Datos registrales. T 15599 , F 202, S 8, H M 64434, I/A 74 ( 8.02.11).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTIN CASADO JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: LOZANO EGEA IGNACIO. Datosregistrales. T 15599 , F 203, S 8, H M 64434, I/A 75 ( 8.02.11).

03 de Noviembre de 2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 15599 , F 202, S 8, H M 64434, I/A 73 (22.10.10).

08 de Enero de 2010
Revocaciones. Apoderado: DIAZ DE CERIO VILLAMAYOR JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Sol.: PELAEZ GARCIAISABEL;CORRAL HERRANZ CARMEN. Datos registrales. T 15599 , F 201, S 8, H M 64434, I/A 72 (24.12.09).

20 de Julio de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 15599 , F 201, S 8, H M 64434, I/A 71 ( 8.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información