Actos BORME de Barbatun Sl
31 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: CRESPO PINTO JUAN MANUEL. Presidente: CRESPO PINTO JUAN MANUEL. Nombramientos.Presidente: CRESPO PEREZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 2139 , F 4, S 8, H CA 43510, I/A 6 (24.03.21).
18 de Agosto de 2020Reelecciones. Consejero: CRESPO PEREZ ANTONIO;CRESPO PEREZ PABLO JAIME;CRESPO PEREZ JUAN MANUEL;CRESPOPINTO JUAN MANUEL;CRESPO PEREZ ALBERTO. Presidente: CRESPO PINTO JUAN MANUEL. Secretario: CRESPO PEREZPABLO JAIME. Con.Delegado: CRESPO PEREZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 2139 , F 4, S 8, H CA 43510, I/A 5 ( 3.08.20).
21 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: CRESPO PINTO JUAN MANUEL;CRESPO PEREZ PABLO JAIME;CRESPO PEREZ JUANMANUEL;CRESPO PEREZ ALBERTO;CRESPO PEREZ ANTONIO. Presidente: CRESPO PEREZ ANTONIO. Secretario: CRESPOPEREZ PABLO JAIME. Cons.Del.Sol: CRESPO PEREZ JUAN MANUEL;CRESPO PEREZ ALBERTO. Nombramientos. Consejero:CRESPO PEREZ ANTONIO;CRESPO PEREZ PABLO JAIME;CRESPO PEREZ JUAN MANUEL;CRESPO PINTO JUANMANUEL;CRESPO PEREZ ALBERTO. Presidente: CRESPO PINTO JUAN MANUEL. Secretario: CRESPO PEREZ PABLO JAIME.Con.Delegado: CRESPO PEREZ JUAN MANUEL. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.265.365,00 Euros. Resultante Suscrito:2.548.425,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Articulo 10. resumen. Cambio de objeto social. La sociedad tiene por objetosocial: La actuaci贸n como sociedad holding mediante la participaci贸n en el capital de entidades residentes y no residentes en elterritorio espa帽ol, dirigiendo y gestionando dichas participaciones, as铆 como la prestaci贸n de servicios a las sociedades participadas,consi. Datos registrales. T 2139 , F 2, S 8, H CA 43510, I/A 4 (11.12.15).
16 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CRESPO PEREZ ANTONIO. Nombramientos. Consejero: CRESPO PINTO JUANMANUEL;CRESPO PEREZ PABLO JAIME;CRESPO PEREZ JUAN MANUEL;CRESPO PEREZ ALBERTO;CRESPO PEREZANTONIO. Presidente: CRESPO PEREZ ANTONIO. Secretario: CRESPO PEREZ PABLO JAIME. Cons.Del.Sol: CRESPO PEREZJUAN MANUEL;CRESPO PEREZ ALBERTO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador煤nico a Consejo de administraci贸n. Cambio de domicilio social. C/ CONSORCIO 6 2 B (BARBATE). Datos registrales. T 2051 , F211, S 8, H CA 43510, I/A 3 ( 5.12.14).
19 de Julio de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: CRESPO PEREZ PABLO JAIME;CRESPO PINTO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 2051 , F 210, S8, H CA 43510, I/A 2 ( 9.07.12).
22 de Junio de 2012Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 17.04.12. Objeto social: La actividad de explotaci贸n de t煤nidos y otros recursos pesqueros;la de piscifactor铆a y acuicultura en general. Domicilio: PAGO DE LA MUELA, CHALET GARIPOLO (VEJER DE LA FRONTERA).Capital: 1.283.060,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: CRESPO PEREZ ANTONIO. Datos registrales. T 2051 , F 208, S 8, HCA 43510, I/A 1 (11.06.12).