Buscador CIF Logo

Actos BORME Basic Fit Spain Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Basic Fit Spain Sa

Actos BORME Basic Fit Spain Sa - A82553447

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Basic Fit Spain Sa con CIF A82553447

馃敊 Perfil de Basic Fit Spain Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Basic Fit Spain Sa

23 de Mayo de 2023
Cambio de domicilio social. C/ HORACIO QUIROGA 35 (MALAGA). Datos registrales. T 6336, L 5244, F 35, S 8, H MA174283, I/A2 (15.05.23).

21 de Abril de 2023
Revocaciones. Apoderado: BALFOUR MICHAEL WILLIAM;CHILD COLIN CHARLES;CARTWRIGHT NIGEL RONALD;FOLDVARYVALERIE;METCALF MICHAEL EDWARD;GOCKEL HENRIK;KEESS RALF;ARGUELLES MORON MIGUEL;FOLDVARY VALERIE.Apo.Sol.: FRAGOSO LUENGO FRANCISCO JOSE;ROTELLA AGUADO ANA OLGA;VELASCO BAUTISTA JOSE LUIS;MARTINEZGARCIA MANUEL. Apo.Manc.: ECHANIZ PINO LLERKO;GARCIA LOPEZ MARIA FRANCISCA. Apoderado: MOOS RENEMICHEL;VAN DER ARR HENDRIK JOHANNES;ECHANIZ PINO LLERKO;PEREZ MARCITLLACH PALOMA;MARTINEZ PEREZALEJANDRO;PEREZ RIOJA AGUSTINA;SOBRADOS RIVERO DIEGO;MOOS RENE MICHEL;VAN DER ARR HENDRIKJOHANNES;ZEKKRI REDOUANE;YOUNG CONRAD CLAUDE;PEREZ MARCITLLACH PALOMA;MARTINEZ GARCIAMANUEL;GARCIA LOPEZ MARIA FRANCISCA;VAN LEEUWEN MARLOES ALIDE. Nombramientos. Apo.Sol.: MOOS RENEMICHEL;VAN DER AAR HENDRICK JOHANNES;ZEKKRI REDOUANE. Apo.Man.Soli: YOUNG CONRAD CLAUDE;TAYLORSEBASTIEN RAQUIL J.;PEREZ MARCITLLACH PALOMA;MARTINEZ GARCIA MANUEL;GARCIA LOPEZ MARIA FRANCISCA;VANLEEUWEN MARLOES ALIDE;MOYA IZQUIERDO SARA. Ampliacion del objeto social. Estudio ,promoci贸n realizaci贸n ,coordinaci贸n y supervisi贸n de toda clase de obras de construcci贸n , mejora y conservaci贸n. Datos registrales. T 31086 , F 111, S 8,H M 256187, I/A 59 (14.04.23).

23 de Septiembre de 2022
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31086 , F 110, S 8, H M 256187, I/A 58 (16.09.22).

15 de Febrero de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MAIZ CARRO SANTIAGO. Nombramientos. SecreNoConsj: MOYA IZQUIERDO SARA.Apoderado: MOOS RENE MICHEL;VAN DER ARR HENDRIK JOHANNES;ZEKKRI REDOUANE;YOUNG CONRAD CLAUDE;PEREZMARCITLLACH PALOMA;MARTINEZ GARCIA MANUEL;GARCIA LOPEZ MARIA FRANCISCA;VAN LEEUWEN MARLOES ALIDE.Datos registrales. T 31086 , F 109, S 8, H M 256187, I/A 56 ( 8.02.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: WILLEMSE JOHANNES CORNELIS MARIA. Nombramientos. Consejero: ZEKKRI REDOUANE.Datos registrales. T 31086 , F 110, S 8, H M 256187, I/A 57 ( 8.02.22).

02 de Diciembre de 2021
Modificaciones estatutarias. 24. Retribuci贸n. Datos registrales. T 31086 , F 109, S 8, H M 256187, I/A 55 (25.11.21).

27 de Agosto de 2021
Nombramientos. Con.Delegado: MOOS RENE MICHEL. Datos registrales. T 31086 , F 108, S 8, H M 256187, I/A 54 (20.08.21).

27 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: MOOS RENE MICHEL;VAN DER AAR HENDRICK JOHANNES;WILLEMSE JOHANNES CORNELISMARIA.Presidente: MOOS RENE MICHEL. Nombramientos. Consejero: MOOS RENE MICHEL;VAN DER AAR HENDRIKJOHANNES;WILLEMSE JOHANNES CORNELIS MARIA. Presidente: MOOS RENE MICHEL. Datos registrales. T 31086 , F 108, S8, H M 256187, I/A 53 (20.11.19).

16 de Abril de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: MOOS RENE MICHEL;VAN DER AAR HENDRIK JOHANNES. Apo.Manc.: FRAGOSO LUENGOFRANCISCO JOSE;MARTINEZ GARCIA MANUEL;ECHANIZ PINO LLERKO;SOBRADOS RIVERO DIEGO. Nombramientos.Apoderado: MOOS RENE MICHEL;VAN DER ARR HENDRIK JOHANNES;ECHANIZ PINO LLERKO;PEREZ MARCITLLACHPALOMA;MARTINEZ PEREZ ALEJANDRO;PEREZ RIOJA AGUSTINA;SOBRADOS RIVERO DIEGO. Datos registrales. T 31086 , F107, S 8, H M 256187, I/A 52 ( 9.04.19).

11 de Abril de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31086 , F 106, S 8, H M 256187, I/A 51 ( 4.04.19).

10 de Abril de 2018
Revocaciones. Apoderado: MOOS RENE MICHEL;VAN DER AAR HENDRIK JOHANNES;FRAGOSO LUENGO FRANCISCOJOSE;ROTELLA AGUADO ANA OLGA;VELASCO BAUTISTA JOSE LUIS;MARTINEZ GARCIA MANUEL. Nombramientos.Apo.Sol.: MOOS RENE MICHEL;VAN DER AAR HENDRIK JOHANNES. Apo.Manc.: FRAGOSO LUENGO FRANCISCOJOSE;MARTINEZ GARCIA MANUEL;ECHANIZ PINO LLERKO;SOBRADOS RIVERO DIEGO. Datos registrales. T 31086 , F 106, S8, H M 256187, I/A 50 (22.03.18).

08 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: ECHANIZ PINO LLERKO;GARCIA LOPEZ MARIA FRANCISCA. Datos registrales. T 31086 , F 105, S8, H M 256187, I/A 49 ( 1.09.17).

21 de Abril de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 12.000.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Datos registrales. T 31086 ,F 104, S 8, H M 256187, I/A 48 (14.04.16).

03 de Marzo de 2016
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31086 , F 104, S 8, H M 256187, I/A 47 (24.02.16).

01 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: MOOS RENE MICHEL;VAN DER ARR HENDRIK JOHANNES;WILLEMSE JOHANNES CORNELISMARIA;FRAGOSO LUENGO FRANCISCO JOSE;ROTELLA AGUADO ANA OLGA;VELASCO BAUTISTA JOSE LUIS;MARTINEZGARCIA MANUEL. Nombramientos. Apoderado: MOOS RENE MICHEL;VAN DER AAR HENDRIK JOHANNES;FRAGOSOLUENGO FRANCISCO JOSE;ROTELLA AGUADO ANA OLGA;VELASCO BAUTISTA JOSE LUIS;MARTINEZ GARCIA MANUEL.Cambio de domicilio social. C/ DE LA CONDESA DEL VENADITO 1 8& (MADRID). Datos registrales. T 31086 , F 103, S 8, H M256187, I/A 46 (23.02.16).

30 de Septiembre de 2014
Revocaciones. Apoderado: MOOS RENE MICHEL;WILBORTS ERIC GERARD;FRAGOSO LUENGO FRANCISCO JOSE;ROTELLAAGUADO ANA OLGA;VELASCO BAUTISTA JOSE LUIS;MARTINEZ GARCIA MANUEL. Nombramientos. Apo.Manc.: MOOS RENEMICHEL;VAN DER ARR HENDRIK JOHANNES;WILLEMSE JOHANNES CORNELIS MARIA;FRAGOSO LUENGO FRANCISCOJOSE;ROTELLA AGUADO ANA OLGA;VELASCO BAUTISTA JOSE LUIS;MARTINEZ GARCIA MANUEL. Datos registrales. T 31086, F 102, S 8, H M 256187, I/A 45 (23.09.14).

05 de Mayo de 2014
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 12潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 31086 , F102, S 8, H M 256187, I/A 44 (23.04.14).

20 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MOOS RENE MICHEL. Presidente: MOOS RENE MICHEL. Consejero: WILBORTS ERIC GERARD.Vicepresid.: WILBORTS ERIC GERARD. Consejero: VAN DER ARR HENDRIK JOHANNES. SecreNoConsj: MAIZ CARROSANTIAGO. Nombramientos. Adm. Solid.: MOOS RENE MICHEL;VAN DER AAR HENDRICK JOHANNES. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. COMOCONSECUENCIA DEL CAMBIO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION, SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 13, 21, 22 Y 23 DE LOSESTATUTOS SOCIALES, SE A脩ADEN LOS ARTICULOS 24 Y 25, Y SE MODIFICA LA NUMERACION DE LOS ARTICULOS 24, 25,26 Y 27 QUE PASAN A SER LOS ARTICULOS 26, 27, 28 Y 29, RESPECTIVAMENTE. . Datos registrales. T 31086 , F 101, S 8, H M256187, I/A 42 (12.03.14).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MOOS RENE MICHEL;VAN DER AAR HENDRICK JOHANNES. Nombramientos. Consejero:MOOS RENE MICHEL;VAN DER AAR HENDRICK JOHANNES;WILLEMSE JOHANNES CORNELIS MARIA.Presidente: MOOS RENEMICHEL. SecreNoConsj: MAIZ CARRO SANTIAGO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 31086 , F 101, S 8, H M 256187, I/A 43 (12.03.14).

23 de Enero de 2014
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: BASIC FIT INTERNATIONAL BV. Datos registrales. T 31086 , F100, S 8, H M 256187, I/A 41 (14.01.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n