Actos BORME de Basket Zaragoza 2002 Sad
23 de Septiembre de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4526 , F 186, S 8, H Z 31448, I/A 57 (19.09.22).
30 de Agosto de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4526 , F 186, S 8, H Z 31448, I/A 56 (23.08.22).
24 de Enero de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 502.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.277.596,80 Euros. Datos registrales. T 4526 , F185, S 8, H Z 31448, I/A 55 (17.01.22).
13 de Septiembre de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4526 , F 185, S 8, H Z 31448, I/A 54 ( 7.09.21).
14 de Mayo de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: FORCEN MARQUEZ JUAN. Apo.Sol.: FORCEN MARQUEZ JUAN. Apo.Man.Soli: FORCENMARQUEZ JUAN. Apo.Sol.: FORCEN MARQUEZ JUAN. Apo.Man.Soli: RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. Apoderado: GARCESANSO JESUS EMILIO. Apo.Manc.: FORCEN MARQUEZ JUAN;GARCES ANSO JESUS EMILIO;RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. Apo.Sol.: RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. Apo.Man.Soli: GASTON GARCIA JAVIER. Apo.Sol.: GASTON GARCIAJAVIER. Datos registrales. T 4009 , F 114, S 8, H Z 31448, I/A 50 ( 7.05.21).
Nombramientos. Apoderado: RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. Datos registrales. T 4009 , F 114, S 8, H Z 31448, I/A 51 (7.05.21).
Nombramientos. Apoderado: GASTON GARCIA JAVIER. Datos registrales. T 4009 , F 117, S 8, H Z 31448, I/A 52 ( 7.05.21).
Nombramientos. Apoderado: GARCES ANSO JESUS EMILIO. Datos registrales. T 4526 , F 182, S 8, H Z 31448, I/A 53 ( 7.05.21).
29 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: FORCEN MARQUEZ JUAN;MACHIN RODES ROBERTO;LALAGUNA ARANDA AGUSTIN.SecreNoConsj: FORCEN MARQUEZ JOSE LUIS. Vicepresid.: FORCEN MARQUEZ JUAN. Consejero: GARCES ANSOEMILIO;SAINZ GIL JOSE ALBERTO;FUNDACION BASKET ZARAGOZA 2002;ECHEVERRIBAR FLETA ARTEMIOFRANCISCO;RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. Presidente: RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. Nombramientos.Consejero: LALAGUNA ARANDA AGUSTIN;SAINZ GIL JOSE ALBERTO;ECHEVERRIBAR FLETA ARTEMIO FRANCISCO;GARCESANSO EMILIO;RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. SecreNoConsj: CHUECA GONZALEZ RICARDO. Datos registrales. T 4009 ,F 113, S 8, H Z 31448, I/A 49 (22.03.21).
13 de Agosto de 2020Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4009 , F 113, S 8, H Z 31448, I/A 48 ( 6.08.20).
11 de Marzo de 2020Nombramientos. Consejero: ECHEVERRIBAR FLETA ARTEMIO FRANCISCO. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n:650.851,20 Euros. Resultante Suscrito: 1.779.796,80 Euros. Datos registrales. T 4009 , F 113, S 8, H Z 31448, I/A 47 ( 4.03.20).
21 de Enero de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: SAVOVIC JOVANOVIC PREDRAG. Apo.Man.Soli: SAVOVIC JOVANOVIC PREDRAG. Nombramientos.Apo.Man.Soli: GASTON GARCIA JAVIER. Apo.Sol.: GASTON GARCIA JAVIER. Datos registrales. T 4009 , F 112, S 8, H Z 31448,I/A 46 (14.01.20).
16 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4009 , F 111, S 8, H Z 31448, I/A 45 ( 8.01.20).
15 de Enero de 2020Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4009 , F 111, S 8, H Z 31448, I/A 43 ( 8.01.20).
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4009 , F 111, S 8, H Z 31448, I/A 44 ( 8.01.20).
09 de Agosto de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. Datos registrales. T 4009 , F 110, S 8, H Z 31448, I/A 42 (2.08.19).
07 de Noviembre de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 833.448,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.430.648,00 Euros. Datos registrales. T 4009 , F 109, S 8,H Z 31448, I/A 41 (31.10.18).
28 de Febrero de 2018Reelecciones. Consejero: RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. Presidente: RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. Consejero:FORCEN MARQUEZ JUAN. Vicepresid.: FORCEN MARQUEZ JUAN. Consejero: MACHIN RODES ROBERTO;LALAGUNA ARANDAAGUSTIN;GARCES ANSO EMILIO;SAINZ GIL JOSE ALBERTO;FUNDACION BASKET ZARAGOZA 2002. SecreNoConsj: FORCENMARQUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 4009 , F 109, S 8, H Z 31448, I/A 40 (22.02.18).
15 de Diciembre de 2017Otros conceptos: Juzgado de lo Mercantil N煤mero 2 de Zaragoza, sentencia de 22 de febrero de 2016: Inhabilitar a Salvador PinedaBarrios para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier persona por un plazo de cinco a帽os. Datosregistrales. T 4009 , F 109, S 8, H Z 31448, I/A 39 (11.12.17).
21 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: AZNAR SUAREZ JESUS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAVOVIC JOVANOVIC PREDRAG.Apo.Sol.: SAVOVIC JOVANOVIC PREDRAG. Datos registrales. T 4009 , F 108, S 8, H Z 31448, I/A 38 (14.11.17).
30 de Marzo de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.042.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.597.200,00 Euros. Datos registrales. T 4009 ,F 107, S 8, H Z 31448, I/A 37 (22.03.17).
02 de Junio de 2015Modificaciones estatutarias. ARTICULO 10潞. ULTIMO PARRAFO.- No est谩n sujetas a limitaci贸n alguna las transmisiones que sehagan a favor de otro accionista, las que se realicen a favor del c贸nyuge, ascendiente o descendiente del socio enajenante, ni caso deque el enajenante sea una persona jur铆dica, las efectuadas a favor de. Datos registrales. T 4009 , F 107, S 8, H Z 31448, I/A 36(25.05.15).
08 de Mayo de 2014Modificaciones estatutarias. Art铆culo 29潞.- Para ser consejero no ser谩 necesario ser accionista. Ser谩n nombrados por la JuntaGeneral por plazo de cinco a帽os, pudiendo ser Indefinidamente reelegidos por periodos de igual duraci贸n. No podr谩n ser consejerosquienes se hallen incursos en causa legal de incapacidad o. Datos registrales. T 4009 , F 107, S 8, H Z 31448, I/A 35 (28.04.14).
04 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apoderado: ENERIZ GONZALEZ PEDRO JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: AZNAR SUAREZ JESUS.Apo.Manc.: FORCEN MARQUEZ JUAN;GARCES ANSO JESUS EMILIO;RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. Datos registrales.T 3284 , F 148, S 8, H Z 31448, I/A 34 (27.11.13).
05 de Marzo de 2013Reelecciones. Auditor: OTAL BELLIDO VICTOR MANUEL. Aud.Supl.: MIRANDA SALVADOR LUIS. Datos registrales. T 3284 , F148, S 8, H Z 31448, I/A 33 (22.02.13).
31 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FORCEN MARQUEZ JOSE LUIS. Consejero: RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO;CASAOPEREZ JAVIER;MACHIN RODES ROBERTO;PINEDA BARRIOS SALVADOR;CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DEARAGON. Presidente: RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. Consejero: FORCEN MARQUEZ JUAN;GARCES ANSO JESUSEMILIO;TERVALIS DESARROLLO SA. Vicepresid.: FORCEN MARQUEZ JUAN. Consejero: CENTRO INMOBILIARIO RYC SL.Nombramientos. Consejero: RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. Presidente: RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. Consejero:FORCEN MARQUEZ JUAN. Vicepresid.: FORCEN MARQUEZ JUAN. Consejero: MACHIN RODES ROBERTO;PINEDA BARRIOSSALVADOR;LALAGUNA ARANDA AGUSTIN;GARCES ANSO EMILIO;SAINZ GIL JOSE ALBERTO;TERVALIS DESARROLLOSA;FUNDACION BASKET ZARAGOZA 2002. SecreNoConsj: RUIZ TAPIADOR REYNALDO-BENITO. Datos registrales. T 3284 , F147, S 8, H Z 31448, I/A 32 (20.08.12).
27 de Junio de 2012Modificaciones estatutarias. Art. 21潞.- Convocatoria. 1.- La convocatoria de la Junta General se realizar谩 por cualquierprocedimiento de comunicaci贸n, individual y escrita, que asegure la recepci贸n del mismo por todos los socios en el domicilio designadoal efecto oen el que conste en la documentaci贸n de la sociedad. 2.- En A帽adir el siguiente p谩rrafo al art铆culo 31.2. de los Estatutossociales: "Los administradores que constituyan al menosun tercio de los miembros del consejo podr谩n convocarlo, indicando el ordendel d铆a, para su celebraci贸n en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petici贸n al. Datos registrales. T 3284 , F 147,S 8, H Z 31448, I/A 31 (15.06.12).
20 de Marzo de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 640.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.640.000,00 Euros. Datos registrales. T 3284 , F 147, S 8,H Z 31448, I/A 30 ( 8.03.12).
16 de Enero de 2012Reelecciones. Aud.Supl.: MIRANDA SALVADOR LUIS. Auditor: OTAL BELLIDO VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 3284 , F147, S 8, H Z 31448, I/A 29 ( 3.01.12).
20 de Diciembre de 2011Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 147.000,00 Euros. Datos registrales. T 3284 , F 147, S 8, H Z 31448, I/A 28 (7.12.11).
03 de Diciembre de 2009Nombramientos. Consejero: CENTRO INMOBILIARIO RYC SL. Datos registrales. T 3284 , F 147, S 8, H Z 31448, I/A 27(24.11.09).
12 de Agosto de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA CHAPULI ALBERTO. Apo.Sol.: GARCIA CHAPULI ALBERTO. Datos registrales. T 3284 , F146, S 8, H Z 31448, I/A 25 ( 3.08.09).
Nombramientos. Apoderado: GARCES ANSO JESUS EMILIO;ENERIZ GONZALEZ PEDRO JOSE. Datos registrales. T 3284 , F146, S 8, H Z 31448, I/A 26 ( 3.08.09).