Buscador CIF Logo

Actos BORME Bcn Farma Distribucion Y Almacenaje De Medicamentos Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Bcn Farma Distribucion Y Almacenaje De Medicamentos Sl

Actos BORME Bcn Farma Distribucion Y Almacenaje De Medicamentos Sl - B61829370

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Bcn Farma Distribucion Y Almacenaje De Medicamentos Sl con CIF B61829370

馃敊 Perfil de Bcn Farma Distribucion Y Almacenaje De Medicamentos Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Bcn Farma Distribucion Y Almacenaje De Medicamentos Sl

20 de Febrero de 2023
Cambio de denominaci贸n social. EUROMED PHARMA SPAIN S.L. Datos registrales. T 38961 , F 81, S 8, H B 193374, I/A 38

11 de Junio de 2021
Nombramientos. APODERAD.SOL: ROIG MOLINA NURIA. Datos registrales. T 38961 , F 81, S 8, H B 193374, I/A 37 ( 4.06.21).

29 de Enero de 2021
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SL. Datos registrales. T 38961 , F 81, S 8, H B193374, I/A 36 (20.01.21).

09 de Junio de 2020
Revocaciones. CONS. DELEG.: ROIG MOLINA NURIA. APODERADO: RAFFAELLE PETRONE;ROIG MOLINA NURIA;GIUSEPPESANTORIO. APODERAD.SOL: VILLARROYA PEREZ JAVIER. Nombramientos. CONS.DEL.M/S: ROIG MOLINA NURIA. Datosregistrales. T 38961 , F 79, S 8, H B 193374, I/A 35 (29.05.20).

13 de Noviembre de 2019
Revocaciones. APOD.MANCOMU: ROIG MOLINA ALEJANDRO;ESPEJO PADILLA ESTER;CASTELLA ESPUNY MARIAYOLANDA;GAMEZ VILLAFUERTE NURIA. Datos registrales. T 38961 , F 79, S 8, H B 193374, I/A 34 ( 6.11.19).

11 de Noviembre de 2019
Nombramientos. APOD.MANCOMU: ROIG MOLINA NURIA;VILLARROYA PEREZ JAVIER;VITORIO CIRUCCI;GIUSEPPESANTORIO;PAOLO ESPOSITO;RAFFAELLE PETRONE. Datos registrales. T 38961 , F 79, S 8, H B 193374, I/A 33 (29.10.19).

24 de Junio de 2019
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: VILLARROYA PEREZ JAVIER;VITORIO CIRUCCI;GIUSEPPE SANTORIO;PAOLOESPOSITO;RAFFAELLE PETRONE. Datos registrales. T 38961 , F 78, S 8, H B 193374, I/A 32 (17.06.19).

17 de Agosto de 2018
Nombramientos. APODERAD.SOL: VILLARROYA PEREZ JAVIER. Datos registrales. T 38961 , F 77, S 8, H B 193374, I/A 31 (7.08.18).

16 de Mayo de 2018
Revocaciones. APODERADO: GUMA TEIXIDO JOAN. Datos registrales. T 38961 , F 77, S 8, H B 193374, I/A 30 ( 4.05.18).

03 de Mayo de 2018
Revocaciones. CONSEJERO: GUMA TEIXIDO JOAN. SECRETARIO: GUMA TEIXIDO JOAN. Nombramientos. CONSEJERO:VILLARROYA PEREZ JAVIER. SECRETARIO: VILLARROYA PEREZ JAVIER. Modificaciones estatutarias. ART.20.- SISTEMARETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 38961 , F 76, S 8, H B 193374, I/A 29 (23.04.18).

10 de Abril de 2018
Revocaciones. APODERADO: BUXEDA TOMAS EDUARDO. Datos registrales. T 38961 , F 76, S 8, H B 193374, I/A 28 ( 3.04.18).

11 de Diciembre de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SL. Datos registrales. T 38961 , F 76, S 8, H B193374, I/A 27 (29.11.17).

19 de Mayo de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SL. Datos registrales. T 38961 , F 76, S 8, H B193374, I/A 26 (10.05.16).

31 de Julio de 2013
Nombramientos. APOD.MANCOMU: ROIG MOLINA ALEJANDRO;ESPEJO PADILLA ESTER;CASTELLA ESPUNY MARIAYOLANDA;GAMEZ VILLAFUERTE NURIA. Datos registrales. T 38961 , F 76, S 8, H B 193374, I/A 25 (23.07.13).

06 de Marzo de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SL. Datos registrales. T 38961 , F 75, S 8, H B193374, I/A 24 (24.02.12).

14 de Julio de 2011
Nombramientos. APODERADO: GIUSEPPE SANTORIO. Datos registrales. T 38961 , F 75, S 8, H B 193374, I/A 23 (30.06.11).

29 de Octubre de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DESPATX D'AUDITORIA MARTINEZ RIBAS SL. Datos registrales. T 38961 , F 75, S 8, H B193374, I/A 22 (19.10.10).

26 de Abril de 2010
Revocaciones. APODERADO: GUMA TEIXIDO JOAN;RAFFAELLE PETRONE. Nombramientos. APODERADO: RAFFAELLEPETRONE;ROIG MOLINA NURIA;GUMA TEIXIDO JOAN. Datos registrales. T 38961 , F 73, S 8, H B 193374, I/A 21 (13.04.10).

30 de Diciembre de 2009
Cambio de domicilio social. CL EDUARD MARISTANY, NUM.430-432, NAVE 18 (BADALONA). Datos registrales. T 38961 , F 73,S 8, H B 193374, I/A 20 (17.12.09).

10 de Febrero de 2009
Otros conceptos: CAMBIO DE SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD.NUEVO SOCIO:"CARPEFIN BV". Datos registrales. T 38961 , F73, S 8, H B 193374, I/A 19 (28.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n