Actos BORME de Bcn Lluria Sl
27 de Diciembre de 2023Revocaciones. ADM.CONJUNTO: CABRERA PLANA JUDITH;CABRERA PLANA ROBERT. Nombramientos. CONSEJERO:CABRERA PLANA JUDITH. VICESECRET.: CABRERA PLANA JUDITH. APOD.MANCOMU: CABRERA PLANA JUDITH.CONSEJERO: CABRERA PLANA ROBERT. SECRETARIO: CABRERA PLANA ROBERT. APOD.MANCOMU: CABRERA PLANAROBERT. CONSEJERO: CABRERA PLANA ETHEL. PRESIDENTE: CABRERA PLANA ETHEL. APOD.MANCOMU: CABRERAPLANA ETHEL. Datos registrales. T 44067 , F 38, S 8, H B 446248, I/A 14 (14.12.23).
15 de Octubre de 2021Revocaciones. APOD.SOL/MAN: RODRIGUEZ MONTES MARIA DEL PILAR. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: AGUILERAGONZALEZ LORENA. Datos registrales. T 44067 , F 37, S 8, H B 446248, I/A 13 ( 6.10.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. APODERAD.SOL: SANCHO CLAVE RAMON. Datos registrales. T 44067 , F 37, S 8, H B 446248, I/A 12(28.05.21).
29 de Marzo de 2021Revocaciones. ADM.UNICO: CABRERA BLANCH JOSE. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: CABRERA PLANAJUDITH;CABRERA PLANA ROBERT. Datos registrales. T 44067 , F 37, S 8, H B 446248, I/A 11 (17.03.21).
27 de Enero de 2021Revocaciones. AUDIT.CUENT.: DINAMIC AUDITORS SAP. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: SERRAT AUDITORS SL. Datosregistrales. T 44067 , F 36, S 8, H B 446248, I/A 10 (19.01.21).
05 de Diciembre de 2017Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DINAMIC AUDITORS SAP. Datos registrales. T 44067 , F 36, S 8, H B 446248, I/A 9 (28.11.17).
11 de Agosto de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.753.000,00 Euros. Modificacionesestatutarias. articulo 7.- en relacion a la division de participaciones sociales. Datos registrales. T 44067 , F 36, S 8, H B 446248, I/A8 ( 3.08.16).
01 de Junio de 2016Nombramientos. APOD.SOL/MAN: HERNANDEZ ZAYAS SANTIAGO;RODRIGUEZ MONTES MARIA DEL PILAR;MAYOLASSANCHEZ JAIRO;FERRER CABRE JOAQUIM. Datos registrales. T 44067 , F 35, S 8, H B 446248, I/A 7 (25.05.16).
16 de Febrero de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.753.000,00 Euros. Datos registrales. T 44067 , F 35, S8, H B 446248, I/A 6 ( 6.02.15).
08 de Julio de 2014Nombramientos. APOD.MANCOMU: CABRERA PLANA JUDITH;POY CIURANA CARLES;CABRERA PLANA ROBERT;CABRERAPLANA ETHEL Datos registrales. T 44067 , F 34, S 8, H B 446248, I/A 5 ( 1.07.14).
11 de Abril de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 16.253.000,00 Euros. Datos registrales. T 44067 , F 34, S 8,H B 446248, I/A 4 ( 3.04.14).
27 de Febrero de 2014Nombramientos. APODERAD.SOL: POY CIURANA CARLES;CABRERA PLANA ROBERT. Datos registrales. T 44067 , F 33, S 8,H B 446248, I/A 3 (19.02.14).
13 de Febrero de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 15.750.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 15.753.000,00 Euros. Datos registrales. T 44067 , F 33,S 8, H B 446248, I/A 2 ( 5.02.14).
10 de Enero de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 5.12.13. Objeto social: LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE TODO TIPO DEINSTALACIONES HOTELERAS Y NEGOCIOS TURISTICOS.LA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS RELACIONADOS CON LAALIMETACION.LA EXPLOTACION DE LAVANDERIAS,ETC. Domicilio: AV DIAGONAL Num.3 (BARCELONA). Capital: 3.000,00Euros. Nombramientos. ADM.UNICO: CABRERA BLANCH JOSE. Datos registrales. T 44067 , F 31, S 8, H B 446248, I/A 1(31.12.13).