Buscador CIF Logo

Actos BORME Bdp International Spain Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Bdp International Spain Sa

Actos BORME Bdp International Spain Sa - A79894051

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Bdp International Spain Sa con CIF A79894051

馃敊 Perfil de Bdp International Spain Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Bdp International Spain Sa

08 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apoderado: POZA CREMER GUILLERMO;POZA CREMER GUILLERMO. Datos registrales. T 41252 , F 216, S 8,H M 11393, I/A 57 ( 1.03.23).

25 de Febrero de 2022
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 41252 , F 215, S 8, H M 11393, I/A 56 (18.02.22).

13 de Enero de 2022
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: BDP GLOBAL SERVICES B.V. Datos registrales. T 41252 , F 215,S 8, H M 11393, I/A 55 ( 6.01.22).

06 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: BRAGADO BELLO ANGEL MANUEL. Datos registrales. T 32927 , F 225, S 8, H M 11393, I/A 54(28.04.21).

27 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ CABELLO CARLOS. Datos registrales. T 32927 , F 224, S 8, H M 11393, I/A 52(20.11.20).

Nombramientos. Apoderado: REY MOYA JORONIMO ANTONIO. Datos registrales. T 32927 , F 224, S 8, H M 11393, I/A 53(20.11.20).

16 de Abril de 2020
Revocaciones. Apoderado: MOLINA SECO IGNACIO MARIA. Apo.Sol.: MOLINA SECO IGNACIO MARIA. Nombramientos.Apoderado: REY MOYA JORONIMO ANTONIO;REY MOYA JORONIMO ANTONIO. Datos registrales. T 32927 , F 223, S 8, H M11393, I/A 51 ( 7.04.20).

20 de Diciembre de 2019
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: EUROPEAN DISTRIBUTION XXI SL. Datos registrales. T 32927 , F 222, S 8, H M11393, I/A 50 (13.12.19).

21 de Mayo de 2019
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: BDP EUROPE SARL. Datos registrales. T 32927 , F 221, S 8, H M11393, I/A 49 (13.05.19).

14 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: ALEGRIA GARCIA JORGE. Apoderado: GONZALVEZ MARIN MIRIAM. Apo.Sol.: GONZALVEZ MARINMIRIAM. Datos registrales. T 32927 , F 221, S 8, H M 11393, I/A 48 ( 7.05.19).

07 de Mayo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: LIGEON KLANN HELEN BELINDA. Datos registrales. T 32927 , F 221, S 8, H M 11393, I/A 46(26.04.19).

Revocaciones. Apoderado: LIGEON KLANN HELEN BELINDA. Datos registrales. T 32927 , F 221, S 8, H M 11393, I/A 47(26.04.19).

06 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apoderado: ROLDAN GONZALEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ VIGIL DE QUI脩ONESBLANCA. Apo.Sol.: MOLINA SECO IGNACIO MARIA;GONZALVEZ MARIN MIRIAM. Datos registrales. T 32927 , F 220, S 8, H M11393, I/A 45 (25.04.19).

14 de Marzo de 2019
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 32927 , F 219, S 8, H M 11393, I/A 44 ( 7.03.19).

12 de Marzo de 2019
Reelecciones. Consejero: MARTINEZ VIGIL DE QUI脩ONES JOSE. Secretario: MARTINEZ VIGIL DE QUI脩ONES JOSE. Consejero:LETANGE YVES;VICTOR HOLMSTOCK DIRK MARIA;LIGEON KLANN HELEN BELINDA. Presidente: LETANGE YVES. Datosregistrales. T 32927 , F 219, S 8, H M 11393, I/A 43 ( 5.03.19).

13 de Julio de 2018
Nombramientos. Apoderado: MOLINA SECO IGNACIO;GONZALVEZ MARIN MIRIAN. Datos registrales. T 32927 , F 218, S 8, H M11393, I/A 42 ( 5.07.18).

14 de Junio de 2016
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CABELLO CARLOS. Datos registrales. T 32927 , F 217, S 8, H M 11393, I/A 41 (6.06.16).

21 de Enero de 2016
Nombramientos. Auditor: MORISON AC SLP. Datos registrales. T 32927 , F 217, S 8, H M 11393, I/A 40 (12.01.16).

04 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: DE BOE STEPHAN;SIMPSON KARYN. Apoderado: ROLDAN GONZALEZ JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 32927 , F 216, S 8, H M 11393, I/A 39 (25.11.15).

07 de Agosto de 2015
Revocaciones. Apoderado: OSUSKY FRANK;HOLMSTOCK DIRK;MULDOON CATHERINE;BOLTE JOHN. Nombramientos.Apoderado: LETANGE YVES;HOLMSTOCK DIRK;KLANN EV LIGEON HELEN BELINDA. Datos registrales. T 32927 , F 215, S 8, HM 11393, I/A 38 (30.07.15).

30 de Enero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: BOLTE JOHN;OSUSKY FRANK. Presidente: BOLTE JOHN. Nombramientos. Consejero: VICTORHOLMSTOCK DIRK MARIA;KLANN EV LIGEON HELEN BELINDA. Presidente: LETANGE YVES. Datos registrales. T 19073 , F 23,S 8, H M 11393, I/A 37 (22.01.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n