Actos BORME de Bdr Thermea Iberia Sl
16 de Noviembre de 2023Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscripci贸n 11陋 el nombramiento com oAdministrador 煤nico de SANCHEZ SOLE SERGIO,siendo lo correcto BLANCH VALLHONRAT JUAN. Datos registrales. T 37102 , F 24, S 8, H M 662232, I/A 11 ( 1.08.23).
15 de Marzo de 2023Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: BDR THERMEA GROUP B.V. Datos registrales. T 37102 , F 23, S8, H M 662232, I/A 10 ( 8.03.23).
11 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: MATA LABAJOS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 37102 , F 23, S 8, H M 662232, I/A 9 ( 4.10.22).
19 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ TORRES ESTHER. Apo.Manc.: SANCHEZ TORRES ESTHER;MESTRES SOLAJORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN. Datos registrales. T 37102 , F 22, S 8, H M 662232, I/A 8 (12.09.22).
04 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: BLANCH VALLHONRAT JUAN;VAN OOIJEN JAN ROELF;MESTRES SOLA JORGE. Presidente:VAN OOIJEN JAN ROELF. SecreNoConsj: SANCHEZ SOLE SERGIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: MESTRES SOLAJORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministradores mancomunados. Datos registrales. T 37102 , F 21, S 8, H M 662232, I/A 6 (28.05.21).
Revocaciones. Apoderado: VAN OOIJEN JAN ROELF. Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ SOLE SERGIO;ARTIGAS GRAUELENA. Datos registrales. T 37102 , F 21, S 8, H M 662232, I/A 7 (28.05.21).
21 de Junio de 2019Revocaciones. Apoderado: BASILE SALVATORE. Datos registrales. T 37102 , F 20, S 8, H M 662232, I/A 5 (14.06.19).
17 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Secretario: SUBIRANA ORTIN FRANCESC. Nombramientos. SecreNoConsj: SANCHEZ SOLE SERGIO.Datos registrales. T 37102 , F 20, S 8, H M 662232, I/A 3 ( 9.08.18).
Revocaciones. Apoderado: SUBIRANA ORTIN FRANCESC. Datos registrales. T 37102 , F 20, S 8, H M 662232, I/A 4 ( 9.08.18).
29 de Enero de 2018Cambio de domicilio social. C/ LOPEZ DE HOYOS 35 - BAJOS (MADRID). Datos registrales. T 37102 , F 19, S 8, H M 662232, I/A2 (22.01.18).
03 de Febrero de 2015Revocaciones. APODERADO: PI JULIA LUIS;ADRIAN EGERTON DARLING;PI JULIA LUIS. Nombramientos. APOD.MANCOMU:JAN ROELF VAN OOIJEN. Datos registrales. T 37789 , F 170, S 8, H B 277634, I/A 19 (27.01.15).
15 de Enero de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: NAVARRO MARTINEZ AVIAL GONZALO;PAZOS RODRIGUEZ ROMAN;CASTILLO NIETOELISA;SEGURA FAYOS VICENTE JAVIER. Datos registrales. T 37789 , F 170, S 8, H B 277634, I/A 18 ( 5.01.15).
06 de Marzo de 2013Revocaciones. CONSEJERO: JOHN TIERNEY. Nombramientos. CONSEJERO: BLANCH VALLHONRAT JUAN. Datosregistrales. T 37789 , F 170, S 8, H B 277634, I/A 17 (27.02.13).
27 de Julio de 2012Revocaciones. CONSEJERO: ADRIAN EGERTON DARLING. PRESIDENTE: ADRIAN EGERTON DARLING. Nombramientos.CONSEJERO: MESTRES SOLA JORGE. PRESIDENTE: JAN ROELF VAN OOIJEN. Datos registrales. T 37789 , F 169, S 8, H B277634, I/A 16 (16.07.12).
14 de Marzo de 2012Nombramientos. APODERADO: MESTRES SOLA JORGE. Datos registrales. T 37789 , F 166, S 8, H B 277634, I/A 15 ( 2.03.12).
13 de Febrero de 2012Revocaciones. CONSEJERO: MARTYN COFFEY. Nombramientos. CONSEJERO: JAN ROELF VAN OOIJEN. Datos registrales.T 37789 , F 166, S 8, H B 277634, I/A 14 ( 1.02.12).