Actos BORME de Bebolution Sl
19 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. LiquiSoli: SEMPERE GARCIA CAYO;SEMPERE FERRI GERMAN. Consejero: SEMPERE FERRIGERMAN;SEMPERE GARCIA CAYO;SEMPERE GUTIERREZ FERRAN;SEMPERE FRANCES JORGE;VERDU FRANCES JOSE.Presidente: SEMPERE FERRI GERMAN. Secretario: SEMPERE GARCIA CAYO. Vicepresid.: SEMPERE GUTIERREZ FERRAN.Cons.Del.Sol: SEMPERE FERRI GERMAN;VERDU FRANCES JOSE. Nombramientos. LiquiSoli: SEMPERE FERRIGERMAN;SEMPERE GARCIA CAYO. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 3146 , F 21, S 8, H A 104266, I/A 8(11.01.16).
24 de Abril de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: VERDU FRANCES JOSE;FERRI LLORENS JOSE JOAQUIN. Datos registrales. T 3146 , F 21, S 8, H A104266, I/A 7 (14.04.14).
08 de Enero de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SEMPERE FERRI GERMAN. Nombramientos. Consejero: SEMPERE FERRIGERMAN;SEMPERE GARCIA CAYO;SEMPERE GUTIERREZ FERRAN;SEMPERE FRANCES JORGE;VERDU FRANCES JOSE.Presidente: SEMPERE FERRI GERMAN. Secretario: SEMPERE GARCIA CAYO. Vicepresid.: SEMPERE GUTIERREZ FERRAN.Cons.Del.Sol: SEMPERE FERRI GERMAN;VERDU FRANCES JOSE. Modificaciones estatutarias. Artículo 13º. Retribución delcargo.. Artículo 19º. Presidente honorífico.. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración.Datos registrales. T 3146 , F 21, S 8, H A 104266, I/A 6 (30.12.13).
27 de Septiembre de 2010Cambio de domicilio social. AVDA 1º DE MAYO, S/N - POLIGONO INDUSTRIAL LA MARJ (ONIL). Datos registrales. T 3146 , F20, S 8, H A 104266, I/A 5 (15.09.10).
03 de Agosto de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ ORTS FRANCISCO ANTONIO. Datos registrales. T 3146 , F 20, S 8, H A 104266, I/A 4(22.07.10).